NOBLEREVEL LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | NOBLEREVEL LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02743181 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von NOBLEREVEL LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich NOBLEREVEL LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NOBLEREVEL LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für NOBLEREVEL LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Francis Declan Finbar Tempany Mccormack als Sekretär am 09. Okt. 2012 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Mitteilung über den Abschluss des freiwilligen Vergleichs | 6 Seiten | 1.4 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Timothy James Bolot als Geschäftsführer am 17. Aug. 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Mitteilung an den Unternehmensregister über den Inkrafttreten des freiwilligen Vergleichs | 4 Seiten | 1.1 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Jan. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von William James Buchan als Geschäftsführer am 15. Nov. 2011 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Andrew Smith als Geschäftsführer am 01. Nov. 2011 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Stephen Jonathan Taylor als Direktor am 26. Okt. 2011 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Timothy James Bolot als Direktor am 26. Okt. 2011 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2010 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | MG01 | ||||||||||
Ernennung von Francis Declan Finbar Tempany Mccormack als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von William Mcleish als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Jan. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Midmer als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 15. Jan. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 27. Sept. 2009 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr David Andrew Smith am 07. Jan. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Ernennung von Mr David Andrew Smith als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Smith als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr David Andrew Smith als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von NOBLEREVEL LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAYLOR, Stephen Jonathan | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 163496070001 | |||||
| COPELAND, Robert Nigel | Sekretär | Cherry Tree Cottage Hearns Lane Gallows Tree Common RG4 9DE Reading Berkshire | British | 5690880001 | ||||||
| FEENEY, Martin | Sekretär | 13 Avonhead Avenue Condorrat Cumbernauld G67 4RB Glasgow Scotland | British | 53915080001 | ||||||
| FORD, Colin Andrew | Sekretär | 12 Willow Drive Milton Of Campsie G66 8DY Glasgow Lanarkshire | British | 70144650001 | ||||||
| HURRELL, Steven Alfred | Sekretär | 8 Hamilton Crescent Bearsden G61 3JP Glasgow Strathclyde | British | 82311390001 | ||||||
| KIME, Sean Thomas | Sekretär | Flat 1 3 Nevern Place SW5 9NR London | British | 89002440002 | ||||||
| MACFARLANE, Rona Jane | Sekretär | 2/2 5 Doune Quadrant G20 6DL Glasgow | British | 62509960001 | ||||||
| MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany | Sekretär | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | 158305360001 | |||||||
| MCLEISH, William David | Sekretär | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | British | 168970640001 | ||||||
| MURPHY, Charles Furber | Sekretär | 8 Tidwells Lea Warfield RG42 3TP Bracknell Berkshire | British | 69603410001 | ||||||
| MURRAY, Karen Mary | Sekretär | Willerton Trumpsgreen Road GU25 4HH Virginia Water Surrey | British | 27248850001 | ||||||
| RUTTER, Christopher | Sekretär | 15 The Dell DL14 7HJ Bishop Auckland County Durham | British | 103588940001 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| ABLETT, Julie | Geschäftsführer | 166 Rutland Road West Bridgford NG2 5DZ Nottingham | British | 57906600001 | ||||||
| BARLOW, George Edward | Geschäftsführer | 41 Nidd Approach LS22 7UJ Wetherby West Yorkshire | England | British | 66559170001 | |||||
| BOLOT, Timothy James | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 107837080002 | |||||
| BRADEEN, Chester Howard | Geschäftsführer | Barberry Cottage Cheapside Road SL5 7QR Ascot Berkshire | Us Citizen | 44958580001 | ||||||
| BUCHAN, William James | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | England | British | 79917240001 | |||||
| COLVIN, William | Geschäftsführer | Senang Pyrford Woods Road GU22 8QR West Byfleet Surrey | United Kingdom | British | 51697890003 | |||||
| COPELAND, Robert Nigel | Geschäftsführer | Cherry Tree Cottage Hearns Lane Gallows Tree Common RG4 9DE Reading Berkshire | United Kingdom | British | 5690880001 | |||||
| FARRALL, Elaine Ann | Geschäftsführer | Manton Lodge Clumber Park S80 3AX Worksop Nottinghamshire | British | 14241020001 | ||||||
| FEENEY, Martin | Geschäftsführer | 13 Avonhead Avenue Condorrat Cumbernauld G67 4RB Glasgow Scotland | Scotland | British | 53915080001 | |||||
| FLAHERTY, James Paul | Geschäftsführer | Flat 18 Montagu Court 27-29 Montagu Square W1H 2LG London | American | 100530310001 | ||||||
| FOULKES, Kamma | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 111188390002 | |||||
| GOSLING, Mark David | Geschäftsführer | Fosse Beck Bewerley HG3 5HX Harrogate | British | 66801660002 | ||||||
| HAMILTON, Thomas Banks | Geschäftsführer | 29 Montrose Avenue G52 4LA Hillington Park Glasgow | British | 79846610001 | ||||||
| JAP, Chee Miau | Geschäftsführer | 8 Thurloe Street SW7 2ST London | United Kingdom | Singaporean | 101200680001 | |||||
| LAWRENCE, Stephen John | Geschäftsführer | The Old Barn Littleton SO22 6QS Winchester Hants | England | British | 5579020001 | |||||
| LOCK, Jason David | Geschäftsführer | 32 Monkton Rise TS14 6BG Guisborough Chessington House | England | British | 144822040001 | |||||
| MARK, Larry Edward | Geschäftsführer | 29 Cedar Drive SL5 0UA Sunningdale Berkshire | New Zealander | 5076900001 | ||||||
| MCINTEER, Warren Hill | Geschäftsführer | 11 Thorn Road Bearsden G61 4PP Glasgow Lanarkshire | Scotland | British | 100131200001 | |||||
| MIDMER, Richard Neil | Geschäftsführer | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | England | British | 110640170001 | |||||
| MORETON, John Ernest | Geschäftsführer | The Old Farm Winkfield Row RG12 6NG Reading Berkshire | New Zealander | 80392940001 | ||||||
| MOSS, John Rhys | Geschäftsführer | Bryn Y Gwynt Graigfechan LL15 2EY Ruthin Clwyd | British | 36148600001 | ||||||
| MURPHY, Charles Furber | Geschäftsführer | 8 Tidwells Lea Warfield RG42 3TP Bracknell Berkshire | British | 69603410001 |
Hat NOBLEREVEL LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Supplemental legal mortgage | Erstellt am 06. Mai 2011 Geliefert am 20. Mai 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Land on the north side of bury new road heywood t/no GM608227 see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of accession and charge | Erstellt am 21. Aug. 2008 Geliefert am 02. Sept. 2008 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 26. Mai 2000 Geliefert am 15. Juni 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or owing by the UK guarantor to the ("chargees") or any ofthem under or in connection with guaranty agreement on any account whatsoever (as defined therein) and all liabilities whether actual or contingent at any time incurred by the company to the chargees under the amended and restated participation agreement (as defined therein) and/or any deed or document executed by the company pursuant thereto | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture deed | Erstellt am 10. Feb. 1997 Geliefert am 12. Feb. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage deed | Erstellt am 17. Dez. 1996 Geliefert am 19. Dez. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold property known as bullace row camberwell southwark london; sgl 502718; all fixtures/fittings,fixed plant,machinery,book/other debts,licences,goodwill of business and all guarantees or covenants; see form 395. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage deed | Erstellt am 17. Dez. 1996 Geliefert am 19. Dez. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold property known as 10 brook rd,south benfleet castle point essex with all buildings,fixtures/fittings,plant and machinery thereon; ex 85951; all book/other debts,licences,goodwill of business and all guarantees or covenants; see form 395. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 01. Aug. 1995 Geliefert am 04. Aug. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/as wellgate nursing home, wellgate, rotherham, S. yorkshire t/nos SYK316915 and SYK344344 the goodwill of the business the benefit of all guarantees and covenants. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Single debenture | Erstellt am 22. Feb. 1994 Geliefert am 28. Feb. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattel mortgage | Erstellt am 28. Mai 1993 Geliefert am 10. Juni 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The loose fittings and furnishings at garden lodge nursing home middlemass hey netherley merseyside. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattel mortgage | Erstellt am 28. Mai 1993 Geliefert am 10. Juni 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The loose fittings and furniture at maple lodge nursing home arncliffe road halewood liverpool. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. Mai 1993 Geliefert am 10. Juni 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H maple lodge nursing home arncliffe road liverpool merseyside and gardenlodge nursing home and land adjoining at middlemass hey netherley merseyside and land adjoining maple lodge nursing home aforesaid. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat NOBLEREVEL LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Freiwillige Unternehmenssanierung (CVA) |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0