ENERGY DATA SERVICES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ENERGY DATA SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02744645 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ENERGY DATA SERVICES LIMITED?
- Tätigkeit von Nachrichtenagenturen (63910) / Information und Kommunikation
Wo befindet sich ENERGY DATA SERVICES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 Broadgate EC2M 2QS London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ENERGY DATA SERVICES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ENERGY DATA SERVICES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Aug. 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
legacy | 9 Seiten | RP04CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Peter Low als Geschäftsführer am 27. Jan. 2017 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Roger Haworth als Geschäftsführer am 14. Apr. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Giles Harvey Roberts Richardson als Direktor am 16. Juni 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kier Murray Fawcus als Geschäftsführer am 27. Jan. 2017 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Aug. 2016 mit Aktualisierungen | 7 Seiten | CS01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Sept. 2016 bis 31. Dez. 2016 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2015 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2014 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Aug. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Erfüllung der Belastung 1 vollständig | 5 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt | 1 Seiten | DISS40 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Aug. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stephen Lacey als Geschäftsführer am 06. Juni 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stephen Lacey als Sekretär am 06. Juni 2014 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stephen Lacey als Geschäftsführer am 06. Juni 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stephen Lacey als Sekretär am 06. Juni 2014 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Mr John Roger Haworth als Direktor am 12. Jan. 2015 | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ENERGY DATA SERVICES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPP GROUP (NOMINEES) LIMITED | Sekretär | Farm Street W1J 5RJ London 27 England |
| 80143770001 | ||||||||||
| RICHARDSON, Giles Harvey Roberts | Geschäftsführer | Broadgate EC2M 2QS London 1 | England | British | 224284590001 | |||||||||
| BANNER, Christopher | Sekretär | 86 Lexington Apartments 40 City Road EC1Y 2AN London | British | 76044030002 | ||||||||||
| COGAN, Michael | Sekretär | 15 Jackson Road N7 6ES London | British | 31528660001 | ||||||||||
| CROMACK, Andrew Michael | Sekretär | 23 Knole Road ME5 8PJ Chatham Kent | British | 78040930001 | ||||||||||
| GULLIVER, John Keith | Sekretär | The Registry Royal Mint Court EC3N 4QN London | British | 147777590001 | ||||||||||
| LACEY, Stephen | Sekretär | Broadgate EC2M 2QS London 1 England | 164064150001 | |||||||||||
| LOW, Peter | Sekretär | The Registry Royal Mint Court EC3N 4QN London | 148715850001 | |||||||||||
| LOW, Peter | Sekretär | 10 Union Square Islington N1 7DH London | British | 65476890001 | ||||||||||
| STANNETT, Robert William | Sekretär | Shalford GU4 8JN Guildford Northfield Surrey | British | 141063520001 | ||||||||||
| THOMSON, Alastair Iain Lindsay | Sekretär | 30 Roehampton Close SW15 5LU London | British | 60638430002 | ||||||||||
| AA COMPANY SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | First Floor Offices 8-10 Stamford Hill N16 6XZ London | 900002630001 | |||||||||||
| BANNER, Christopher | Geschäftsführer | 86 Lexington Apartments 40 City Road EC1Y 2AN London | British | 76044030002 | ||||||||||
| COGAN, Michael | Geschäftsführer | 15 Jackson Road N7 6ES London | British | 31528660001 | ||||||||||
| DOLTON, Stephen | Geschäftsführer | 99 Cumnor Hill OX2 9JR Oxford | British | 70990450005 | ||||||||||
| FAWCUS, Kier Murray | Geschäftsführer | Broadgate EC2M 2QS London 1 England | England | British | 84594470002 | |||||||||
| GILBERT, Clifford Roderick | Geschäftsführer | 74 Median Road E5 0PN London | British | 31528640001 | ||||||||||
| GULLIVER, John Keith | Geschäftsführer | The Registry Royal Mint Court EC3N 4QN London | United Kingdom | British | 147777590001 | |||||||||
| HARKNESS, Peter Martin | Geschäftsführer | 19 Horsley Court Montaigne Close Regency Street SW1 4BF London | United Kingdom | British | 146757430001 | |||||||||
| HAWORTH, John Roger | Geschäftsführer | Broadgate EC2M 2QS London 1 England | England | British | 91354480002 | |||||||||
| HILLIARD, Charles Stephen | Geschäftsführer | 18 Albion Works Studios 63 Sigdon Road E8 1AW London | British | 104848990001 | ||||||||||
| JONES, Roberta | Geschäftsführer | 26 Canonbury Street N1 2TD London | British | 31528650002 | ||||||||||
| KNIGHT, Martin | Geschäftsführer | The Cuttings 57 Cheam Road East Ewell KT17 3EB Epsom Surrey | England | British | 13326400003 | |||||||||
| LACEY, Stephen | Geschäftsführer | Broadgate EC2M 2QS London 1 England | England | British | 88368490002 | |||||||||
| LOW, Peter | Geschäftsführer | Broadgate EC2M 2QS London 1 England | England | British | 65476890002 | |||||||||
| MAJITHIA, Viren Laxmidas | Geschäftsführer | 8 Orford Road Walthamstow E17 9LN London | British | 45026990003 | ||||||||||
| MAJITHIA, Viren Laxmidas | Geschäftsführer | 26 Burgh Street N1 8HG London | British | 45026990002 | ||||||||||
| SEYMOUR, Steven David | Geschäftsführer | 10c Walford Road N16 8ED London | British | 74953460001 | ||||||||||
| SEYMOUR, Steven David | Geschäftsführer | 10c Walford Road N16 8ED London | British | 74953460001 | ||||||||||
| SHEPHERD, Jonathan Paul | Geschäftsführer | 7 Hatton Close Chafford Hundred RM16 6RP Grays Essex | United Kingdom | British | 104848170001 | |||||||||
| STANNETT, Robert William | Geschäftsführer | Shalford GU4 8JN Guildford Northfield Surrey | England | British | 141063520001 | |||||||||
| TYLER, Christopher | Geschäftsführer | 5 Aveling Park Road E17 4NU London | British | 76771030002 | ||||||||||
| TYLER, Christopher John | Geschäftsführer | 12a Saratoga Road E5 0SJ London | British | 76771030001 | ||||||||||
| BUYVIEW LTD | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 1st Floor Offices 8-10 Stamford Hill N16 6XZ London | 900002620001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ENERGY DATA SERVICES LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Knight-Banner Information Limited | 06. Apr. 2016 | Broadgate EC2M 2QS London 1 | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Precise Media Group Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | Broadgate EC2M 2QS London 1 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat ENERGY DATA SERVICES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 15. Dez. 2006 Geliefert am 20. Dez. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 01. Apr. 2005 Geliefert am 20. Apr. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 01. Apr. 2005 Geliefert am 15. Apr. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future indebtedness liabilities and obligations due or to become due from any chargor or other member of the group to the chargee (the "security trustee") as agent and trustee for itself and each of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| An omnibus guarantee and set-off agreement | Erstellt am 02. Juli 2003 Geliefert am 05. Juli 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| All assets debenture | Erstellt am 21. Aug. 2001 Geliefert am 22. Aug. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever and under the financing agreement as defined in the all assets debenture | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 26. Juli 2001 Geliefert am 14. Aug. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Agreement and charge | Erstellt am 05. Juli 1999 Geliefert am 21. Juli 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under this deed or under the sub-sub underlease (as defined) | |
Kurze Angaben £40,750 being the deposit in the deposit account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0