NIKE MERCURIAL II LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | NIKE MERCURIAL II LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02744719 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von NIKE MERCURIAL II LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich NIKE MERCURIAL II LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nike Camberwell Way Doxford International Business Park SR3 3XN Sunderland England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von NIKE MERCURIAL II LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| UMBRO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 02. Juni 2000 | 02. Juni 2000 |
| UMBRO EUROPE (HOLDINGS) LIMITED | 31. Dez. 1996 | 31. Dez. 1996 |
| UMBRO EUROPE LIMITED | 01. Dez. 1993 | 01. Dez. 1993 |
| UMBRO INTERNATIONAL (EUROPE) LIMITED | 24. Feb. 1993 | 24. Feb. 1993 |
| UMBRO INTERNATIONAL EUROPE LIMITED | 03. Nov. 1992 | 03. Nov. 1992 |
| BROOMCO (591) LIMITED | 03. Sept. 1992 | 03. Sept. 1992 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NIKE MERCURIAL II LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Mai 2013 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für NIKE MERCURIAL II LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für NIKE MERCURIAL II LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 29. Aug. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2013 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed umbro international holdings LIMITED\certificate issued on 10/07/13 | 3 Seiten | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Evan Scott Reynolds als Sekretär am 29. Mai 2013 | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Umbro House, Lakeside Cheadle Royal Business Park Cheadle Cheshire SK8 3GQ am 29. Mai 2013 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Andrew Hare als Sekretär am 29. Mai 2013 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2012 | 19 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Evan Scott Reynolds als Direktor am 03. Dez. 2012 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Gary James Brown als Geschäftsführer am 03. Dez. 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 29. Aug. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 22. Mai 2012
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 4 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2011 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 29. Aug. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von James Allaker als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Eunan Mclaughlin als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 29. Aug. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Grant Winston Hanson am 29. Aug. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für David Andrew Hare am 29. Aug. 2010 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Gary James Brown am 29. Aug. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2010 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von NIKE MERCURIAL II LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REYNOLDS, Evan Scott | Sekretär | Camberwell Way Doxford International Business Park SR3 3XN Sunderland Nike England | 178624920001 | |||||||
| HANSON, Grant Winston | Geschäftsführer | Camberwell Way Doxford International Business Park SR3 3XN Sunderland Nike England | United States | American | 128634930001 | |||||
| REYNOLDS, Evan Scott | Geschäftsführer | Camberwell Way Doxford International Business Park SR3 3XN Sunderland Nike England | United States | American | 174461900001 | |||||
| CAMPBELL JNR, John M | Sekretär | 1 Petiver Lane Greenville South Carolina 29605 United States | British | 31126770001 | ||||||
| DARWIN, Andrew David | Sekretär | 76 Ivy Park Road Ranmoor S10 3LD Sheffield South Yorkshire | British | 14246940002 | ||||||
| ELLISON, Stephanie Joy | Sekretär | Umbro International Limited PO BOX 33 Dallimore Road M23 9GJ Roundthorn Industrial Estate Manchester | British | 35963700001 | ||||||
| ELLISON, Stephanie Joy | Sekretär | 26 The Cobbles Cuddington CW8 2XH Northwich Cheshire | British | 63214420001 | ||||||
| HARE, David Andrew | Sekretär | Umbro House, Lakeside Cheadle Royal Business Park SK8 3GQ Cheadle Cheshire | British | 94574310001 | ||||||
| DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield South Yorkshire | 900003810001 | |||||||
| ALLAKER, James | Geschäftsführer | Umbro House, Lakeside Cheadle Royal Business Park SK8 3GQ Cheadle Cheshire | England | British | 116430430001 | |||||
| BIRD III, Lewis Leo | Geschäftsführer | 6191 Sw Wilhelm Road Tualatin Or 97062 Usa | United States | 125383590001 | ||||||
| BROWN, Gary James | Geschäftsführer | Umbro House, Lakeside Cheadle Royal Business Park SK8 3GQ Cheadle Cheshire | England | British | 125196870001 | |||||
| COOK, Matthew Adrian | Geschäftsführer | Via Scornetta San Lazzaro Di Savena Bologna 31 Italy | British | 128768440001 | ||||||
| CORBIDGE, Mark Andrew | Geschäftsführer | 1 Hurlingham Square SW6 3DZ London | England | British | 55506050001 | |||||
| DINGES, Gregory Clark | Geschäftsführer | Terrace Drive 97034 Lake Oswego 907 Oregon Usa | American | 128857410001 | ||||||
| DUCKWORTH, Allan | Geschäftsführer | 18 Firbank Church Park PR7 6HP Euxton Lancashire | England | British | 50488440001 | |||||
| HARE, David Andrew | Geschäftsführer | 12 Clifton Avenue M14 6UB Manchester Lancashire | England | British | 94574310001 | |||||
| HATFIELD, Alan | Geschäftsführer | 9 Cornfield SK15 2UA Stalybridge Cheshire | British | 62250740001 | ||||||
| KENYON, Peter Francis | Geschäftsführer | 24 Northumberland Place W2 5BS London | British | 95799140001 | ||||||
| MAKIN, Steve Richard | Geschäftsführer | 4 Shortsill Lane Coneythorpe HG5 0RL Knaresborough North Yorkshire | United Kingdom | British | 133477340001 | |||||
| MCGUIGAN, Peter | Geschäftsführer | Green Walk Bowdon WA14 2SN Altrincham Telfa House Cheshire United Kingdom | England | British | 136211350001 | |||||
| MCLAUGHLIN, Eunan Patrick | Geschäftsführer | Umbro House, Lakeside Cheadle Royal Business Park SK8 3GQ Cheadle Cheshire | Netherlands | Irish | 146619970001 | |||||
| MONAGHAN, Mark | Geschäftsführer | 26 Beaufort Avenue M33 3WL Sale Cheshire | British | 48690170001 | ||||||
| PRESTON, Steven | Geschäftsführer | Yew Tree Barn Yew Tree Farm Yew Tree Lane WA4 4QZ Appleton Thorn Cheshire | Northern Ireland | British | 87165990001 | |||||
| PROTHERO, Martin | Geschäftsführer | 2 Juniper Court CH2 3EH Hoole Cheshire | British | 106133480001 | ||||||
| STONE, IV, Eugene Earl | Geschäftsführer | 18 Persimmon Lane Greenville South Carolina 29609 Usa | American | 46647900001 | ||||||
| WEST, John Joseph | Geschäftsführer | Crows Nest GU25 4QN Virginia Water Surrey | British | 631130001 | ||||||
| DLA NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield South Yorkshire | 900003800001 |
Hat NIKE MERCURIAL II LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee & debenture | Erstellt am 28. Apr. 2004 Geliefert am 06. Mai 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 23. Apr. 1999 Geliefert am 05. Mai 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the finance documents (as defined) and this debenture | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 09. Apr. 1997 Geliefert am 16. Apr. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of each loan document to which the chargor is a party except for any obligation which, if it were so included, would result in the deed contravening section 151 of the companies act 1985 | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over shares | Erstellt am 31. Aug. 1995 Geliefert am 15. Sept. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben All dividends and interest or other distributions on all stocks shares bonds and securities specified in the first schedule to the charge. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 31. Aug. 1995 Geliefert am 15. Sept. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment of contract monies | Erstellt am 30. Nov. 1993 Geliefert am 17. Dez. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or umbro international limited now k/a umbro U.K.limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Assignment of all monies due under the contract dated 24TH august 1993. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Floating charge | Erstellt am 30. Nov. 1993 Geliefert am 17. Dez. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Floating charge over the undertaking and all property and assets present and future. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 30. Nov. 1993 Geliefert am 02. Dez. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land hereditaments and premises k/a land on the west side of rossfield road rossmore trading estate ellesmere port cheshire t/n CH303293 land lying to the south west of hulley road macclesfield cheshire CH123396 plot 6 hurdsfield industrial estate macclesfield CH216273 and land at hulley road hurdsfield industr ial estate CH303292 with all fixtures and fittings. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 15. Juni 1993 Geliefert am 18. Juni 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from umbro international limited and its subsidiaries to the chargee as agent and trustee for the banks under the terms of the revolving credit agreement dated 14 june 1993 or the other loan documents or the collateral instruments | |
Kurze Angaben (A)properties.(b)plant and machinery.(c)securities.(d)debts.(e)insurance(f)intangible property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A memorandum of deposit and charge over securities | Erstellt am 14. Jan. 1993 Geliefert am 25. Jan. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys and other liabilities in excess of $4,500,000 due owing or incurred by stone manufacturing co. To the chargee (as agent and trustee for the lenders) or the lenders (as defined) pursuant to an amended and restated loan and security agreement dated 12TH january 1993 (as may be further amended or restated from time to time) and all other monies due pursuant to the charge. | |
Kurze Angaben 160,000 ordinary shares of £1 each in the issued share capital of the company and/or all stocks,shares,bonds,debentures,certificates of deposit and other securities of any kind.please see doc M348C for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 30. Sept. 1992 Geliefert am 03. Okt. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that f/h land and and buildings k/as 63 union street stockport greater manchester.t/no.gm 490382 by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant,machinery and fixtures and fittings,furniture,equipment,implements and utensils now and in the future at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 30. Sept. 1992 Geliefert am 03. Okt. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that l/h land on the west side of rossfield road rossmore trading estate,ellesmere port ellesmere port and neston,cheshire.t/no.ch 303293.by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant,machinery and fixtures and fittings,furniture,equipment,implements and utensils now and in the future at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 30. Sept. 1992 Geliefert am 03. Okt. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that f/h land and buildings k/as plot 6 hurdsfield industrial estate macclesfield cheshire.t/no. Ch 216273.by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant,machinery and fixtures and fittings,furniture,equipment,implements & utensils now and in the future at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 30. Sept. 1992 Geliefert am 03. Okt. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that f/h land at hulley road hurdsfield industrial estate macclesfield cheshire.t/nos.CH123396 and CH303292.by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property described above and the plant,machinery & fixtures and fittings,furniture,equipment,implements and utensils. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0