NIKE MERCURIAL II LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameNIKE MERCURIAL II LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02744719
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von NIKE MERCURIAL II LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich NIKE MERCURIAL II LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Nike Camberwell Way
    Doxford International Business Park
    SR3 3XN Sunderland
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von NIKE MERCURIAL II LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    UMBRO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED02. Juni 200002. Juni 2000
    UMBRO EUROPE (HOLDINGS) LIMITED31. Dez. 199631. Dez. 1996
    UMBRO EUROPE LIMITED01. Dez. 199301. Dez. 1993
    UMBRO INTERNATIONAL (EUROPE) LIMITED24. Feb. 199324. Feb. 1993
    UMBRO INTERNATIONAL EUROPE LIMITED03. Nov. 199203. Nov. 1992
    BROOMCO (591) LIMITED03. Sept. 199203. Sept. 1992

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NIKE MERCURIAL II LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Mai 2013

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für NIKE MERCURIAL II LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für NIKE MERCURIAL II LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Jahresrückblick erstellt bis 29. Aug. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital26. Sept. 2013

    Kapitalaufstellung am 26. Sept. 2013

    • Kapital: GBP 1
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2013

    9 SeitenAA

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed umbro international holdings LIMITED\certificate issued on 10/07/13
    3 SeitenCERTNM
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name10. Juli 2013

    Namensänderung durch Beschluss

    NM01
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 07. Jan. 2013

    RES15

    Ernennung von Mr Evan Scott Reynolds als Sekretär am 29. Mai 2013

    1 SeitenAP03

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Umbro House, Lakeside Cheadle Royal Business Park Cheadle Cheshire SK8 3GQ am 29. Mai 2013

    1 SeitenAD01

    Beendigung der Bestellung von David Andrew Hare als Sekretär am 29. Mai 2013

    1 SeitenTM02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2012

    19 SeitenAA

    Ernennung von Evan Scott Reynolds als Direktor am 03. Dez. 2012

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Gary James Brown als Geschäftsführer am 03. Dez. 2012

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 29. Aug. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    legacy

    2 SeitenSH20

    legacy

    2 SeitenCAP-SS

    Kapitalaufstellung am 22. Mai 2012

    • Kapital: GBP 1
    4 SeitenSH19

    Beschlüsse

    Resolutions
    4 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2011

    14 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 29. Aug. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von James Allaker als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Eunan Mclaughlin als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 29. Aug. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Grant Winston Hanson am 29. Aug. 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für David Andrew Hare am 29. Aug. 2010

    1 SeitenCH03

    Änderung der Details des Direktors für Gary James Brown am 29. Aug. 2010

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2010

    12 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von NIKE MERCURIAL II LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    REYNOLDS, Evan Scott
    Camberwell Way
    Doxford International Business Park
    SR3 3XN Sunderland
    Nike
    England
    Sekretär
    Camberwell Way
    Doxford International Business Park
    SR3 3XN Sunderland
    Nike
    England
    178624920001
    HANSON, Grant Winston
    Camberwell Way
    Doxford International Business Park
    SR3 3XN Sunderland
    Nike
    England
    Geschäftsführer
    Camberwell Way
    Doxford International Business Park
    SR3 3XN Sunderland
    Nike
    England
    United StatesAmerican128634930001
    REYNOLDS, Evan Scott
    Camberwell Way
    Doxford International Business Park
    SR3 3XN Sunderland
    Nike
    England
    Geschäftsführer
    Camberwell Way
    Doxford International Business Park
    SR3 3XN Sunderland
    Nike
    England
    United StatesAmerican174461900001
    CAMPBELL JNR, John M
    1 Petiver Lane
    Greenville
    South Carolina 29605
    United States
    Sekretär
    1 Petiver Lane
    Greenville
    South Carolina 29605
    United States
    British31126770001
    DARWIN, Andrew David
    76 Ivy Park Road Ranmoor
    S10 3LD Sheffield
    South Yorkshire
    Sekretär
    76 Ivy Park Road Ranmoor
    S10 3LD Sheffield
    South Yorkshire
    British14246940002
    ELLISON, Stephanie Joy
    Umbro International Limited
    PO BOX 33 Dallimore Road
    M23 9GJ Roundthorn Industrial Estate
    Manchester
    Sekretär
    Umbro International Limited
    PO BOX 33 Dallimore Road
    M23 9GJ Roundthorn Industrial Estate
    Manchester
    British35963700001
    ELLISON, Stephanie Joy
    26 The Cobbles
    Cuddington
    CW8 2XH Northwich
    Cheshire
    Sekretär
    26 The Cobbles
    Cuddington
    CW8 2XH Northwich
    Cheshire
    British63214420001
    HARE, David Andrew
    Umbro House, Lakeside
    Cheadle Royal Business Park
    SK8 3GQ Cheadle
    Cheshire
    Sekretär
    Umbro House, Lakeside
    Cheadle Royal Business Park
    SK8 3GQ Cheadle
    Cheshire
    British94574310001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Bevollmächtigter Sekretär
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    900003810001
    ALLAKER, James
    Umbro House, Lakeside
    Cheadle Royal Business Park
    SK8 3GQ Cheadle
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Umbro House, Lakeside
    Cheadle Royal Business Park
    SK8 3GQ Cheadle
    Cheshire
    EnglandBritish116430430001
    BIRD III, Lewis Leo
    6191 Sw Wilhelm Road
    Tualatin
    Or 97062
    Usa
    Geschäftsführer
    6191 Sw Wilhelm Road
    Tualatin
    Or 97062
    Usa
    United States125383590001
    BROWN, Gary James
    Umbro House, Lakeside
    Cheadle Royal Business Park
    SK8 3GQ Cheadle
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Umbro House, Lakeside
    Cheadle Royal Business Park
    SK8 3GQ Cheadle
    Cheshire
    EnglandBritish125196870001
    COOK, Matthew Adrian
    Via Scornetta
    San Lazzaro Di Savena
    Bologna
    31
    Italy
    Geschäftsführer
    Via Scornetta
    San Lazzaro Di Savena
    Bologna
    31
    Italy
    British128768440001
    CORBIDGE, Mark Andrew
    1 Hurlingham Square
    SW6 3DZ London
    Geschäftsführer
    1 Hurlingham Square
    SW6 3DZ London
    EnglandBritish55506050001
    DINGES, Gregory Clark
    Terrace Drive
    97034 Lake Oswego
    907
    Oregon
    Usa
    Geschäftsführer
    Terrace Drive
    97034 Lake Oswego
    907
    Oregon
    Usa
    American128857410001
    DUCKWORTH, Allan
    18 Firbank
    Church Park
    PR7 6HP Euxton
    Lancashire
    Geschäftsführer
    18 Firbank
    Church Park
    PR7 6HP Euxton
    Lancashire
    EnglandBritish50488440001
    HARE, David Andrew
    12 Clifton Avenue
    M14 6UB Manchester
    Lancashire
    Geschäftsführer
    12 Clifton Avenue
    M14 6UB Manchester
    Lancashire
    EnglandBritish94574310001
    HATFIELD, Alan
    9 Cornfield
    SK15 2UA Stalybridge
    Cheshire
    Geschäftsführer
    9 Cornfield
    SK15 2UA Stalybridge
    Cheshire
    British62250740001
    KENYON, Peter Francis
    24 Northumberland Place
    W2 5BS London
    Geschäftsführer
    24 Northumberland Place
    W2 5BS London
    British95799140001
    MAKIN, Steve Richard
    4 Shortsill Lane
    Coneythorpe
    HG5 0RL Knaresborough
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    4 Shortsill Lane
    Coneythorpe
    HG5 0RL Knaresborough
    North Yorkshire
    United KingdomBritish133477340001
    MCGUIGAN, Peter
    Green Walk
    Bowdon
    WA14 2SN Altrincham
    Telfa House
    Cheshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Green Walk
    Bowdon
    WA14 2SN Altrincham
    Telfa House
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritish136211350001
    MCLAUGHLIN, Eunan Patrick
    Umbro House, Lakeside
    Cheadle Royal Business Park
    SK8 3GQ Cheadle
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Umbro House, Lakeside
    Cheadle Royal Business Park
    SK8 3GQ Cheadle
    Cheshire
    NetherlandsIrish146619970001
    MONAGHAN, Mark
    26 Beaufort Avenue
    M33 3WL Sale
    Cheshire
    Geschäftsführer
    26 Beaufort Avenue
    M33 3WL Sale
    Cheshire
    British48690170001
    PRESTON, Steven
    Yew Tree Barn
    Yew Tree Farm Yew Tree Lane
    WA4 4QZ Appleton Thorn
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Yew Tree Barn
    Yew Tree Farm Yew Tree Lane
    WA4 4QZ Appleton Thorn
    Cheshire
    Northern IrelandBritish87165990001
    PROTHERO, Martin
    2 Juniper Court
    CH2 3EH Hoole
    Cheshire
    Geschäftsführer
    2 Juniper Court
    CH2 3EH Hoole
    Cheshire
    British106133480001
    STONE, IV, Eugene Earl
    18 Persimmon Lane
    Greenville
    South Carolina 29609
    Usa
    Geschäftsführer
    18 Persimmon Lane
    Greenville
    South Carolina 29609
    Usa
    American46647900001
    WEST, John Joseph
    Crows Nest
    GU25 4QN Virginia Water
    Surrey
    Geschäftsführer
    Crows Nest
    GU25 4QN Virginia Water
    Surrey
    British631130001
    DLA NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    900003800001

    Hat NIKE MERCURIAL II LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 28. Apr. 2004
    Geliefert am 06. Mai 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transaktionen
    • 06. Mai 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Juli 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 23. Apr. 1999
    Geliefert am 05. Mai 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the finance documents (as defined) and this debenture
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bny International Limited,as "Trustee" (As Defined)
    Transaktionen
    • 05. Mai 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Aug. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 09. Apr. 1997
    Geliefert am 16. Apr. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of each loan document to which the chargor is a party except for any obligation which, if it were so included, would result in the deed contravening section 151 of the companies act 1985
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of America N.T. & S.A.(As Security Agent and Trustee for the Finance Parties )
    Transaktionen
    • 16. Apr. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Mai 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over shares
    Erstellt am 31. Aug. 1995
    Geliefert am 15. Sept. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    All dividends and interest or other distributions on all stocks shares bonds and securities specified in the first schedule to the charge. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The First National Bank of Bostonas Agent for the Banks (As Defined)
    Transaktionen
    • 15. Sept. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Juni 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 31. Aug. 1995
    Geliefert am 15. Sept. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The First National Bank of Bostonas Agent for the Banks (As Defined)
    Transaktionen
    • 15. Sept. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Juni 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of contract monies
    Erstellt am 30. Nov. 1993
    Geliefert am 17. Dez. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or umbro international limited now k/a umbro U.K.limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Assignment of all monies due under the contract dated 24TH august 1993. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Dez. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Nov. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Floating charge
    Erstellt am 30. Nov. 1993
    Geliefert am 17. Dez. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Floating charge over the undertaking and all property and assets present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Dez. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Mai 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Nov. 1993
    Geliefert am 02. Dez. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land hereditaments and premises k/a land on the west side of rossfield road rossmore trading estate ellesmere port cheshire t/n CH303293 land lying to the south west of hulley road macclesfield cheshire CH123396 plot 6 hurdsfield industrial estate macclesfield CH216273 and land at hulley road hurdsfield industr ial estate CH303292 with all fixtures and fittings. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Dez. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Mai 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 15. Juni 1993
    Geliefert am 18. Juni 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from umbro international limited and its subsidiaries to the chargee as agent and trustee for the banks under the terms of the revolving credit agreement dated 14 june 1993 or the other loan documents or the collateral instruments
    Kurze Angaben
    (A)properties.(b)plant and machinery.(c)securities.(d)debts.(e)insurance(f)intangible property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The First National Bank of Bostonas Agent and Trustee for the Banks
    Transaktionen
    • 18. Juni 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Juni 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A memorandum of deposit and charge over securities
    Erstellt am 14. Jan. 1993
    Geliefert am 25. Jan. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys and other liabilities in excess of $4,500,000 due owing or incurred by stone manufacturing co. To the chargee (as agent and trustee for the lenders) or the lenders (as defined) pursuant to an amended and restated loan and security agreement dated 12TH january 1993 (as may be further amended or restated from time to time) and all other monies due pursuant to the charge.
    Kurze Angaben
    160,000 ordinary shares of £1 each in the issued share capital of the company and/or all stocks,shares,bonds,debentures,certificates of deposit and other securities of any kind.please see doc M348C for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bancboston Financial Companyas Agent and Trustee for the Lenders
    Transaktionen
    • 25. Jan. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Juni 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Sept. 1992
    Geliefert am 03. Okt. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that f/h land and and buildings k/as 63 union street stockport greater manchester.t/no.gm 490382 by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant,machinery and fixtures and fittings,furniture,equipment,implements and utensils now and in the future at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 03. Okt. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Aug. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Sept. 1992
    Geliefert am 03. Okt. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that l/h land on the west side of rossfield road rossmore trading estate,ellesmere port ellesmere port and neston,cheshire.t/no.ch 303293.by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant,machinery and fixtures and fittings,furniture,equipment,implements and utensils now and in the future at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 03. Okt. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Aug. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Sept. 1992
    Geliefert am 03. Okt. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that f/h land and buildings k/as plot 6 hurdsfield industrial estate macclesfield cheshire.t/no. Ch 216273.by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant,machinery and fixtures and fittings,furniture,equipment,implements & utensils now and in the future at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 03. Okt. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Aug. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Sept. 1992
    Geliefert am 03. Okt. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that f/h land at hulley road hurdsfield industrial estate macclesfield cheshire.t/nos.CH123396 and CH303292.by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property described above and the plant,machinery & fixtures and fittings,furniture,equipment,implements and utensils.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 03. Okt. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Aug. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0