MEARS HOMECARE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | MEARS HOMECARE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02744787 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MEARS HOMECARE LIMITED?
- Aktivitäten von Zeitarbeitsagenturen (78200) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
- Sonstige menschliche Gesundheitsaktivitäten (86900) / Gesundheits- und Sozialwesen
Wo befindet sich MEARS HOMECARE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1390 Montpellier Court, Gloucester Business Park Brockworth GL3 4AH Gloucester |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von MEARS HOMECARE LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| CARE UK HOMECARE LIMITED | 11. Okt. 2001 | 11. Okt. 2001 |
| HOMECARING LIMITED | 15. Apr. 1993 | 15. Apr. 1993 |
| FIT BITZ LIMITED | 03. Sept. 1992 | 03. Sept. 1992 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MEARS HOMECARE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2022 |
Welche sind die letzten Einreichungen für MEARS HOMECARE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2022 | 14 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 167 Seiten | PARENT_ACC | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | AGREEMENT2 | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 19. Juli 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 03. Apr. 2023
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 14 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 171 Seiten | PARENT_ACC | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | AGREEMENT2 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 19. Juli 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 22 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 19. Juli 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Change of details for Mears Care (Holdings) Limited as a person with significant control on 01. Juli 2021 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 19. Juli 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 26 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 25 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 19. Juli 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von MEARS HOMECARE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WESTRAN, Ben Robert | Sekretär | Montpellier Court, Gloucester Business Park Brockworth GL3 4AH Gloucester 1390 | 198336280001 | |||||||||||
| SMITH, Andrew Christopher Melville | Geschäftsführer | Montpellier Court, Gloucester Business Park Brockworth GL3 4AH Gloucester 1390 England | England | British | 121328600001 | |||||||||
| MEARS GROUP PLC | Geschäftsführer | Montpellier Court, Gloucester Business Park Brockworth GL3 4AH Gloucester 1390 England |
| 149799340001 | ||||||||||
| BISHOP, Bryon | Sekretär | Great Woodley Farm House Woodley Lane SO51 7PE Romsey Hampshire | British | 22786840001 | ||||||||||
| BOOKER, Roger Ian | Sekretär | 4 Southgate Gardens Long Melford CO10 9HB Sudbury Suffolk | British | 14044530002 | ||||||||||
| CALOW, Jonathan David | Sekretär | Connaught House 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Essex | 165449440001 | |||||||||||
| GRIFFITHS, Freda Margaret | Sekretär | 2 Hiltingbury Road SO53 5SW Eastleigh Hampshire | British | 30316030001 | ||||||||||
| HUMPHREYS, Paul Justin | Sekretär | Hall Barn Creeting Hall Farm Creeting Saint Peter IP6 8QZ Ipswich Suffolk | British | 33223550003 | ||||||||||
| CARE UK SERVICES LTD | Sekretär | 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Connaught House Essex United Kingdom |
| 125241530002 | ||||||||||
| WATERLOW SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003950001 | |||||||||||
| BENN, Geoffrey Richard | Geschäftsführer | 15 Mimosa Close CM1 6NW Chelmsford Essex | England | British | 73786580001 | |||||||||
| BISHOP, Bryon | Geschäftsführer | Great Woodley Farm House Woodley Lane SO51 7PE Romsey Hampshire | United Kingdom | British | 22786840001 | |||||||||
| BOOKER, Roger Ian | Geschäftsführer | Fairview 17a Queens Road WA15 9HF Hale Cheshire | United Kingdom | British | 14044530003 | |||||||||
| BOOKER, Roger Ian | Geschäftsführer | 4 Southgate Gardens Long Melford CO10 9HB Sudbury Suffolk | British | 14044530002 | ||||||||||
| BRYANT, James Richard Stansfeld | Geschäftsführer | Drapers Farmhouse Rushden SG9 0TB Buntingford Hertfordshire | England | British | 7897550001 | |||||||||
| CLOUGH, Richard Stanley | Geschäftsführer | Hanini 50 Second Avenue CO13 9LX Frinton On Sea Essex | England | British | 7897560001 | |||||||||
| CULHANE, Angela | Geschäftsführer | Connaught House 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Essex | England | British | 68602910001 | |||||||||
| GRIFFITHS, Freda Margaret | Geschäftsführer | 2 Hiltingbury Road SO53 5SW Eastleigh Hampshire | British | 30316030001 | ||||||||||
| HASTINGS, Roy | Geschäftsführer | Wallis Road RG21 3DN Basingstoke 20 Hampshire | United Kingdom | British | 130098430001 | |||||||||
| HUMPHREYS, Paul Justin | Geschäftsführer | Connaught House 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Essex | United Kingdom | British | 33223550003 | |||||||||
| MARRIOTT-LAVERY, Deborah Jane | Geschäftsführer | Connaught House 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Essex | United Kingdom | British | 151689670002 | |||||||||
| PAGE, Jacalyn Frances | Geschäftsführer | 15 Chessel Crescent Bitterne SO19 4BR Southampton Hampshire | British | 30316040001 | ||||||||||
| PARISH, Michael Robert | Geschäftsführer | Connaught House 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Essex | England | British | 78828750003 | |||||||||
| QUINN, David Laurence, Mr. | Geschäftsführer | 6 Whitecross Road HP17 8BA Haddenham Buckinghamshire | England | British | 123356660001 | |||||||||
| RUSSELL, Andrew Philip Thomas | Geschäftsführer | 37 Woodley Lane SO51 7JL Romsey Hampshire | England | British | 23099130001 | |||||||||
| RUSSELL, Vivienne Patricia | Geschäftsführer | 37 Woodley Lane SO51 7JL Romsey Hampshire | England | British | 33748240001 | |||||||||
| SCOTT, Christine Jennifer | Geschäftsführer | 166 Bucklesham Road Purdis Farm IP3 8SW Ipswich Suffolk | British | 24581020002 | ||||||||||
| UMBERS, Douglas | Geschäftsführer | SO53 | United Kingdom | British | 90541690001 | |||||||||
| VOCKINS, Anthony Frederick | Geschäftsführer | 4 Main Street Croxton Kerrial NG32 1QF Grantham The Old Post Office Lincolnshire | England | British | 130512090002 | |||||||||
| WATSON, Paul John | Geschäftsführer | Montpellier Court, Gloucester Business Park Brockworth GL3 4AH Gloucester 1390 England | United Kingdom | British | 82460360003 | |||||||||
| WEEKS, Catherine Jane | Geschäftsführer | 8 Chancellery Mews Risbygate Street IP33 3AB Bury St. Edmunds Suffolk | British | 72222500003 | ||||||||||
| WHITECROSS, Philip James | Geschäftsführer | Connaught House 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Essex | England | British | 193730760001 | |||||||||
| WATERLOW NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003940001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei MEARS HOMECARE LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mears Extra Care Limited | 06. Apr. 2016 | Gloucester Business Park GL3 4AH Brockworth 1390 Montpellier Court Gloucester United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat MEARS HOMECARE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 22. Feb. 2018 Geliefert am 22. Feb. 2018 | Vollständig erfüllt | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 26. Sept. 2014 Geliefert am 30. Sept. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung The company charged by way of first fixed charge all its intellectual property (although no further details are specified in the charge for intellectual property owned by this company). For further detail, see clause 3.1(b)(vii) of the charge.. The company listed above charged by way of first legal mortgage all its real property (although no further details are specified in the charge for real property owned by this company). For further detail, see clause 3.1(a) of the charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 22. Dez. 2011 Geliefert am 05. Jan. 2012 | Ausstehend | Gesicherter Betrag £3,671.88 due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Its interest in the deposit account see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. Juli 2010 Geliefert am 26. Juli 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 12. Feb. 2009 Geliefert am 14. Feb. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag £3,671.88 due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben With full title guarantee by way of fixed charge charges its interest in the deposit and all money from time to time withdrawn from the deposit in accordance with the rent deposit deed. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 10. Jan. 2006 Geliefert am 12. Jan. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben £3,671.88 held in a deposit account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 21. Jan. 2005 Geliefert am 26. Jan. 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag £4,406.25 due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The interest and all sums from time to time in a deposit account with the hsbc bank PLC. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 02. Juli 2004 Geliefert am 17. Juli 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The sum of £8,250.00. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. März 2000 Geliefert am 11. Apr. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies, obligations and liabilities due or to become due from the company to any beneficiary under or pursuant to the terms of any of the finance documents, the loan facility or other financial accommodation and under the terms of the charge (all defined therein) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 30. März 2000 Geliefert am 10. Apr. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 21. Jan. 1999 Geliefert am 01. Feb. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 20. Juli 1995 Geliefert am 26. Juli 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0