NATIONAL BRITANNIA GROUP LIMITED

NATIONAL BRITANNIA GROUP LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameNATIONAL BRITANNIA GROUP LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02747765
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von NATIONAL BRITANNIA GROUP LIMITED?

    • (7415) /

    Wo befindet sich NATIONAL BRITANNIA GROUP LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    KPMG LLP
    PO BOX 695 8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von NATIONAL BRITANNIA GROUP LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CONNAUGHT COMPLIANCE SERVICES GROUP LIMITED24. Sept. 200824. Sept. 2008
    NATIONAL BRITANNIA GROUP LIMITED04. Mai 200004. Mai 2000
    NATIONAL BRITANNIA INVESTMENTS LIMITED08. Juni 199908. Juni 1999
    NATIONAL BRITANNIA GROUP LIMITED01. Aug. 199301. Aug. 1993
    NATIONAL BRITANNIA LIMITED08. Dez. 199208. Dez. 1992
    VITAPRIME LIMITED16. Sept. 199216. Sept. 1992

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NATIONAL BRITANNIA GROUP LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Aug. 2009

    Welche sind die letzten Einreichungen für NATIONAL BRITANNIA GROUP LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 19. Apr. 2013

    20 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 30. Apr. 2013

    20 Seiten2.35B

    Mitteilung über die Amtsniederlegung durch den Administrator

    33 Seiten2.39B

    Mitteilung über die Ernennung eines Ersatz-/Zusatzadministrators

    1 Seiten2.40B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 25. Nov. 2012

    33 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 25. Nov. 2012

    38 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 25. Mai 2012

    39 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 13. Dez. 2011

    43 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 31. Juli 2011

    46 Seiten2.24B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    7 Seiten2.16B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Kpmg Llp PO Box 695 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB am 11. Mai 2011

    2 SeitenAD01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Santia House Caerphilly Business Park Caerphilly Mid Glamorgan CF83 3GG Wales am 11. Mai 2011

    2 SeitenAD01

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    1 SeitenF2.18

    Vorschlag des Verwalters

    66 Seiten2.17B

    Vorschlag des Verwalters

    65 Seiten2.17B

    Beendigung der Bestellung von Ian Carlisle als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Beendigung der Bestellung von Julia Cavanagh als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von David Wells als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Connaught House Grenadier Road Exeter Business Park Exeter Devon EX1 3QF am 01. Dez. 2010

    1 SeitenAD01

    Wer sind die Geschäftsführer von NATIONAL BRITANNIA GROUP LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    CAVANAGH, Julia
    Grenadier Road
    Exeter Business Park
    EX1 3QF Exeter
    Connaught House
    Devon
    Sekretär
    Grenadier Road
    Exeter Business Park
    EX1 3QF Exeter
    Connaught House
    Devon
    British146793110001
    DA COSTA, Jean Paul
    2 Vale Court
    21 Mallord Street
    SW3 6AL London
    Sekretär
    2 Vale Court
    21 Mallord Street
    SW3 6AL London
    British95259980001
    LOUDEN, Nicholas William
    11 Heol Y Bont
    Rhiwbina
    CF14 6AJ Cardiff
    South Glamorgan
    Sekretär
    11 Heol Y Bont
    Rhiwbina
    CF14 6AJ Cardiff
    South Glamorgan
    British76293900002
    SAUNBY, Kevin David
    Rudgwick
    Westwell Lane Potters Corner
    TN26 1JA Ashford
    Kent
    Sekretär
    Rudgwick
    Westwell Lane Potters Corner
    TN26 1JA Ashford
    Kent
    British18474810005
    WELLS, David Francis
    Ashley
    SN13 8AJ Near Box
    Ashley Farmhouse
    Wiltshire
    England
    Sekretär
    Ashley
    SN13 8AJ Near Box
    Ashley Farmhouse
    Wiltshire
    England
    BritishAccountant104366980002
    SEVERNSIDE NOMINEES LIMITED
    14-18 City Road
    CF24 3DL Cardiff
    Bevollmächtigter Sekretär
    14-18 City Road
    CF24 3DL Cardiff
    900003980001
    BRUCE, Charles
    Summerdale 8 Greenway Lane
    BA2 4LJ Bath
    Geschäftsführer
    Summerdale 8 Greenway Lane
    BA2 4LJ Bath
    BritishChartered Accountant46553680002
    CARLISLE, Ian
    Caerphilly Business Park
    CF83 3GG Caerphilly
    Santia House
    Mid Glamorgan
    Wales
    Geschäftsführer
    Caerphilly Business Park
    CF83 3GG Caerphilly
    Santia House
    Mid Glamorgan
    Wales
    EnglandBritishCheif Exceutive146715900001
    DA COSTA, Jean Paul
    2 Vale Court
    21 Mallord Street
    SW3 6AL London
    Geschäftsführer
    2 Vale Court
    21 Mallord Street
    SW3 6AL London
    BritishBarrister95259980001
    EPPS, Stuart Lewis
    17 Idencroft Close
    Pontprennau
    CF23 8PH Cardiff
    Geschäftsführer
    17 Idencroft Close
    Pontprennau
    CF23 8PH Cardiff
    WalesWelshFinancial Director76860630003
    FORD, Peter Michael
    White Strake Hawksdown Road
    Walmer
    CT14 7PW Deal
    Kent
    Geschäftsführer
    White Strake Hawksdown Road
    Walmer
    CT14 7PW Deal
    Kent
    EnglandBritishCompany Director16613000001
    FOX, Richard
    39 Fairview Avenue
    Narbarth Pa
    19072
    Usa
    Geschäftsführer
    39 Fairview Avenue
    Narbarth Pa
    19072
    Usa
    United StatesAmericanBusiness31666810001
    GIBSON, John
    8 Fairways View
    Talbot Green Forest Hills Estate
    CF7 8JG Pontyclun
    Mid Glamorgan
    Geschäftsführer
    8 Fairways View
    Talbot Green Forest Hills Estate
    CF7 8JG Pontyclun
    Mid Glamorgan
    BritishDirector35357800001
    HEANEY, Quintin John
    Flat 257 County Hall
    Belvedere Road
    SE1 7GH London
    Geschäftsführer
    Flat 257 County Hall
    Belvedere Road
    SE1 7GH London
    United KingdomBritishChartered Accountant112028430001
    HILL, Stephen Ronald
    Oakfield House
    Stoke Hill
    EX4 9JN Exeter
    Devon
    Geschäftsführer
    Oakfield House
    Stoke Hill
    EX4 9JN Exeter
    Devon
    United KingdomBritishFinance Director115233060001
    HOLROYD, Charles Edward
    Colton Lodge
    Colton
    LS24 8EL Tadcaster
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Colton Lodge
    Colton
    LS24 8EL Tadcaster
    North Yorkshire
    BritishChartered Accountant1492260001
    LOUDEN, Nicholas William
    11 Heol Y Bont
    Rhiwbina
    CF14 6AJ Cardiff
    South Glamorgan
    Geschäftsführer
    11 Heol Y Bont
    Rhiwbina
    CF14 6AJ Cardiff
    South Glamorgan
    WalesBritishFinance Director76293900002
    MATTHEWS, Peter Charles
    33 Tower Close
    Bassingbourn
    SG8 5JX Royston
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    33 Tower Close
    Bassingbourn
    SG8 5JX Royston
    Hertfordshire
    BritishDirector14571860001
    PERCY DAVIS, John
    Apartment 9 Charlesworth House
    48 Stanhope Gardens
    SW7 5RD London
    Geschäftsführer
    Apartment 9 Charlesworth House
    48 Stanhope Gardens
    SW7 5RD London
    BritishInsurance Broker74708620005
    PERCY DAVIS, John
    Apartment 9 Charlesworth House
    48 Stanhope Gardens
    SW7 5RD London
    Geschäftsführer
    Apartment 9 Charlesworth House
    48 Stanhope Gardens
    SW7 5RD London
    BritishInsurance Broker74708620005
    PROWSE, John
    317 Ongar Road
    CM15 9HP Brentwood
    Essex
    Geschäftsführer
    317 Ongar Road
    CM15 9HP Brentwood
    Essex
    EnglandBritishManaging Director96786510001
    RECORD, Anthony
    19 Vincent Square
    Westminster
    SW1P 2NA London
    Geschäftsführer
    19 Vincent Square
    Westminster
    SW1P 2NA London
    EnglandBritishDirector31668130002
    SLEETH, Alexander
    25 Wychwood Park
    CW2 5GP Weston
    Cheshire
    Geschäftsführer
    25 Wychwood Park
    CW2 5GP Weston
    Cheshire
    UkBritishDirector84048730002
    SLEETH, Norman
    6 Redbourne Drive
    Wychwood Park
    CW2 5GH Crewe
    Cheshire
    Geschäftsführer
    6 Redbourne Drive
    Wychwood Park
    CW2 5GH Crewe
    Cheshire
    United KingdomBritishCompany Director95565110001
    STEPHENS, Noelyn
    2 Quayside Cottage
    Tinterne
    NP6 6SZ Gwent
    Geschäftsführer
    2 Quayside Cottage
    Tinterne
    NP6 6SZ Gwent
    BritishDirector18846800003
    STOBART, Grant Edwin
    33 Waddling Lane
    Wheathampstead
    AL4 8FD St Albans
    Geschäftsführer
    33 Waddling Lane
    Wheathampstead
    AL4 8FD St Albans
    United KingdomSouth African BritishFinancial Director98434010001
    TATE, Stephen David
    8 Oakfield Avenue
    NP16 5NE Chepstow
    Geschäftsführer
    8 Oakfield Avenue
    NP16 5NE Chepstow
    BritishDirector55781510002
    WALKER, Adrian Peter
    14 Burlington Avenue
    Kew Gardens
    TW9 4DQ Richmond
    Surrey
    Geschäftsführer
    14 Burlington Avenue
    Kew Gardens
    TW9 4DQ Richmond
    Surrey
    EnglandBritishCompany Gardens18474800002
    WALKER, Adrian Peter
    14 Burlington Avenue
    Kew Gardens
    TW9 4DQ Richmond
    Surrey
    Geschäftsführer
    14 Burlington Avenue
    Kew Gardens
    TW9 4DQ Richmond
    Surrey
    EnglandBritishDirector18474800002
    WELLS, David Francis
    Caerphilly Business Park
    CF83 3GG Caerphilly
    Santia House
    Mid Glamorgan
    Wales
    Geschäftsführer
    Caerphilly Business Park
    CF83 3GG Caerphilly
    Santia House
    Mid Glamorgan
    Wales
    United KingdomBritishAccountant104366980002
    WILTSHIER, John Eric Parham
    The Willows Church Lane
    Petham
    CT4 5RD Canterbury
    Kent
    Geschäftsführer
    The Willows Church Lane
    Petham
    CT4 5RD Canterbury
    Kent
    BritishBusiness Management23610100001
    SEVERNSIDE NOMINEES LIMITED
    14-18 City Road
    CF24 3DL Cardiff
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    14-18 City Road
    CF24 3DL Cardiff
    900003980001

    Hat NATIONAL BRITANNIA GROUP LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Mortgage of shares
    Erstellt am 06. Aug. 2009
    Geliefert am 25. Aug. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the shares and interest in the shares including all related rights see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Wilmington Trust (London) Limited as Trustee for the Holders of the Notes (the Security Trustee)
    Transaktionen
    • 25. Aug. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Security agreement
    Erstellt am 06. Aug. 2009
    Geliefert am 25. Aug. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Wilmington Trust (London) Limited as Trustee for the Holders of the Notes (the Security Trustee)
    Transaktionen
    • 25. Aug. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Security agreement
    Erstellt am 10. Juli 2009
    Geliefert am 23. Juli 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any note hedging party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (Note Hedging Security Trustee)
    Transaktionen
    • 23. Juli 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage of shares
    Erstellt am 10. Juli 2009
    Geliefert am 23. Juli 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any note hedging party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first equitable mortgage all the shares owned by the chargor or held by any nominee on its behalf in the share capital of each mortgaged company, including any dividend. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (The Note Hedging Security Trustee)
    Transaktionen
    • 23. Juli 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage of shares
    Erstellt am 15. Nov. 2007
    Geliefert am 04. Dez. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed charge interest in the shares. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 04. Dez. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Security agreement
    Erstellt am 15. Nov. 2007
    Geliefert am 04. Dez. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 04. Dez. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Insurance assignment
    Erstellt am 18. Feb. 2007
    Geliefert am 28. Feb. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any group company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Insurer: legal and general. Life assured alex sleeth. Policy number 011367180-4. sum assured: £1,000,000. term: 3YEARS. Commencement date: 02 september 2005. insurer: legal and general. Life assured adrian walker. Policy number 011367268-7 sum assured: £750,000. term: 3YEARS. Commencement date: 02 september 2005 and all emcumbrances and dispositions.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Feb. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Dez. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of accession
    Erstellt am 29. März 2005
    Geliefert am 08. Apr. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due of any group company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All security interests and dispositions created or made by or pursuant to the debenture. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Dez. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 08. März 2005
    Geliefert am 19. März 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any group company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. März 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Dez. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 27. Sept. 2001
    Geliefert am 02. Okt. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations and liabilities due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee,the stockholder (as defined) or either of them under the instrument (as defined) or certificate evidencing the loan stock (as defined)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Alexander Forbes UK PLC
    Transaktionen
    • 02. Okt. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Okt. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of keyman life policy
    Erstellt am 14. Sept. 2001
    Geliefert am 21. Sept. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    1. the policy (as defined), all sums assured by it and all bonuses and benefits which may arise under it 2. the company's whole right, title and interest present and future in the policy. The policy being:- insurer: norwich union policy no: 7325963EU life assured: stuart epps sum assured £100,000 term of cover: 5 years date of commencement: 27 july 2001.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 21. Sept. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 23. Dez. 1999
    Geliefert am 24. Dez. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 24. Dez. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 14. Feb. 1996
    Geliefert am 20. Feb. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Including trade and tenant's fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 20. Feb. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Okt. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Confirmatory charge
    Erstellt am 06. Apr. 1994
    Geliefert am 22. Apr. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a mortgage debenture dated 4TH december 1992
    Kurze Angaben
    The property and assets of the company as charged by the said mortgage debenture.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Apr. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Apr. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    `E' loan note instrument
    Erstellt am 14. Dez. 1993
    Geliefert am 30. Dez. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of `e' loan note instrument
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Fox Family Partnership
    Transaktionen
    • 30. Dez. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Dez. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 04. Dez. 1992
    Geliefert am 10. Dez. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Dez. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Apr. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    "B" loan note instrument
    Erstellt am 06. Nov. 1992
    Geliefert am 25. Nov. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the "b" loan note instrument
    Kurze Angaben
    (For full details see form 395 tc ref: M7C). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Richard Fox
    Transaktionen
    • 25. Nov. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. März 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    "A" loan note instrument
    Erstellt am 06. Nov. 1992
    Geliefert am 25. Nov. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the "a" loan note instrument
    Kurze Angaben
    (For full details see form 395 tc ref: M6C). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Fox Foundation Partnership
    Transaktionen
    • 25. Nov. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. März 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat NATIONAL BRITANNIA GROUP LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    01. Feb. 2011Beginn der Verwaltung
    30. Apr. 2013Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Richard John Hill
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Richard Heis
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    John David Thomas Milsom
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praktiker
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0