NATIONAL BRITANNIA GROUP LIMITED
Überblick
Unternehmensname | NATIONAL BRITANNIA GROUP LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02747765 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von NATIONAL BRITANNIA GROUP LIMITED?
- (7415) /
Wo befindet sich NATIONAL BRITANNIA GROUP LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | KPMG LLP PO BOX 695 8 Salisbury Square EC4Y 8BB London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von NATIONAL BRITANNIA GROUP LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
CONNAUGHT COMPLIANCE SERVICES GROUP LIMITED | 24. Sept. 2008 | 24. Sept. 2008 |
NATIONAL BRITANNIA GROUP LIMITED | 04. Mai 2000 | 04. Mai 2000 |
NATIONAL BRITANNIA INVESTMENTS LIMITED | 08. Juni 1999 | 08. Juni 1999 |
NATIONAL BRITANNIA GROUP LIMITED | 01. Aug. 1993 | 01. Aug. 1993 |
NATIONAL BRITANNIA LIMITED | 08. Dez. 1992 | 08. Dez. 1992 |
VITAPRIME LIMITED | 16. Sept. 1992 | 16. Sept. 1992 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NATIONAL BRITANNIA GROUP LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Aug. 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für NATIONAL BRITANNIA GROUP LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 19. Apr. 2013 | 20 Seiten | 2.24B | ||
Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 30. Apr. 2013 | 20 Seiten | 2.35B | ||
Mitteilung über die Amtsniederlegung durch den Administrator | 33 Seiten | 2.39B | ||
Mitteilung über die Ernennung eines Ersatz-/Zusatzadministrators | 1 Seiten | 2.40B | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 25. Nov. 2012 | 33 Seiten | 2.24B | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 25. Nov. 2012 | 38 Seiten | 2.24B | ||
Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung | 1 Seiten | 2.31B | ||
Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung | 1 Seiten | 2.31B | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 25. Mai 2012 | 39 Seiten | 2.24B | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 13. Dez. 2011 | 43 Seiten | 2.24B | ||
Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung | 1 Seiten | 2.31B | ||
Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung | 1 Seiten | 2.31B | ||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 31. Juli 2011 | 46 Seiten | 2.24B | ||
Vermögensübersicht mit Formular 2.14B | 7 Seiten | 2.16B | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Kpmg Llp PO Box 695 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB am 11. Mai 2011 | 2 Seiten | AD01 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Santia House Caerphilly Business Park Caerphilly Mid Glamorgan CF83 3GG Wales am 11. Mai 2011 | 2 Seiten | AD01 | ||
Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge | 1 Seiten | F2.18 | ||
Vorschlag des Verwalters | 66 Seiten | 2.17B | ||
Vorschlag des Verwalters | 65 Seiten | 2.17B | ||
Beendigung der Bestellung von Ian Carlisle als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||
Ernennung eines Verwalters | 1 Seiten | 2.12B | ||
Beendigung der Bestellung von Julia Cavanagh als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||
Beendigung der Bestellung von David Wells als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Connaught House Grenadier Road Exeter Business Park Exeter Devon EX1 3QF am 01. Dez. 2010 | 1 Seiten | AD01 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von NATIONAL BRITANNIA GROUP LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAVANAGH, Julia | Sekretär | Grenadier Road Exeter Business Park EX1 3QF Exeter Connaught House Devon | British | 146793110001 | ||||||
DA COSTA, Jean Paul | Sekretär | 2 Vale Court 21 Mallord Street SW3 6AL London | British | 95259980001 | ||||||
LOUDEN, Nicholas William | Sekretär | 11 Heol Y Bont Rhiwbina CF14 6AJ Cardiff South Glamorgan | British | 76293900002 | ||||||
SAUNBY, Kevin David | Sekretär | Rudgwick Westwell Lane Potters Corner TN26 1JA Ashford Kent | British | 18474810005 | ||||||
WELLS, David Francis | Sekretär | Ashley SN13 8AJ Near Box Ashley Farmhouse Wiltshire England | British | Accountant | 104366980002 | |||||
SEVERNSIDE NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 14-18 City Road CF24 3DL Cardiff | 900003980001 | |||||||
BRUCE, Charles | Geschäftsführer | Summerdale 8 Greenway Lane BA2 4LJ Bath | British | Chartered Accountant | 46553680002 | |||||
CARLISLE, Ian | Geschäftsführer | Caerphilly Business Park CF83 3GG Caerphilly Santia House Mid Glamorgan Wales | England | British | Cheif Exceutive | 146715900001 | ||||
DA COSTA, Jean Paul | Geschäftsführer | 2 Vale Court 21 Mallord Street SW3 6AL London | British | Barrister | 95259980001 | |||||
EPPS, Stuart Lewis | Geschäftsführer | 17 Idencroft Close Pontprennau CF23 8PH Cardiff | Wales | Welsh | Financial Director | 76860630003 | ||||
FORD, Peter Michael | Geschäftsführer | White Strake Hawksdown Road Walmer CT14 7PW Deal Kent | England | British | Company Director | 16613000001 | ||||
FOX, Richard | Geschäftsführer | 39 Fairview Avenue Narbarth Pa 19072 Usa | United States | American | Business | 31666810001 | ||||
GIBSON, John | Geschäftsführer | 8 Fairways View Talbot Green Forest Hills Estate CF7 8JG Pontyclun Mid Glamorgan | British | Director | 35357800001 | |||||
HEANEY, Quintin John | Geschäftsführer | Flat 257 County Hall Belvedere Road SE1 7GH London | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 112028430001 | ||||
HILL, Stephen Ronald | Geschäftsführer | Oakfield House Stoke Hill EX4 9JN Exeter Devon | United Kingdom | British | Finance Director | 115233060001 | ||||
HOLROYD, Charles Edward | Geschäftsführer | Colton Lodge Colton LS24 8EL Tadcaster North Yorkshire | British | Chartered Accountant | 1492260001 | |||||
LOUDEN, Nicholas William | Geschäftsführer | 11 Heol Y Bont Rhiwbina CF14 6AJ Cardiff South Glamorgan | Wales | British | Finance Director | 76293900002 | ||||
MATTHEWS, Peter Charles | Geschäftsführer | 33 Tower Close Bassingbourn SG8 5JX Royston Hertfordshire | British | Director | 14571860001 | |||||
PERCY DAVIS, John | Geschäftsführer | Apartment 9 Charlesworth House 48 Stanhope Gardens SW7 5RD London | British | Insurance Broker | 74708620005 | |||||
PERCY DAVIS, John | Geschäftsführer | Apartment 9 Charlesworth House 48 Stanhope Gardens SW7 5RD London | British | Insurance Broker | 74708620005 | |||||
PROWSE, John | Geschäftsführer | 317 Ongar Road CM15 9HP Brentwood Essex | England | British | Managing Director | 96786510001 | ||||
RECORD, Anthony | Geschäftsführer | 19 Vincent Square Westminster SW1P 2NA London | England | British | Director | 31668130002 | ||||
SLEETH, Alexander | Geschäftsführer | 25 Wychwood Park CW2 5GP Weston Cheshire | Uk | British | Director | 84048730002 | ||||
SLEETH, Norman | Geschäftsführer | 6 Redbourne Drive Wychwood Park CW2 5GH Crewe Cheshire | United Kingdom | British | Company Director | 95565110001 | ||||
STEPHENS, Noelyn | Geschäftsführer | 2 Quayside Cottage Tinterne NP6 6SZ Gwent | British | Director | 18846800003 | |||||
STOBART, Grant Edwin | Geschäftsführer | 33 Waddling Lane Wheathampstead AL4 8FD St Albans | United Kingdom | South African British | Financial Director | 98434010001 | ||||
TATE, Stephen David | Geschäftsführer | 8 Oakfield Avenue NP16 5NE Chepstow | British | Director | 55781510002 | |||||
WALKER, Adrian Peter | Geschäftsführer | 14 Burlington Avenue Kew Gardens TW9 4DQ Richmond Surrey | England | British | Company Gardens | 18474800002 | ||||
WALKER, Adrian Peter | Geschäftsführer | 14 Burlington Avenue Kew Gardens TW9 4DQ Richmond Surrey | England | British | Director | 18474800002 | ||||
WELLS, David Francis | Geschäftsführer | Caerphilly Business Park CF83 3GG Caerphilly Santia House Mid Glamorgan Wales | United Kingdom | British | Accountant | 104366980002 | ||||
WILTSHIER, John Eric Parham | Geschäftsführer | The Willows Church Lane Petham CT4 5RD Canterbury Kent | British | Business Management | 23610100001 | |||||
SEVERNSIDE NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 14-18 City Road CF24 3DL Cardiff | 900003980001 |
Hat NATIONAL BRITANNIA GROUP LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Mortgage of shares | Erstellt am 06. Aug. 2009 Geliefert am 25. Aug. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All the shares and interest in the shares including all related rights see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Security agreement | Erstellt am 06. Aug. 2009 Geliefert am 25. Aug. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Security agreement | Erstellt am 10. Juli 2009 Geliefert am 23. Juli 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any note hedging party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage of shares | Erstellt am 10. Juli 2009 Geliefert am 23. Juli 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any note hedging party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first equitable mortgage all the shares owned by the chargor or held by any nominee on its behalf in the share capital of each mortgaged company, including any dividend. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage of shares | Erstellt am 15. Nov. 2007 Geliefert am 04. Dez. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed charge interest in the shares. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Security agreement | Erstellt am 15. Nov. 2007 Geliefert am 04. Dez. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Insurance assignment | Erstellt am 18. Feb. 2007 Geliefert am 28. Feb. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any group company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Insurer: legal and general. Life assured alex sleeth. Policy number 011367180-4. sum assured: £1,000,000. term: 3YEARS. Commencement date: 02 september 2005. insurer: legal and general. Life assured adrian walker. Policy number 011367268-7 sum assured: £750,000. term: 3YEARS. Commencement date: 02 september 2005 and all emcumbrances and dispositions.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of accession | Erstellt am 29. März 2005 Geliefert am 08. Apr. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due of any group company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All security interests and dispositions created or made by or pursuant to the debenture. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 08. März 2005 Geliefert am 19. März 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any group company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite guarantee and debenture | Erstellt am 27. Sept. 2001 Geliefert am 02. Okt. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All obligations and liabilities due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee,the stockholder (as defined) or either of them under the instrument (as defined) or certificate evidencing the loan stock (as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Assignment of keyman life policy | Erstellt am 14. Sept. 2001 Geliefert am 21. Sept. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 1. the policy (as defined), all sums assured by it and all bonuses and benefits which may arise under it 2. the company's whole right, title and interest present and future in the policy. The policy being:- insurer: norwich union policy no: 7325963EU life assured: stuart epps sum assured £100,000 term of cover: 5 years date of commencement: 27 july 2001. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 23. Dez. 1999 Geliefert am 24. Dez. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 14. Feb. 1996 Geliefert am 20. Feb. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Including trade and tenant's fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Confirmatory charge | Erstellt am 06. Apr. 1994 Geliefert am 22. Apr. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a mortgage debenture dated 4TH december 1992 | |
Kurze Angaben The property and assets of the company as charged by the said mortgage debenture. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
`E' loan note instrument | Erstellt am 14. Dez. 1993 Geliefert am 30. Dez. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of `e' loan note instrument | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 04. Dez. 1992 Geliefert am 10. Dez. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
"B" loan note instrument | Erstellt am 06. Nov. 1992 Geliefert am 25. Nov. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the "b" loan note instrument | |
Kurze Angaben (For full details see form 395 tc ref: M7C). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
"A" loan note instrument | Erstellt am 06. Nov. 1992 Geliefert am 25. Nov. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the "a" loan note instrument | |
Kurze Angaben (For full details see form 395 tc ref: M6C). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat NATIONAL BRITANNIA GROUP LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| In Verwaltung |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0