MBG INTERNATIONAL LTD.
Überblick
| Unternehmensname | MBG INTERNATIONAL LTD. |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02747938 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MBG INTERNATIONAL LTD.?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich MBG INTERNATIONAL LTD.?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 47 Homefield Road Chiswalk W4 2LW London Uk |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von MBG INTERNATIONAL LTD.?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| TRIO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 02. Okt. 1992 | 02. Okt. 1992 |
| LAWGRA (NO. 172) LIMITED | 16. Sept. 1992 | 16. Sept. 1992 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MBG INTERNATIONAL LTD.?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2014 |
Welche sind die letzten Einreichungen für MBG INTERNATIONAL LTD.?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 16. Sept. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2014 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Cannon Bridge 25 Dowgate Hill London EC4R 2BB zum 47 Homefield Road Chiswalk London Uk W4 2LW am 30. Mai 2015 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Verschiedenes Aud res section 519 CA2006 | 3 Seiten | MISC | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Eamonn William Bradley als Sekretär am 03. Dez. 2014 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Eamonn William Bradley als Geschäftsführer am 03. Dez. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 16. Sept. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2013 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Eintragung der Belastung 027479380009 | 20 Seiten | MR01 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 027479380008 | 29 Seiten | MR01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 16. Sept. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2012 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Alan Farnan als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Caplin als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Stephen Welch als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Eamonn William Bradley als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Eamonn William Bradley als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jeremy Kraft als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jeremy Kraft als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 16. Sept. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2011 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 16. Sept. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2010 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von MBG INTERNATIONAL LTD.?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WELCH, Stephen | Geschäftsführer | Homefield Road Chiswalk W4 2LW London 47 Uk | England | Australian | 179384770001 | |||||
| BRADLEY, Eamonn William | Sekretär | Cannon Bridge 25 Dowgate Hill EC4R 2BB London | 177013070001 | |||||||
| KRAFT, Jeremy David | Sekretär | 27 Avenue Gardens TW11 0BH Teddington Middlesex | British | 71360190003 | ||||||
| THOMSON, John Stewart | Sekretär | 9 Upper Lattimore Road AL1 3UD St Albans Hertfordshire | British | 1644180002 | ||||||
| LAWGRAM SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | More London Riverside SE1 2AU London 4 | 900004760001 | |||||||
| BRADLEY, Eamonn William | Geschäftsführer | Cannon Bridge 25 Dowgate Hill EC4R 2BB London | United Kingdom | British | 177008470001 | |||||
| CAPLIN, David Simon Montfort | Geschäftsführer | 519 Ben Johnson House Barbican EC2Q 8DL London | England | British | 104626850001 | |||||
| CLARKE, Matthew James Stanhope | Geschäftsführer | 22 Hazlitt Road W14 0JY London | England | British | 52586600001 | |||||
| FARNAN, Alan Martin | Geschäftsführer | 14 Roganstown Golf And Country Club Roganstown IRISH Swords County Dublin | Ireland | Irish | 88410720002 | |||||
| HAGAN, David Lloyd | Geschäftsführer | Eastwoods Pitmore Lane SO41 6BW Sway Hampshire | United Kingdom | British | 50541510001 | |||||
| KRAFT, Jeremy David | Geschäftsführer | 27 Avenue Gardens TW11 0BH Teddington Middlesex | United Kingdom | British | 71360190003 | |||||
| MOORE, Christopher Hodgson | Geschäftsführer | 8 Hammersmith Terrace W6 9TS London | England | English | 5345930001 | |||||
| MOORE, Peter David | Geschäftsführer | Glen House Deepdene Wood RH5 4BQ Dorking Surrey | United Kingdom | British | 1644210001 | |||||
| SPENCE, Christopher John | Geschäftsführer | Chieveley Manor Church Lane Chieveley RG20 8UT Newbury Berkshire | United Kingdom | British | 3558990001 | |||||
| THOMSON, John Stewart | Geschäftsführer | 9 Upper Lattimore Road AL1 3UD St Albans Hertfordshire | United Kingdom | British | 1644180002 | |||||
| TURNER, Nicholas Spencer | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Flat 6 53 Shepherds Hill Highgate N6 5QP London | British | 900005470001 |
Hat MBG INTERNATIONAL LTD. Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 29. Apr. 2014 Geliefert am 15. Mai 2014 | Ausstehend | ||
Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 29. Apr. 2014 Geliefert am 06. Mai 2014 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung 1. all registered or unregistered estates and interests in freehold and leasehold properties now or in the future owned by the obligors (as defined in the charge document) or in which the obligors have an interest from time to time; and. 2. any present or future interests (whether legal or equitable, and including the benefit of all licences) relating to any registered or unregistered trade marks, patents, copyrights, design rights, domain names, business names, confidential information, know-how and other intellectual property rights together with the rights to use any of the foregoing. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of pledge | Erstellt am 09. Apr. 2008 Geliefert am 15. Apr. 2008 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or the borrowers to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All the issued sahres being 36,400 shares of 1 each together with all future shares together with rights attaching to those shares see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and share pledge | Erstellt am 17. März 2008 Geliefert am 25. März 2008 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or the principal borrower to the chargee on any account whatsoevr | |
Kurze Angaben The shares together with all rights including dividends and other distributions arising in relation thereto. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debentures | Erstellt am 17. März 2008 Geliefert am 25. März 2008 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and share pledge | Erstellt am 16. Juli 2007 Geliefert am 18. Juli 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Assigned all of the company's rights, title and interest, present and future, to receive money which may become payable pursuant to the share purchase agreement pledged the shares togther with all rights, including dividends and other distributions, arising in relation thereto. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Accession agreement to the debenture | Erstellt am 27. Juni 2005 Geliefert am 07. Juli 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the principals (or any of them) to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Accession agreement relating to composite guarantee and debenture dated 11 march 2005 | Erstellt am 27. Juni 2005 Geliefert am 02. Juli 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due by the principals or any of them to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 10. Juni 2005 Geliefert am 16. Juni 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due by the principals (or any of them) to the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0