MBG INTERNATIONAL LTD.

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMBG INTERNATIONAL LTD.
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02747938
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MBG INTERNATIONAL LTD.?

    • Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich MBG INTERNATIONAL LTD.?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    47 Homefield Road
    Chiswalk
    W4 2LW London
    Uk
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von MBG INTERNATIONAL LTD.?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    TRIO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED02. Okt. 199202. Okt. 1992
    LAWGRA (NO. 172) LIMITED16. Sept. 199216. Sept. 1992

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MBG INTERNATIONAL LTD.?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2014

    Welche sind die letzten Einreichungen für MBG INTERNATIONAL LTD.?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Jahresrückblick erstellt bis 16. Sept. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital22. Okt. 2015

    Kapitalaufstellung am 22. Okt. 2015

    • Kapital: GBP 3,000,000
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2014

    3 SeitenAA

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Cannon Bridge 25 Dowgate Hill London EC4R 2BB zum 47 Homefield Road Chiswalk London Uk W4 2LW am 30. Mai 2015

    2 SeitenAD01

    Verschiedenes

    Aud res section 519 CA2006
    3 SeitenMISC

    Beendigung der Bestellung von Eamonn William Bradley als Sekretär am 03. Dez. 2014

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Eamonn William Bradley als Geschäftsführer am 03. Dez. 2014

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 16. Sept. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital29. Okt. 2014

    Kapitalaufstellung am 29. Okt. 2014

    • Kapital: GBP 3,000,000
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2013

    15 SeitenAA

    Eintragung der Belastung 027479380009

    20 SeitenMR01

    Eintragung der Belastung 027479380008

    29 SeitenMR01

    Jahresrückblick erstellt bis 16. Sept. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital15. Okt. 2013

    Kapitalaufstellung am 15. Okt. 2013

    • Kapital: GBP 3,000,000
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2012

    14 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Alan Farnan als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von David Caplin als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Stephen Welch als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Eamonn William Bradley als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Eamonn William Bradley als Sekretär

    1 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Jeremy Kraft als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Jeremy Kraft als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Jahresrückblick erstellt bis 16. Sept. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2011

    13 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 16. Sept. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2010

    13 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von MBG INTERNATIONAL LTD.?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    WELCH, Stephen
    Homefield Road
    Chiswalk
    W4 2LW London
    47
    Uk
    Geschäftsführer
    Homefield Road
    Chiswalk
    W4 2LW London
    47
    Uk
    EnglandAustralian179384770001
    BRADLEY, Eamonn William
    Cannon Bridge
    25 Dowgate Hill
    EC4R 2BB London
    Sekretär
    Cannon Bridge
    25 Dowgate Hill
    EC4R 2BB London
    177013070001
    KRAFT, Jeremy David
    27 Avenue Gardens
    TW11 0BH Teddington
    Middlesex
    Sekretär
    27 Avenue Gardens
    TW11 0BH Teddington
    Middlesex
    British71360190003
    THOMSON, John Stewart
    9 Upper Lattimore Road
    AL1 3UD St Albans
    Hertfordshire
    Sekretär
    9 Upper Lattimore Road
    AL1 3UD St Albans
    Hertfordshire
    British1644180002
    LAWGRAM SECRETARIES LIMITED
    More London Riverside
    SE1 2AU London
    4
    Bevollmächtigter Sekretär
    More London Riverside
    SE1 2AU London
    4
    900004760001
    BRADLEY, Eamonn William
    Cannon Bridge
    25 Dowgate Hill
    EC4R 2BB London
    Geschäftsführer
    Cannon Bridge
    25 Dowgate Hill
    EC4R 2BB London
    United KingdomBritish177008470001
    CAPLIN, David Simon Montfort
    519 Ben Johnson House
    Barbican
    EC2Q 8DL London
    Geschäftsführer
    519 Ben Johnson House
    Barbican
    EC2Q 8DL London
    EnglandBritish104626850001
    CLARKE, Matthew James Stanhope
    22 Hazlitt Road
    W14 0JY London
    Geschäftsführer
    22 Hazlitt Road
    W14 0JY London
    EnglandBritish52586600001
    FARNAN, Alan Martin
    14 Roganstown Golf And Country Club
    Roganstown
    IRISH Swords
    County Dublin
    Geschäftsführer
    14 Roganstown Golf And Country Club
    Roganstown
    IRISH Swords
    County Dublin
    IrelandIrish88410720002
    HAGAN, David Lloyd
    Eastwoods
    Pitmore Lane
    SO41 6BW Sway
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Eastwoods
    Pitmore Lane
    SO41 6BW Sway
    Hampshire
    United KingdomBritish50541510001
    KRAFT, Jeremy David
    27 Avenue Gardens
    TW11 0BH Teddington
    Middlesex
    Geschäftsführer
    27 Avenue Gardens
    TW11 0BH Teddington
    Middlesex
    United KingdomBritish71360190003
    MOORE, Christopher Hodgson
    8 Hammersmith Terrace
    W6 9TS London
    Geschäftsführer
    8 Hammersmith Terrace
    W6 9TS London
    EnglandEnglish5345930001
    MOORE, Peter David
    Glen House
    Deepdene Wood
    RH5 4BQ Dorking
    Surrey
    Geschäftsführer
    Glen House
    Deepdene Wood
    RH5 4BQ Dorking
    Surrey
    United KingdomBritish1644210001
    SPENCE, Christopher John
    Chieveley Manor Church Lane
    Chieveley
    RG20 8UT Newbury
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Chieveley Manor Church Lane
    Chieveley
    RG20 8UT Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish3558990001
    THOMSON, John Stewart
    9 Upper Lattimore Road
    AL1 3UD St Albans
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    9 Upper Lattimore Road
    AL1 3UD St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritish1644180002
    TURNER, Nicholas Spencer
    Flat 6 53 Shepherds Hill
    Highgate
    N6 5QP London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Flat 6 53 Shepherds Hill
    Highgate
    N6 5QP London
    British900005470001

    Hat MBG INTERNATIONAL LTD. Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 29. Apr. 2014
    Geliefert am 15. Mai 2014
    Ausstehend
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Sns Portfolio Limited
    Transaktionen
    • 15. Mai 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 29. Apr. 2014
    Geliefert am 06. Mai 2014
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    1. all registered or unregistered estates and interests in freehold and leasehold properties now or in the future owned by the obligors (as defined in the charge document) or in which the obligors have an interest from time to time; and. 2. any present or future interests (whether legal or equitable, and including the benefit of all licences) relating to any registered or unregistered trade marks, patents, copyrights, design rights, domain names, business names, confidential information, know-how and other intellectual property rights together with the rights to use any of the foregoing.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Sns Portfolio Limited
    Transaktionen
    • 06. Mai 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    Deed of pledge
    Erstellt am 09. Apr. 2008
    Geliefert am 15. Apr. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or the borrowers to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the issued sahres being 36,400 shares of 1 each together with all future shares together with rights attaching to those shares see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 15. Apr. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Guarantee and share pledge
    Erstellt am 17. März 2008
    Geliefert am 25. März 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or the principal borrower to the chargee on any account whatsoevr
    Kurze Angaben
    The shares together with all rights including dividends and other distributions arising in relation thereto.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 25. März 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Composite guarantee and debentures
    Erstellt am 17. März 2008
    Geliefert am 25. März 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 25. März 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Guarantee and share pledge
    Erstellt am 16. Juli 2007
    Geliefert am 18. Juli 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Assigned all of the company's rights, title and interest, present and future, to receive money which may become payable pursuant to the share purchase agreement pledged the shares togther with all rights, including dividends and other distributions, arising in relation thereto.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee (The "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 18. Juli 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Accession agreement to the debenture
    Erstellt am 27. Juni 2005
    Geliefert am 07. Juli 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the principals (or any of them) to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Gresham LLP (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 07. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Accession agreement relating to composite guarantee and debenture dated 11 march 2005
    Erstellt am 27. Juni 2005
    Geliefert am 02. Juli 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due by the principals or any of them to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • All Monies Due or to Become Due by the Principals or Any of Them to the Secured Parties on Any Whatsoever
    Transaktionen
    • 02. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 10. Juni 2005
    Geliefert am 16. Juni 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due by the principals (or any of them) to the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee (For the Secured Parties)
    Transaktionen
    • 16. Juni 2005Registrierung einer Belastung (395)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0