THE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED

THE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTHE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02748038
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von THE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich THE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Marstons House
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    West Midlands
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von THE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis02. Okt. 2021

    Welche sind die letzten Einreichungen für THE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    2 SeitenDS01

    Kapitalaufstellung am 07. Sept. 2022

    • Kapital: GBP 1
    3 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Cancel share premium account 05/09/2022
    RES13
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 05. Sept. 2022

    • Kapital: GBP 874,158
    3 SeitenSH01

    Bestätigungserklärung erstellt am 27. Juni 2022 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 02. Okt. 2021

    8 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Anne Marie Brennan als Sekretär am 05. Okt. 2021

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Mrs Michelle Louise Woodall als Sekretär am 05. Okt. 2021

    2 SeitenAP03

    Ernennung von Edward Hancock als Direktor am 05. Okt. 2021

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Robert Anthony Leach als Direktor am 05. Okt. 2021

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mrs Hayleigh Lupino als Direktor am 05. Okt. 2021

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Ralph Graham Findlay als Geschäftsführer am 02. Okt. 2021

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 27. Juni 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 03. Okt. 2020

    8 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Richard James Westwood als Geschäftsführer am 30. Okt. 2020

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 27. Juni 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 28. Sept. 2019

    8 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 27. Juni 2019 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 29. Sept. 2018

    8 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 27. Juni 2018 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2017

    8 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von THE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    WOODALL, Michelle Louise
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    Sekretär
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    288186710001
    ANDREA, Andrew Andonis
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    West Midlands
    EnglandBritishCompany Director137383120001
    HANCOCK, Edward John
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Surveyor288133210001
    LEACH, Robert Anthony
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    United KingdomBritishHead Of Treasury194085550001
    LUPINO, Hayleigh
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director207826950002
    ADAMS, Paul Francis
    Thurston House
    Weston Road
    BA1 2XU Bath
    Sekretär
    Thurston House
    Weston Road
    BA1 2XU Bath
    British125526410001
    BIRCH, James
    7 Woods Close
    Sherston
    SN16 0LF Malmesbury
    Wiltshire
    Sekretär
    7 Woods Close
    Sherston
    SN16 0LF Malmesbury
    Wiltshire
    BritishDirector116449180001
    BRENNAN, Anne Marie
    Marston's House
    WV1 4JT Wolverhampton
    West Midlands
    Sekretär
    Marston's House
    WV1 4JT Wolverhampton
    West Midlands
    BritishCompany Secretary109935620001
    BRYAN, Nicholas George
    8 The Breach
    SN10 5BJ Devizes
    Wiltshire
    Sekretär
    8 The Breach
    SN10 5BJ Devizes
    Wiltshire
    BritishCompany Director65460520003
    SHAH, Vimal
    9 Southfield Road
    Chiswick
    W4 1AG London
    Sekretär
    9 Southfield Road
    Chiswick
    W4 1AG London
    British4692040001
    WEST, Alan
    29 Oak Manor Drive
    GL52 6SZ Cheltenham
    Gloucestershire
    Sekretär
    29 Oak Manor Drive
    GL52 6SZ Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishFinancial Controller111318570001
    BONDLAW SECRETARIES LIMITED
    39-49 Commercial Road
    SO15 1GA Southampton
    Hampshire
    Sekretär
    39-49 Commercial Road
    SO15 1GA Southampton
    Hampshire
    106817380001
    ADAMS, Paul Francis
    Thurston House
    Weston Road
    BA1 2XU Bath
    Geschäftsführer
    Thurston House
    Weston Road
    BA1 2XU Bath
    EnglandBritishChartered Accountant125526410001
    ANDREW, Derek
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    West Midlands
    BritishCompany Director39071260003
    BIRCH, James
    7 Woods Close
    Sherston
    SN16 0LF Malmesbury
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    7 Woods Close
    Sherston
    SN16 0LF Malmesbury
    Wiltshire
    BritishDirector116449180001
    BRYAN, Nicholas George
    8 The Breach
    SN10 5BJ Devizes
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    8 The Breach
    SN10 5BJ Devizes
    Wiltshire
    EnglandBritishCompany Director65460520003
    CHOWDHARY, Balvinder Kaur
    112 Park Road
    Hampton Hill
    TW12 1HR Hampton
    Middlesex
    Geschäftsführer
    112 Park Road
    Hampton Hill
    TW12 1HR Hampton
    Middlesex
    EnglandBritishCompany Registration Agent4672940001
    COYLE, James Arthur
    Glen Ruther College Road
    Denstone
    ST14 5HR Uttoxeter
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Glen Ruther College Road
    Denstone
    ST14 5HR Uttoxeter
    Staffordshire
    BritishSales Director63364040001
    DALZELL, Peter
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director163616170001
    DARBY, Alistair William
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    West Midlands
    BritishCompany Director87846880002
    DAVIES, Martin William Oliver
    Dancing Waters
    The Friary
    SL4 2NS Old Windsor
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Dancing Waters
    The Friary
    SL4 2NS Old Windsor
    Berkshire
    BritishManaging Director40444030001
    DENNING, Roland John
    Swallowfield Grange
    The Street
    RG7 1RE Swallowfield
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Swallowfield Grange
    The Street
    RG7 1RE Swallowfield
    Berkshire
    EnglandBritishCompany Director95991510001
    FINDLAY, Ralph Graham
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marstons House
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marstons House
    West Midlands
    EnglandBritishCompany Director129897400001
    GRACE, David Allen
    Lark Rise Home Farm Court
    East End Adderbury
    OX17 3NW Banbury
    Oxon
    Geschäftsführer
    Lark Rise Home Farm Court
    East End Adderbury
    OX17 3NW Banbury
    Oxon
    BritishCompany Director67926560001
    HAWTHORN, Stuart John
    3 Rutherford Close
    OX14 2AT Abingdon
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    3 Rutherford Close
    OX14 2AT Abingdon
    Oxfordshire
    BritishDirector82240190001
    INGLETT, Paul
    Marston's House
    WV1 4JT Wolverhampton
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Marston's House
    WV1 4JT Wolverhampton
    West Midlands
    BritishCompany Director81617110002
    LUSCOMBE, Richard William
    Lauriston House
    Town Barton, Norton St. Philip
    BA2 7LN Bath
    Avon
    Geschäftsführer
    Lauriston House
    Town Barton, Norton St. Philip
    BA2 7LN Bath
    Avon
    BritishCompany Director70464690001
    MOSS, Arthur Christopher
    80 Bridge Street
    OX2 0BD Oxford
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    80 Bridge Street
    OX2 0BD Oxford
    Oxfordshire
    BritishBrewer30700880001
    OLIVER, Stephen John
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    West Midlands
    BritishCompany Director66123690003
    ROGERS, Ian
    17 Burcott Park
    Burcott
    OX14 3DH Abingdon
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    17 Burcott Park
    Burcott
    OX14 3DH Abingdon
    Oxfordshire
    BritishManaging Director30700870003
    THOMPSON, Rupert Geoffrey Ryland
    The Hermitage
    RG17 0HA Hungerford
    Berks
    Geschäftsführer
    The Hermitage
    RG17 0HA Hungerford
    Berks
    EnglandBritishCompany Director30939200001
    WESTWOOD, Richard James
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director314691870001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei THE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    Brewery Road
    WV1 4JT Wolverhampton
    Marston's House
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandUnited Kingdom
    RechtsgrundlageUnited Kingdom
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer03981399
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat THE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Erstellt am 08. Juli 2002
    Geliefert am 09. Juli 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD (the Security Holder)
    Transaktionen
    • 09. Juli 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 12. Juni 2002
    Geliefert am 14. Juni 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Juni 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Nov. 2002Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    Debenture
    Erstellt am 29. Okt. 1999
    Geliefert am 10. Nov. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Nov. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Dez. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 19. Jan. 1998
    Geliefert am 22. Jan. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Jan. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Dez. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Book debts debenture
    Erstellt am 28. Okt. 1996
    Geliefert am 30. Okt. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    First fixed charge on all book debts and other debts of the company both present and future save for those book debts and other debts sold by the company and purchased by the chargee under an invoice discounting agreement and not purchased pursuant to the provisions thereof.
    Berechtigte Personen
    • New Court Commercial Finance Limited
    Transaktionen
    • 30. Okt. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Feb. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 10. Apr. 1995
    Geliefert am 19. Apr. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    Leasehold property known as units 10 and 11 eagle industrial estate the crofts witney oxfordshire title number ON172245 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Apr. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Aug. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 10. Apr. 1995
    Geliefert am 19. Apr. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    Leasehold property known as unit 12 eagle industrial estate witney oxfordshire title number ON169190 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Apr. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Aug. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Collateral debenture
    Erstellt am 17. Okt. 1994
    Geliefert am 21. Okt. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from hobgoblinns limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • 3I Group PLC
    Transaktionen
    • 21. Okt. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Dez. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Counterpart rent deposit deed
    Erstellt am 11. Aug. 1994
    Geliefert am 12. Aug. 1994
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or hobgoblinns limited to the chargee under the terms of a lease dated 11TH august 1994 and this deed
    Kurze Angaben
    £1066 or one quarter of the annual rent from time to time payable under the said lease dated 11TH august 1994 (whichever shall be the greater) together with a sum equivalent to the rate of V.A.T. currently charged on rent.
    Berechtigte Personen
    • Hambridge Investments (Newbury) Limited
    Transaktionen
    • 12. Aug. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed incorporating charge
    Erstellt am 12. Mai 1994
    Geliefert am 13. Mai 1994
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or hobgoblinns limited to the chargee under the terms of the lease dated 12TH may 1994.
    Kurze Angaben
    £5,529 and all other monies deposited in the deposit account at lloyds bank PLC in the name of the chargee.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hambridge Investments (Newbury) Limited
    Transaktionen
    • 13. Mai 1994Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 01. Juli 1993
    Geliefert am 08. Juli 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Juli 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Juni 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 24. Juni 1993
    Geliefert am 07. Juli 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H-unit 9B two rivers industrial estate station lane witney oxfordshire. T/n-ON111965 and ON139732 and/or the proceeds of sale thereof and assigns the goodwill of the business and the full benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Juli 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Aug. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0