THE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED
Überblick
Unternehmensname | THE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02748038 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von THE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich THE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Marstons House Brewery Road WV1 4JT Wolverhampton West Midlands |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von THE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 02. Okt. 2021 |
Welche sind die letzten Einreichungen für THE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 2 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 07. Sept. 2022
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 05. Sept. 2022
| 3 Seiten | SH01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 27. Juni 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 02. Okt. 2021 | 8 Seiten | AA | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Anne Marie Brennan als Sekretär am 05. Okt. 2021 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Ernennung von Mrs Michelle Louise Woodall als Sekretär am 05. Okt. 2021 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||||||
Ernennung von Edward Hancock als Direktor am 05. Okt. 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Ernennung von Robert Anthony Leach als Direktor am 05. Okt. 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mrs Hayleigh Lupino als Direktor am 05. Okt. 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ralph Graham Findlay als Geschäftsführer am 02. Okt. 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 27. Juni 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 03. Okt. 2020 | 8 Seiten | AA | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard James Westwood als Geschäftsführer am 30. Okt. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 27. Juni 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 28. Sept. 2019 | 8 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 27. Juni 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 29. Sept. 2018 | 8 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 27. Juni 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2017 | 8 Seiten | AA | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von THE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOODALL, Michelle Louise | Sekretär | Brewery Road WV1 4JT Wolverhampton Marston's House United Kingdom | 288186710001 | |||||||
ANDREA, Andrew Andonis | Geschäftsführer | Brewery Road WV1 4JT Wolverhampton Marston's House West Midlands | England | British | Company Director | 137383120001 | ||||
HANCOCK, Edward John | Geschäftsführer | Brewery Road WV1 4JT Wolverhampton Marston's House United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 288133210001 | ||||
LEACH, Robert Anthony | Geschäftsführer | Brewery Road WV1 4JT Wolverhampton Marston's House United Kingdom | United Kingdom | British | Head Of Treasury | 194085550001 | ||||
LUPINO, Hayleigh | Geschäftsführer | Brewery Road WV1 4JT Wolverhampton Marston's House United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 207826950002 | ||||
ADAMS, Paul Francis | Sekretär | Thurston House Weston Road BA1 2XU Bath | British | 125526410001 | ||||||
BIRCH, James | Sekretär | 7 Woods Close Sherston SN16 0LF Malmesbury Wiltshire | British | Director | 116449180001 | |||||
BRENNAN, Anne Marie | Sekretär | Marston's House WV1 4JT Wolverhampton West Midlands | British | Company Secretary | 109935620001 | |||||
BRYAN, Nicholas George | Sekretär | 8 The Breach SN10 5BJ Devizes Wiltshire | British | Company Director | 65460520003 | |||||
SHAH, Vimal | Sekretär | 9 Southfield Road Chiswick W4 1AG London | British | 4692040001 | ||||||
WEST, Alan | Sekretär | 29 Oak Manor Drive GL52 6SZ Cheltenham Gloucestershire | British | Financial Controller | 111318570001 | |||||
BONDLAW SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 39-49 Commercial Road SO15 1GA Southampton Hampshire | 106817380001 | |||||||
ADAMS, Paul Francis | Geschäftsführer | Thurston House Weston Road BA1 2XU Bath | England | British | Chartered Accountant | 125526410001 | ||||
ANDREW, Derek | Geschäftsführer | Brewery Road WV1 4JT Wolverhampton Marston's House West Midlands | British | Company Director | 39071260003 | |||||
BIRCH, James | Geschäftsführer | 7 Woods Close Sherston SN16 0LF Malmesbury Wiltshire | British | Director | 116449180001 | |||||
BRYAN, Nicholas George | Geschäftsführer | 8 The Breach SN10 5BJ Devizes Wiltshire | England | British | Company Director | 65460520003 | ||||
CHOWDHARY, Balvinder Kaur | Geschäftsführer | 112 Park Road Hampton Hill TW12 1HR Hampton Middlesex | England | British | Company Registration Agent | 4672940001 | ||||
COYLE, James Arthur | Geschäftsführer | Glen Ruther College Road Denstone ST14 5HR Uttoxeter Staffordshire | British | Sales Director | 63364040001 | |||||
DALZELL, Peter | Geschäftsführer | Brewery Road WV1 4JT Wolverhampton Marston's House United Kingdom | England | British | Company Director | 163616170001 | ||||
DARBY, Alistair William | Geschäftsführer | Brewery Road WV1 4JT Wolverhampton Marston's House West Midlands | British | Company Director | 87846880002 | |||||
DAVIES, Martin William Oliver | Geschäftsführer | Dancing Waters The Friary SL4 2NS Old Windsor Berkshire | British | Managing Director | 40444030001 | |||||
DENNING, Roland John | Geschäftsführer | Swallowfield Grange The Street RG7 1RE Swallowfield Berkshire | England | British | Company Director | 95991510001 | ||||
FINDLAY, Ralph Graham | Geschäftsführer | Brewery Road WV1 4JT Wolverhampton Marstons House West Midlands | England | British | Company Director | 129897400001 | ||||
GRACE, David Allen | Geschäftsführer | Lark Rise Home Farm Court East End Adderbury OX17 3NW Banbury Oxon | British | Company Director | 67926560001 | |||||
HAWTHORN, Stuart John | Geschäftsführer | 3 Rutherford Close OX14 2AT Abingdon Oxfordshire | British | Director | 82240190001 | |||||
INGLETT, Paul | Geschäftsführer | Marston's House WV1 4JT Wolverhampton West Midlands | British | Company Director | 81617110002 | |||||
LUSCOMBE, Richard William | Geschäftsführer | Lauriston House Town Barton, Norton St. Philip BA2 7LN Bath Avon | British | Company Director | 70464690001 | |||||
MOSS, Arthur Christopher | Geschäftsführer | 80 Bridge Street OX2 0BD Oxford Oxfordshire | British | Brewer | 30700880001 | |||||
OLIVER, Stephen John | Geschäftsführer | Brewery Road WV1 4JT Wolverhampton Marston's House West Midlands | British | Company Director | 66123690003 | |||||
ROGERS, Ian | Geschäftsführer | 17 Burcott Park Burcott OX14 3DH Abingdon Oxfordshire | British | Managing Director | 30700870003 | |||||
THOMPSON, Rupert Geoffrey Ryland | Geschäftsführer | The Hermitage RG17 0HA Hungerford Berks | England | British | Company Director | 30939200001 | ||||
WESTWOOD, Richard James | Geschäftsführer | Brewery Road WV1 4JT Wolverhampton Marston's House United Kingdom | England | British | Company Director | 314691870001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei THE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Refresh Group Limited | 06. Apr. 2016 | Brewery Road WV1 4JT Wolverhampton Marston's House United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat THE WYCHWOOD BREWERY COMPANY LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Fixed charge on purchased debts which fail to vest | Erstellt am 08. Juli 2002 Geliefert am 09. Juli 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 12. Juni 2002 Geliefert am 14. Juni 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 29. Okt. 1999 Geliefert am 10. Nov. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 19. Jan. 1998 Geliefert am 22. Jan. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Book debts debenture | Erstellt am 28. Okt. 1996 Geliefert am 30. Okt. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben First fixed charge on all book debts and other debts of the company both present and future save for those book debts and other debts sold by the company and purchased by the chargee under an invoice discounting agreement and not purchased pursuant to the provisions thereof. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 10. Apr. 1995 Geliefert am 19. Apr. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben Leasehold property known as units 10 and 11 eagle industrial estate the crofts witney oxfordshire title number ON172245 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 10. Apr. 1995 Geliefert am 19. Apr. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben Leasehold property known as unit 12 eagle industrial estate witney oxfordshire title number ON169190 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Collateral debenture | Erstellt am 17. Okt. 1994 Geliefert am 21. Okt. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from hobgoblinns limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Counterpart rent deposit deed | Erstellt am 11. Aug. 1994 Geliefert am 12. Aug. 1994 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or hobgoblinns limited to the chargee under the terms of a lease dated 11TH august 1994 and this deed | |
Kurze Angaben £1066 or one quarter of the annual rent from time to time payable under the said lease dated 11TH august 1994 (whichever shall be the greater) together with a sum equivalent to the rate of V.A.T. currently charged on rent. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Rent deposit deed incorporating charge | Erstellt am 12. Mai 1994 Geliefert am 13. Mai 1994 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or hobgoblinns limited to the chargee under the terms of the lease dated 12TH may 1994. | |
Kurze Angaben £5,529 and all other monies deposited in the deposit account at lloyds bank PLC in the name of the chargee.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 01. Juli 1993 Geliefert am 08. Juli 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 24. Juni 1993 Geliefert am 07. Juli 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H-unit 9B two rivers industrial estate station lane witney oxfordshire. T/n-ON111965 and ON139732 and/or the proceeds of sale thereof and assigns the goodwill of the business and the full benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0