DUNHAM ASSET MANAGEMENT LIMITED

DUNHAM ASSET MANAGEMENT LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameDUNHAM ASSET MANAGEMENT LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02752310
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von DUNHAM ASSET MANAGEMENT LIMITED?

    • Finanzintermediation sonst. n.n.a. (64999) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

    Wo befindet sich DUNHAM ASSET MANAGEMENT LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    20 Market Street
    WA14 1PF Altrincham
    Cheshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von DUNHAM ASSET MANAGEMENT LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ACTIONSTEP LIMITED01. Okt. 199201. Okt. 1992

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von DUNHAM ASSET MANAGEMENT LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2023

    Welche sind die letzten Einreichungen für DUNHAM ASSET MANAGEMENT LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    2 SeitenDS01
    XCU103M9

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2023

    8 SeitenAA
    XCE22PRV

    Bestätigungserklärung erstellt am 13. Sept. 2023 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01
    XCC1413D

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2022

    10 SeitenAA
    XBHDN88Q

    Bestätigungserklärung erstellt am 13. Sept. 2022 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01
    XBCGCOYG

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2021

    10 SeitenAA
    XB79H21F

    Bestätigungserklärung erstellt am 13. Sept. 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01
    XAD8304B

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2020

    10 SeitenAA
    X9JVRA8B

    Bestätigungserklärung erstellt am 13. Sept. 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01
    X9DKVNOG

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2019

    11 SeitenAA
    X8YI0FEI

    Bestätigungserklärung erstellt am 13. Sept. 2019 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01
    X8E4CPP4

    Gesellschaftsvertrag und Satzung

    19 SeitenMA
    R85LBDHC

    Beschlüsse

    Resolutions
    4 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Zuteilung von Wertpapieren

    RES10
    capital

    Beschluss zur Änderung der Aktienrechte oder der Bezeichnung

    RES12
    incorporation

    Beschluss zur Änderung der Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Erklärung der Unternehmensgegenstände

    2 SeitenCC04
    A85LJTQY

    Änderung der Bezeichnung der Aktienklasse

    2 SeitenSH08
    A85LJTRE

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2018

    11 SeitenAA
    X7K56W14

    Bestätigungserklärung erstellt am 13. Sept. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01
    X7ETG92H

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2017

    11 SeitenAA
    A6XZUDVM

    Ernennung von Gillian Linda Mcgarey als Direktor am 11. Dez. 2017

    2 SeitenAP01
    X6LKESU2

    Ernennung von Lisa Jane Rita Smith als Direktor am 11. Dez. 2017

    2 SeitenAP01
    X6LKEEE3

    Bestätigungserklärung erstellt am 13. Sept. 2017 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01
    X6FRMRDL

    Notification of a person with significant control statement

    2 SeitenPSC08
    X6FRLUSB

    Withdrawal of a person with significant control statement on 26. Sept. 2017

    2 SeitenPSC09
    X6FRKMYG

    Wer sind die Geschäftsführer von DUNHAM ASSET MANAGEMENT LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SMITH, Christopher Peter
    10 Bonville Chase
    WA14 4QA Altrincham
    Cheshire
    Sekretär
    10 Bonville Chase
    WA14 4QA Altrincham
    Cheshire
    BritishFinancial Advisor25910690002
    MCGAREY, Gillian Linda
    Pexhill Road
    Henbury
    SK11 9PT Macclesfield
    1
    Cheshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Pexhill Road
    Henbury
    SK11 9PT Macclesfield
    1
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector241295750001
    MCGAREY, Stephen
    Pexhill Road
    Henbury
    SK11 9PT Macclesfield
    1
    Cheshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Pexhill Road
    Henbury
    SK11 9PT Macclesfield
    1
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinancial Advisor3571520004
    SMITH, Christopher Peter
    10 Bonville Chase
    WA14 4QA Altrincham
    Cheshire
    Geschäftsführer
    10 Bonville Chase
    WA14 4QA Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritishFinancial Advisor25910690002
    SMITH, Lisa Jane Rita
    Bonville Chase
    WA14 4QA Altrincham
    10
    Cheshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Bonville Chase
    WA14 4QA Altrincham
    10
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector241295550001
    BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    Bevollmächtigter Sekretär
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    900001550001
    DEANSGATE COMPANY FORMATIONS LIMITED
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    900001540001

    Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für DUNHAM ASSET MANAGEMENT LIMITED?

    Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
    Benachrichtigt amAufgehört amErklärung
    13. Sept. 2017Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es keine registrierungspflichtige Person oder registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen gibt.
    13. Sept. 201613. Sept. 2017Das Unternehmen hat die erforderlichen Schritte zur Ermittlung, ob eine Person eine registrierungspflichtige Person oder eine registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen ist, noch nicht abgeschlossen.

    Hat DUNHAM ASSET MANAGEMENT LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 14. Sept. 2007
    Geliefert am 15. Sept. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Apartment 2501 halls 2 budenburg woodfield road altrincham cheshire.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 15. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 26. Okt. 1998
    Geliefert am 27. Okt. 1998
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H 47 roebuck lane sale greater manchester-GM79250 and all buildings structures fixtures (including trade fixtures) and fixed plant machinery and equipment. All right title and interest of the company to and in any proceeds of any present or future insurances of the property. Any present and future goodwill attaching to the property. All moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 27. Okt. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 25. Sept. 1998
    Geliefert am 29. Sept. 1998
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a 40 waverley road sale greater manchester t/n GM298142. And all buildings structures fixtures (including trade fixtures) and fixed plant machinery and equipment from time to time thereon all right title and interest to and in any proceeds of any present or future insurances of the property any present and future goodwill of the business (if any) and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 29. Sept. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Aug. 1998
    Geliefert am 02. Sept. 1998
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Freeholds property k/a 37 belgrave road sale trafford greater manchester t/n GM279385 together with all structures (including trade fixtures) and fixed plant machinery and equipment all right title and interest any present and future goodwill. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 02. Sept. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 07. März 1997
    Geliefert am 08. März 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a and situate at 28 albion street sale t/no;-GM452438 and all buildings and fixtures and fittings thereon all proceeds of insurance all present and future goodwill at the property. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 08. März 1997Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Jan. 1997
    Geliefert am 18. Jan. 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the f/h property k/a 53 woodfield road altrincham t/n GM25537 with all structyres thereon fixed plant and machinery and equipment all right title and interest in the proceeds of insurance any present or future goodwill. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • The Governor & the Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 18. Jan. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Dez. 1996
    Geliefert am 24. Dez. 1996
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £41,450 due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    F/Hold property known as 24 seymour grove,sale with all buildings,fixtures,plant and machinery thereon; all rights,title and interest and any proceeds of insurance; the goodwill of business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Ireland LTD
    Transaktionen
    • 24. Dez. 1996Registrierung einer Belastung (395)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0