FLEXIT IH LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | FLEXIT IH LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02752646 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von FLEXIT IH LIMITED?
- (7011) /
Wo befindet sich FLEXIT IH LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | The Hart Shaw Building Europa Link Sheffield Business Park S9 1XU Sheffield South Yorkshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von FLEXIT IH LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| SHAREBALANCE PUBLIC LIMITED COMPANY | 02. Okt. 1992 | 02. Okt. 1992 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FLEXIT IH LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2008 |
Welche sind die letzten Einreichungen für FLEXIT IH LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 3 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Booths Park Chelford Road Knutsford Cheshire WA16 8QZ am 16. Jan. 2010 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 353 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2004 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von FLEXIT IH LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAND, Kim Andrea | Sekretär | Sutton Field Whitegate CW8 2BD Northwich Cherry Trees, Cheshire | British | 141032930001 | ||||||
| FIDLER, Christopher Laskey | Geschäftsführer | Marlborough Avenue SK8 7AW Cheadle Hulme 66 Cheshire | England | British | 141025870003 | |||||
| AMEC NOMINEES LIMITED | Geschäftsführer | Booths Park Chelford Road WA16 8QZ Knutsford Cheshire | 32732300002 | |||||||
| FELLOWES, Colin | Sekretär | 9 Thistlewood Drive Summerfields SK9 2RF Wilmslow Cheshire | British | 800670001 | ||||||
| FIDLER, Christopher Laskey | Sekretär | Marlborough Avenue SK8 7AW Cheadle Hulme 66 Cheshire | British | 141025870003 | ||||||
| JACKSON, Stanley Robertson | Sekretär | 74 Olivers Battery Road North SO22 4JB Winchester Hampshire | British | 4689630002 | ||||||
| SHELDON, Jeremy Nigel | Sekretär | Pasturewood House Abinger Lane, Abinger Common RH5 6JH Dorking Surrey | British | 80327250001 | ||||||
| RICHARD ELLIS FINANCIAL LIMITED | Sekretär | C/O Richard Ellis 55 Old Broad Street EC2M 1LP London | 32874470003 | |||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| COX, Michael John | Geschäftsführer | Holly Tree House Brandy Bottom Yateley Common GU17 6BE Camberley Surrey | British | 28998990001 | ||||||
| COX, Michael John | Geschäftsführer | Holly Tree House Brandy Bottom Yateley Common GU17 6BE Camberley Surrey | British | 28998990001 | ||||||
| COX, Michael John | Geschäftsführer | Holly Tree House Brandy Bottom Yateley Common GU17 6BE Camberley Surrey | British | 28998990001 | ||||||
| DEVINE, Stephen Colm | Geschäftsführer | 4 Fernbank Finchampstead RG11 4XB Wokingham Berkshire | Irish | 6552570001 | ||||||
| DEVINE, Stephen Colm | Geschäftsführer | 4 Fernbank Finchampstead RG11 4XB Wokingham Berkshire | Irish | 6552570001 | ||||||
| ELLINGHAM, Hugh Vere Alexander | Geschäftsführer | Stonepitts Manor Seal TN15 0ER Sevenoaks Kent | United Kingdom | British | 36926690001 | |||||
| FITZGERALD, Michael Thomas | Geschäftsführer | Whin Cottage St Michaels Drive TN14 5SA Otford Kent | British | 62403370002 | ||||||
| FRASER, Richard Lindsay | Geschäftsführer | Meadowgarth Bowbridge Lane Prestbury GL52 3BJ Cheltenham Gloucestershire | British | 13770640001 | ||||||
| HOLLAND, Peter James | Geschäftsführer | Woodside House Wynnstay Lane, Marford LL12 8LH Wrexham | Wales | British | 75624260001 | |||||
| JACKSON, Stanley Robertson | Geschäftsführer | 74 Olivers Battery Road North SO22 4JB Winchester Hampshire | British | 4689630002 | ||||||
| JACKSON, Stanley Robertson | Geschäftsführer | 74 Olivers Battery Road North SO22 4JB Winchester Hampshire | British | 4689630002 | ||||||
| PEARCE, Daniel Norton Idris, Sir | Geschäftsführer | G3 Albany Piccadilly W1J 0AT London | British | 45656280001 | ||||||
| RATCLIFFE, Michael Arthur | Geschäftsführer | 9 Leigh Court Close KT11 2HT Cobham Surrey | United Kingdom | British | 11387510001 | |||||
| ROUGHTON, Dominic David | Geschäftsführer | 10 Danbury Street Islington N1 8JU London | British | 30738920001 | ||||||
| SHELDON, Jeremy Nigel | Geschäftsführer | Pasturewood House Abinger Lane, Abinger Common RH5 6JH Dorking Surrey | British | 80327250001 | ||||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Hat FLEXIT IH LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Erstellt am 01. Juni 1994 Geliefert am 03. Juni 1994 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of the put and call option deed dated 14TH january 1993 | |
Kurze Angaben Plot 58 regents gate foxholes hertford hertfordshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 19. Apr. 1994 Geliefert am 20. Apr. 1994 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of a put and call option deed dated 14TH january 1993 | |
Kurze Angaben Plot 58 on the company's estate at phase 2(a) regents gate foxholes, hertford hertfordshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 09. Feb. 1994 Geliefert am 10. Feb. 1994 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of the put and call option deed dated 14TH january 1993 | |
Kurze Angaben Plot 14 crusaders court st. Johns terrace road earlswood redhill, plots 9 17 and 25 manor drive wembley. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 09. Feb. 1994 Geliefert am 10. Feb. 1994 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee arising from or as a result of a material breach by the company of one or more of the covenants and undertakings given by the company pursuant to clause 11.1 of the put and call option deed for the sale and purchase of the business of the company dated 14 january 1993 | |
Kurze Angaben Plot 160 carreg yr afon glan yr afon graig newydd godre'r graig pontardawe west glamorgan. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 09. Feb. 1994 Geliefert am 10. Feb. 1994 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee arising from or as a result of a material breach by the company of one or more of the covenants and undertakings given by the company pursuant to clause 11.1 of the put and call option deed for the sale and purchase of the business of the company dated 14 january 1993 | |
Kurze Angaben Plot 78 herons reach blackpool. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 21. Dez. 1993 Geliefert am 07. Jan. 1994 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of a put and call option deed dated 14TH january 1993 | |
Kurze Angaben Plot 43 impala drive cherry hinton. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 29. Nov. 1993 Geliefert am 01. Dez. 1993 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of a put and call option deed dated 14TH january 1993 | |
Kurze Angaben Plot 150.3 glan-yr-afon, godre'r graig, pontardawe, swansea. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 11. Nov. 1993 Geliefert am 17. Nov. 1993 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of a put and call option deed dated 14TH january 1993 | |
Kurze Angaben Plots 32,33,34 and 39 salters lane, waterside mews, newport. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 01. Nov. 1993 Geliefert am 02. Nov. 1993 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of a put and call option deed dated 14TH january 1993 | |
Kurze Angaben Plot 115 cyclops wharf, west ferry road, london. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 12. Okt. 1993 Geliefert am 15. Okt. 1993 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of a put and call option deed dated 14TH january 1993 | |
Kurze Angaben Plots 169 and 170 barley croft, station road, elmswell, suffolk. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 14. Sept. 1993 Geliefert am 21. Sept. 1993 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to 11.1 of the put and call option deed dated 14/1/93 | |
Kurze Angaben Plot 88 herons reach blackpool. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 30. Juli 1993 Geliefert am 05. Aug. 1993 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of a put and call option deed dated 14TH january 1993 | |
Kurze Angaben Plot 902 cyclops wharf, west ferry road, london. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 23. Juli 1993 Geliefert am 07. Aug. 1993 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of a put and call option deed dated 14TH january 1993 | |
Kurze Angaben Plot 502 cyclops wharf west ferry road, london. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 21. Juli 1993 Geliefert am 23. Juli 1993 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of the put and call option deed dated 14/1/193 | |
Kurze Angaben Plots 95, 32, 29 and 49 spring gardens ince. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 02. Juli 1993 Geliefert am 07. Juli 1993 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of a put and call option deed dated 14TH january 1993 | |
Kurze Angaben Plot 144 godre'r graig, swansea. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 25. Juni 1993 Geliefert am 02. Juli 1993 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of a put and call option deed dated 14TH january 1993 | |
Kurze Angaben 326 cyclops wharf, west ferry road, london. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 24. Juni 1993 Geliefert am 02. Juli 1993 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of a put and call option deed dated 14TH january 1993 | |
Kurze Angaben 516 cyclops wharf, west ferry road, london. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 04. Juni 1993 Geliefert am 17. Juni 1993 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Plots 2.01, 5.16 and 6.19 king and queen wharf, rotherhithe. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 17. Mai 1993 Geliefert am 20. Mai 1993 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Plots 59,64,65 willow green,robertsbridge; plot 45 lytton gate,woolmer green. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 22. Feb. 1993 Geliefert am 25. Feb. 1993 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of the put and call option deed dated 14TH january 1993 | |
Kurze Angaben Plot 7 on the company's estate at the ridings, paddock wood t/no: k 684686 (see ch microfiche for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 14. Jan. 1993 Geliefert am 01. Feb. 1993 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of the put and call options deed of even date and under the terms of the charge | |
Kurze Angaben See 395 for full details and property details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat FLEXIT IH LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0