FLEXIT IK LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameFLEXIT IK LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02752648
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von FLEXIT IK LIMITED?

    • (7011) /

    Wo befindet sich FLEXIT IK LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    The Hart Shaw Building Europa Link
    Sheffield Business Park
    S9 1XU Sheffield
    South Yorkshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von FLEXIT IK LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    TRADERISE PUBLIC LIMITED COMPANY02. Okt. 199202. Okt. 1992

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FLEXIT IK LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2008

    Welche sind die letzten Einreichungen für FLEXIT IK LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    3 Seiten4.71

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Booths Park Chelford Road Knutsford Cheshire WA16 8QZ am 16. Jan. 2010

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 17. Dez. 2009

    LRESSP

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    3 Seiten288a

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    3 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten353

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    3 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006

    3 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005

    3 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2004

    3 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von FLEXIT IK LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HAND, Kim Andrea
    Sutton Field
    Whitegate
    CW8 2BD Northwich
    Cherry Trees,
    Cheshire
    Sekretär
    Sutton Field
    Whitegate
    CW8 2BD Northwich
    Cherry Trees,
    Cheshire
    British141032930001
    FIDLER, Christopher Laskey
    Marlborough Avenue
    SK8 7AW Cheadle Hulme
    66
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Marlborough Avenue
    SK8 7AW Cheadle Hulme
    66
    Cheshire
    EnglandBritish141025870003
    AMEC NOMINEES LIMITED
    Booths Park
    Chelford Road
    WA16 8QZ Knutsford
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Booths Park
    Chelford Road
    WA16 8QZ Knutsford
    Cheshire
    32732300002
    FELLOWES, Colin
    9 Thistlewood Drive
    Summerfields
    SK9 2RF Wilmslow
    Cheshire
    Sekretär
    9 Thistlewood Drive
    Summerfields
    SK9 2RF Wilmslow
    Cheshire
    British800670001
    FIDLER, Christopher Laskey
    Marlborough Avenue
    SK8 7AW Cheadle Hulme
    66
    Cheshire
    Sekretär
    Marlborough Avenue
    SK8 7AW Cheadle Hulme
    66
    Cheshire
    British141025870003
    JACKSON, Stanley Robertson
    74 Olivers Battery Road North
    SO22 4JB Winchester
    Hampshire
    Sekretär
    74 Olivers Battery Road North
    SO22 4JB Winchester
    Hampshire
    British4689630002
    SHELDON, Jeremy Nigel
    Pasturewood House
    Abinger Lane, Abinger Common
    RH5 6JH Dorking
    Surrey
    Sekretär
    Pasturewood House
    Abinger Lane, Abinger Common
    RH5 6JH Dorking
    Surrey
    British80327250001
    RICHARD ELLIS FINANCIAL LIMITED
    C/O Richard Ellis
    55 Old Broad Street
    EC2M 1LP London
    Sekretär
    C/O Richard Ellis
    55 Old Broad Street
    EC2M 1LP London
    32874470003
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    COX, Michael John
    Holly Tree House
    Brandy Bottom Yateley Common
    GU17 6BE Camberley
    Surrey
    Geschäftsführer
    Holly Tree House
    Brandy Bottom Yateley Common
    GU17 6BE Camberley
    Surrey
    British28998990001
    COX, Michael John
    Holly Tree House
    Brandy Bottom Yateley Common
    GU17 6BE Camberley
    Surrey
    Geschäftsführer
    Holly Tree House
    Brandy Bottom Yateley Common
    GU17 6BE Camberley
    Surrey
    British28998990001
    COX, Michael John
    Holly Tree House
    Brandy Bottom Yateley Common
    GU17 6BE Camberley
    Surrey
    Geschäftsführer
    Holly Tree House
    Brandy Bottom Yateley Common
    GU17 6BE Camberley
    Surrey
    British28998990001
    DEVINE, Stephen Colm
    4 Fernbank
    Finchampstead
    RG11 4XB Wokingham
    Berkshire
    Geschäftsführer
    4 Fernbank
    Finchampstead
    RG11 4XB Wokingham
    Berkshire
    Irish6552570001
    DEVINE, Stephen Colm
    4 Fernbank
    Finchampstead
    RG11 4XB Wokingham
    Berkshire
    Geschäftsführer
    4 Fernbank
    Finchampstead
    RG11 4XB Wokingham
    Berkshire
    Irish6552570001
    ELLINGHAM, Hugh Vere Alexander
    Stonepitts Manor
    Seal
    TN15 0ER Sevenoaks
    Kent
    Geschäftsführer
    Stonepitts Manor
    Seal
    TN15 0ER Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish36926690001
    FITZGERALD, Michael Thomas
    Whin Cottage St Michaels Drive
    TN14 5SA Otford
    Kent
    Geschäftsführer
    Whin Cottage St Michaels Drive
    TN14 5SA Otford
    Kent
    British62403370002
    FRASER, Richard Lindsay
    Meadowgarth Bowbridge Lane
    Prestbury
    GL52 3BJ Cheltenham
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    Meadowgarth Bowbridge Lane
    Prestbury
    GL52 3BJ Cheltenham
    Gloucestershire
    British13770640001
    HOLLAND, Peter James
    Woodside House
    Wynnstay Lane, Marford
    LL12 8LH Wrexham
    Geschäftsführer
    Woodside House
    Wynnstay Lane, Marford
    LL12 8LH Wrexham
    WalesBritish75624260001
    JACKSON, Stanley Robertson
    74 Olivers Battery Road North
    SO22 4JB Winchester
    Hampshire
    Geschäftsführer
    74 Olivers Battery Road North
    SO22 4JB Winchester
    Hampshire
    British4689630002
    JACKSON, Stanley Robertson
    74 Olivers Battery Road North
    SO22 4JB Winchester
    Hampshire
    Geschäftsführer
    74 Olivers Battery Road North
    SO22 4JB Winchester
    Hampshire
    British4689630002
    PEARCE, Daniel Norton Idris, Sir
    G3 Albany
    Piccadilly
    W1J 0AT London
    Geschäftsführer
    G3 Albany
    Piccadilly
    W1J 0AT London
    British45656280001
    RATCLIFFE, Michael Arthur
    9 Leigh Court Close
    KT11 2HT Cobham
    Surrey
    Geschäftsführer
    9 Leigh Court Close
    KT11 2HT Cobham
    Surrey
    United KingdomBritish11387510001
    ROUGHTON, Dominic David
    10 Danbury Street
    Islington
    N1 8JU London
    Geschäftsführer
    10 Danbury Street
    Islington
    N1 8JU London
    British30738920001
    SHELDON, Jeremy Nigel
    Pasturewood House
    Abinger Lane, Abinger Common
    RH5 6JH Dorking
    Surrey
    Geschäftsführer
    Pasturewood House
    Abinger Lane, Abinger Common
    RH5 6JH Dorking
    Surrey
    British80327250001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Hat FLEXIT IK LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 30. März 1994
    Geliefert am 09. Apr. 1994
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of the put and call option deed dated 14TH january 1993
    Kurze Angaben
    Plot 18 crusader court earlswood.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 09. Apr. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 24. März 1994
    Geliefert am 25. März 1994
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of the put and call option deed dated 14TH january 1993
    Kurze Angaben
    Plot 60 phase 2A (1) foxholes hertford hertfordshire.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 25. März 1994Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 18. Feb. 1994
    Geliefert am 23. Feb. 1994
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of a put and call option deed 14TH january 1993
    Kurze Angaben
    Plot 157 claremont, essex hall.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 23. Feb. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Feb. 1994
    Geliefert am 10. Feb. 1994
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of the put and call option deed dated 14TH january 1993
    Kurze Angaben
    Plots 17 8 and 10 crusaders court st. Johns terrace road earlswood, plots 18 and 23 manor drive wembley. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 10. Feb. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Feb. 1994
    Geliefert am 10. Feb. 1994
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee arising from or as a result of a material breach by the company of one or more of the covenants and undertakings given by the company pursuant to clause 11.1 of the put and call option deed for the sale and purchase of the business of the company dated 14 january 1993
    Kurze Angaben
    Plots 3 and 162 carreg yr afon glan yr afon graig newydd godre'r graig pontardawe west glamorgan.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 10. Feb. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Feb. 1994
    Geliefert am 10. Feb. 1994
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee arising from or as a result of a material breach by the company of one or more of the covenants and undertakings given by the company pursuant to clause 11.1 of the put and call option deed for the sale and purchase of the business of the company dated 14 january 1993
    Kurze Angaben
    Plots 80, 90 and 262 herons reach blackpool.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 10. Feb. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 14. Dez. 1993
    Geliefert am 15. Dez. 1993
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of a put and call option deed dated 14TH january 1993
    Kurze Angaben
    Plot 179 lodge lane, hyde.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 15. Dez. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 21. Juli 1993
    Geliefert am 23. Juli 1993
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of the put and call option deed dated 14/1/93
    Kurze Angaben
    27, 24, 46, 47 spring gardens ince.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 23. Juli 1993Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Juli 1993
    Geliefert am 07. Juli 1993
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of a put and call option deed dated 14TH january 1993
    Kurze Angaben
    Plot 165 godre'r graig swansea.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 07. Juli 1993Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Juli 1993
    Geliefert am 07. Juli 1993
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of a put and call option deed dated 14TH january 1993
    Kurze Angaben
    Plot 146 godre'r graig swansea.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 07. Juli 1993Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 18. Juni 1993
    Geliefert am 02. Juli 1993
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of a put and call option deed dated 14TH january 1993
    Kurze Angaben
    413 cyclops wharf, west ferry road, london.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 02. Juli 1993Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Juni 1993
    Geliefert am 17. Juni 1993
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of a put and call option deed dated 14TH january 1993
    Kurze Angaben
    Plot 152 godre'r graig, swansea.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 17. Juni 1993Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Juni 1993
    Geliefert am 17. Juni 1993
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    3.19, 5.09, 5.15 & 6.15 king and queen wharf, rotherhithe, 60 regents gate, foxholes, stansted road, 80 shires, greenbank, borough road.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 17. Juni 1993Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 03. Juni 1993
    Geliefert am 23. Juni 1993
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    224 cyclops wharf west ferry road london.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 23. Juni 1993Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 27. Mai 1993
    Geliefert am 10. Juni 1993
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee as defined in the legal charge
    Kurze Angaben
    Plot 329 on the companys estate at cyclops wharf, west ferry road, london.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 10. Juni 1993Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Mai 1993
    Geliefert am 20. Mai 1993
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Plots 60,68 willow green,robertsbridge and plot 117 lytton gate,woolmer green.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 20. Mai 1993Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Feb. 1993
    Geliefert am 25. Feb. 1993
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of the put and call option deed dated 14TH january 1993
    Kurze Angaben
    Plot 88 on the company's estate at phase 3 beckside west green, pocklington t/no: h 171354 (see ch microfiche for full details).
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 25. Feb. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 14. Jan. 1993
    Geliefert am 01. Feb. 1993
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 11.1 of the put and call options deed of even date and under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    See 395 for full details and property details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 01. Feb. 1993Registrierung einer Belastung (395)

    Hat FLEXIT IK LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    17. Dez. 2009Beginn der Liquidation
    10. Apr. 2011Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Christopher John Brown
    The Hart Shaw Building Europa Link
    Sheffield Business Park
    S9 1XU Sheffield
    South Yorkshire
    Praktiker
    The Hart Shaw Building Europa Link
    Sheffield Business Park
    S9 1XU Sheffield
    South Yorkshire

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0