C & W PRODUCTION ENGINEERING LIMITED

C & W PRODUCTION ENGINEERING LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameC & W PRODUCTION ENGINEERING LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02756320
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von C & W PRODUCTION ENGINEERING LIMITED?

    • (2811) /

    Wo befindet sich C & W PRODUCTION ENGINEERING LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    BAKER TILLY RESTRUCTURING & RECOVERY LLP
    3 Hardman Street Spinningfields
    M3 3HF Manchester
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von C & W PRODUCTION ENGINEERING LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    LINWORK LIMITED16. Okt. 199216. Okt. 1992

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von C & W PRODUCTION ENGINEERING LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Okt. 2008

    Welche sind die letzten Einreichungen für C & W PRODUCTION ENGINEERING LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    19 SeitenLIQ14

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Juni 2017

    17 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Juni 2016

    15 Seiten4.68

    Insolvenzgerichtsbeschluss

    Court order insolvency:re block transfer replacement of liq
    8 SeitenLIQ MISC OC

    Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator

    1 Seiten4.40

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Juni 2015

    17 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Juni 2014

    16 Seiten4.68

    Insolvenzmeldung

    Insolvency:order of court appointing donald bailey as administrator of the company
    11 SeitenLIQ MISC

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Insolvenzgerichtsbeschluss

    Court order insolvency:court order re. Removal/replacement of liquidators
    11 SeitenLIQ MISC OC

    Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator

    1 Seiten4.40

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Juni 2013

    19 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Juni 2012

    20 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Juni 2011

    17 Seiten4.68

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Unit 9 Vaughan St Industrial Estate, Manchester M12 5BT* am 14. Juli 2010

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren

    LRESEX

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    9 Seiten4.20

    legacy

    5 SeitenMG01

    Jahresrückblick erstellt bis 16. Okt. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital04. Jan. 2010

    Kapitalaufstellung am 04. Jan. 2010

    • Kapital: GBP 50,002
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Ian Peter Mcneil am 01. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Okt. 2008

    7 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten395

    Wer sind die Geschäftsführer von C & W PRODUCTION ENGINEERING LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MCNEIL, Mary Jane
    White Lodge
    Light Alders Lane Disley
    SK12 2LW Stockport
    Cheshire
    Sekretär
    White Lodge
    Light Alders Lane Disley
    SK12 2LW Stockport
    Cheshire
    British97492290001
    MCNEIL, Ian Peter
    White Lodge
    Light Alders Lane, Disley
    SK12 2LW Stockport
    Cheshire
    Geschäftsführer
    White Lodge
    Light Alders Lane, Disley
    SK12 2LW Stockport
    Cheshire
    United KingdomBritishEngineer43574300002
    PLENDERLEITH, Trevor
    6 Green Meadows
    Marple
    SK6 6QF Stockport
    Cheshire
    Sekretär
    6 Green Meadows
    Marple
    SK6 6QF Stockport
    Cheshire
    BritishAccountant30945390001
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Bevollmächtigter Sekretär
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    GIBRAIL, Raschid Paul
    The Limes 36 Breck Road
    FY6 7AQ Poulton Le Fylde
    Lancashire
    Geschäftsführer
    The Limes 36 Breck Road
    FY6 7AQ Poulton Le Fylde
    Lancashire
    BritishCompany Director6241370001
    PLENDERLEITH, Trevor
    6 Green Meadows
    Marple
    SK6 6QF Stockport
    Cheshire
    Geschäftsführer
    6 Green Meadows
    Marple
    SK6 6QF Stockport
    Cheshire
    BritishAccountant30945390001
    HALLMARK REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004090001

    Hat C & W PRODUCTION ENGINEERING LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 26. März 2010
    Geliefert am 27. März 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land with t/nos GM336251 GM324036 and GM339934 and fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts and uncalled capital, see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ian Peter Griffiths
    Transaktionen
    • 27. März 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 22 august 2006 and
    Erstellt am 16. März 2009
    Geliefert am 25. März 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. März 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 22/8/2006
    Erstellt am 13. Okt. 2006
    Geliefert am 21. Okt. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Erstellt am 22. Aug. 2006
    Geliefert am 06. Sept. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or c & w holdings limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Any sums or sums standing to the credit if any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Sept. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage
    Erstellt am 24. Jan. 2006
    Geliefert am 27. Jan. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a or being unit 3 vaughan street ind estate vaughan st west gorton manchester t/no GM336251. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Jan. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 20. Nov. 2003
    Geliefert am 21. Nov. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Noble & lund cnc plano miller serial number 5952N craven vertical borer serial number 17954 any part or parts thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 07. Aug. 2000
    Geliefert am 11. Aug. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property k/a a small piece of land at unit 9, vaughan industrial estate, vaughan street, west gorton, manchester. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Aug. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 29. Jan. 1999
    Geliefert am 08. Feb. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Unit 9 vaughan street industrial estate vaughan street west gorton manchester. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Feb. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 17. Mai 1996
    Geliefert am 29. Mai 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Eagle Star Life Assurance Company Limited
    Transaktionen
    • 29. Mai 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Feb. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 26. Nov. 1992
    Geliefert am 07. Dez. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Various items of equipment (see form 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Dez. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Feb. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 26. Nov. 1992
    Geliefert am 07. Dez. 1992
    Teilweise erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that land lying to the west of vaughan street west gorton manchester t/nos. GM324036 GM347335 GM339934 together with buildings erected thereon k/a units 1, 9 & 10 vaughan crane works vaughan street west gorton manchester. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Dez. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Feb. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    • 12. Feb. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat C & W PRODUCTION ENGINEERING LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    21. Juni 2010Beginn der Liquidation
    16. Juli 2018Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Lindsey J Cooper
    3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    Praktiker
    3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    Russell Stewart Cash
    3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    Praktiker
    3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    Donald Bailey
    3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    Praktiker
    3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    Jeremy Nigel Ian Woodside
    9th Floor 3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    Praktiker
    9th Floor 3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0