PRESTIGIC LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnamePRESTIGIC LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02757109
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von PRESTIGIC LIMITED?

    • Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich PRESTIGIC LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    42 Albemarle Street
    London
    W1S 4JH
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PRESTIGIC LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Mai 2016

    Welche sind die letzten Einreichungen für PRESTIGIC LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 20. Okt. 2017 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Mai 2016

    7 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 20. Okt. 2016 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Mai 2015

    7 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 20. Okt. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital28. Okt. 2015

    Kapitalaufstellung am 28. Okt. 2015

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Philip Thomas Dawes als Sekretär am 31. Mai 2015

    1 SeitenTM02

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Mai 2014

    16 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 20. Okt. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital04. Dez. 2014

    Kapitalaufstellung am 04. Dez. 2014

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Mai 2013

    15 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 20. Okt. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital22. Okt. 2013

    Kapitalaufstellung am 22. Okt. 2013

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2012

    16 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 20. Okt. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2011

    17 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 20. Okt. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2010

    17 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 20. Okt. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2009

    17 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 20. Okt. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Adrian Goldsmith am 01. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Mai 2008

    16 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288c

    Wer sind die Geschäftsführer von PRESTIGIC LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GOLDSMITH, Adrian Richard
    30 Macaulay Road
    Clapham
    SW4 0QX London
    Greater London
    Geschäftsführer
    30 Macaulay Road
    Clapham
    SW4 0QX London
    Greater London
    United KingdomBritish48240460001
    DAWES, Philip Thomas
    3 Blackmile Lane
    Grendon
    NN7 1JR Northampton
    Northants
    Sekretär
    3 Blackmile Lane
    Grendon
    NN7 1JR Northampton
    Northants
    British87840550002
    GREEN, Jonathan Swale
    Flat 5
    153 Sutherland Avenue
    W9 1ES London
    Sekretär
    Flat 5
    153 Sutherland Avenue
    W9 1ES London
    British103086380001
    INGHAM, Michael Harry Peter
    3 Lauriston Road
    Wimbledon
    SW19 4TJ London
    Sekretär
    3 Lauriston Road
    Wimbledon
    SW19 4TJ London
    British2739650001
    MADDEN, Sarah Joy
    104 Stephendale Road
    SW6 2PH London
    Sekretär
    104 Stephendale Road
    SW6 2PH London
    British65668820001
    VAN ROOYEN, Tracy
    30 Edgewood Drive
    Green Street Green
    BR6 6LQ Orpington
    Kent
    Sekretär
    30 Edgewood Drive
    Green Street Green
    BR6 6LQ Orpington
    Kent
    British67908740002
    WALDEN, Susan Tracy
    31 Brechin Place
    SW7 4QD London
    Sekretär
    31 Brechin Place
    SW7 4QD London
    British40398340002
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Bevollmächtigter Sekretär
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    HARRIS, Michael Roderick
    Sandgate
    Marley Way, Storrington
    RH20 3NH Pulborough
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Sandgate
    Marley Way, Storrington
    RH20 3NH Pulborough
    West Sussex
    EnglandBritish4768360001
    TCHENGUIZ, Robert
    6 Chesterfield Hill
    Mayfair
    W1J 5BL London
    Geschäftsführer
    6 Chesterfield Hill
    Mayfair
    W1J 5BL London
    Iranian74322720002
    TCHENGUIZ, Vincent Aziz
    3 Lees Place
    Mayfair
    W1K 6LH London
    Geschäftsführer
    3 Lees Place
    Mayfair
    W1K 6LH London
    United KingdomBritish71890500003
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei PRESTIGIC LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Prestigic Holdings Limited
    Albemarle Street
    W1S 4JH London
    42
    England
    06. Apr. 2016
    Albemarle Street
    W1S 4JH London
    42
    England
    Nein
    RechtsformLimited Company
    RegistrierungslandEngland And Wales
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortCompanies House England And Wales
    Registrierungsnummer03256692
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat PRESTIGIC LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Supplemental deed being supplemental to a deed of legal charge dated 27 march 1998
    Erstellt am 28. Mai 2003
    Geliefert am 10. Juni 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from prestigic holdings limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage l/h land being 3 & 4 vaughan parade and 3 palk street torquay devon t/no DN339269 together with all buildings erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fixed plant and machinery together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fixed plant and machinery thereon, all improvements and additions thereto and all easements rights licences appurtenant thereto, subject to and with the benefit of all existing leases underleases tenancies agreements to lease rights covenants under conditions affecting the same but otherwise free from encumbrance.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance LTD
    Transaktionen
    • 10. Juni 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of assignment
    Erstellt am 28. Mai 2003
    Geliefert am 10. Juni 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from prestigic holdings limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the rights titles benefits and interests whether present or future of the company to all moneys from time to time due owing or incurred to the company under the leases in respect of l/h property k/a 3 & 4 vaughan parade and 3 palk street torquay t/no DN339269. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance LTD
    Transaktionen
    • 10. Juni 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Jan. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment by way of charge
    Erstellt am 27. März 1998
    Geliefert am 15. Apr. 1998
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies, obligations and liabilites whatsoever which may now or at any time in the future be due owing or incurred by prestigic holdings limited and any company from time to time which is a holding company or subsidiary of prestigic holdings limited and any subsidiary undertaking or associate of any such company ("group member") to norwich union mortgage finance limited as trustee for itself and the other lenders ("trustee") or the trustee, the norwich union mortgage finance limited and any company which is or becomes a holding company of any such company or subsidiary or associate of any such company or holding company which lends or has lent to, or is at any time owed moneys by, any group member ("lenders") or for or in respect of which any group member may be liable to the trustee or any lenders whether present or future, actual or contingent on any account whatsoever and in any manner whatsoever
    Kurze Angaben
    The company assigns by way of charge all the rights, titles, benefits and interests and whether present or future of the company to all monies from time to time due owing or incurred to the company under the occupational lease/s in respect of 27 crown street leeds, 328 and 330 chepstow road newport gwent, 2-4 albert road wildnes and 6-7 high street market drayton ("the lease/s") other than the sums due to the company by way of insurance rent or service charge or any vat payable to the company thereon including the right to receive the same and the full benefit of any guarantee or security for the performance thereof now or at any time thereafter given together with all claims, causes of action and damages arising in connection therewith and any proceeds of the forgoing ("the assigned rights").. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transaktionen
    • 15. Apr. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of legal charge
    Erstellt am 27. März 1998
    Geliefert am 15. Apr. 1998
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies, obligations and liabilites whatsoever which may now or at any time in the future be due owing or incurred by prestigic holdings limited and any company from time to time which is a holding company or subsidiary of prestigic holdings limited and any subsidiary undertaking or associate of any such company ("group member") to norwich union mortgage finance limited as trustee for itself and the other lenders ("trustee") or the trustee, the norwich union mortgage finance limited and any company which is or becomes a holding company of any such company or subsidiary or associate of any such company or holding company which lends or has lent to, or is at any time owed moneys by, any group member ("lenders") or for or in respect of which any group member may be liable to the trustee or any lenders whether present or future, actual or contingent on any account whatsoever and in any manner whatsoever
    Kurze Angaben
    The properties listed below together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants' fixtures) and fittings thereon and all improvements and additions thereto and all easements, rights and licences appurtenant thereto subject to and with the benefit of all existing leases underleases tenancies agreements to lease rights covenants and conditions affecting the same but otherwise free from encumbrance: 27 crown street leeds t/n-WYK193950. 328 and 330 chepstow road newport t/n-WA236678. 2 and 4 albert road widnes cheshire t/n-CH339908. 6-7 high street market drayton shropshire t/n-SL53053. Manvers house kingston mills bradford upon avon wiltshire t/n-WT141611. All monies deposited with the trustee on the terms set out in schedule 6 to the deed. By way of floating charge the whole of the company's property, assets, rights and revenues whatsoever and wheresoever, present and future, including the uncalled share capital (if any) or such of them as the context requires.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transaktionen
    • 15. Apr. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 24. Feb. 1997
    Geliefert am 14. März 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from holaw (332) limited and prestigic limited (group member) to the chargee as trustee for itself and the other lenders or the chargee and any company which is or becomes a holding company of any such company or subsidiary or associate of any such company or holding company on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Units 2 & 3 burrington way,plymouth-DN323936 together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants'fixtures) and fitting thereon and all improvements and additions thereto.all monies deposited with the trustee on the terms set out in schedule 6 to the deed.floating charge the whole of the company's property,assets,rights and revenues whatsoever and wheresoever present and future including the uncalled share capital (if any).
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transaktionen
    • 14. März 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Jan. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment by way of charge
    Erstellt am 24. Feb. 1997
    Geliefert am 14. März 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or prestigic holdings limited and holaw (332) limited to the chargee (as trustee) or any lender (as defined)
    Kurze Angaben
    All the rights, titles benefits and interests and whether present or future of the company to all monies from time to time due owing or incurred to the company under the occupational leases in respect of units 2 & 3 burrington way plymouth ("the leases/s") other than the sums due to the company by way of insurance rent or service charge. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transaktionen
    • 14. März 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Jan. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge and further legal charge
    Erstellt am 08. Aug. 1994
    Geliefert am 11. Aug. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £187,500.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the legal charge and £10,000 (being part of the principal sum detailed above) due under the floating charge
    Kurze Angaben
    All that f/h property k/a 7 high street market drayton shropshire t/no sl 53053 all that f/h property k/a the marsh goose (fromerly sheridans restaurant ) high street moreton in marsh t/no GR98033. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Allied Dunbar Assurance PLC
    Transaktionen
    • 11. Aug. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Jan. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Joint venture agreement
    Erstellt am 05. Aug. 1994
    Geliefert am 10. Aug. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £26,750.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    All that f/h premises k/a 6-7 high street market drayton t/no SL53053. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Daywatch Limited
    Transaktionen
    • 10. Aug. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Jan. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Joint venture agreement
    Erstellt am 05. Aug. 1994
    Geliefert am 10. Aug. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £34,750.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    All that f/h property k/a 2-4 albert road widnes cheshire t/no ch 339908. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Daywatch Limited
    Transaktionen
    • 10. Aug. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Jan. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge and floating charge
    Erstellt am 06. Apr. 1994
    Geliefert am 09. Apr. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £262,500.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 328 and 330 chepstow road newport gwent t/no WA236678. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Allied Dunbar Assurance PLC
    Transaktionen
    • 09. Apr. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Jan. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge and floating charge
    Erstellt am 06. Apr. 1994
    Geliefert am 09. Apr. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £262,500.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 2 and 4 albert road widnes halton cheshire t/no CH339908. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Allied Dunbar Assurance PLC
    Transaktionen
    • 09. Apr. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Jan. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge and floating charge
    Erstellt am 06. Apr. 1994
    Geliefert am 09. Apr. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £262,500.00 and all other monies due or to beocme due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 3/4/vaughan parade and 3 palk street torquay devon t/no DN301207. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Allied Dunbar Assurance PLC
    Transaktionen
    • 09. Apr. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Jan. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Joint venture agreement
    Erstellt am 03. März 1994
    Geliefert am 10. März 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £67,500.00 together with all other monies due or to become due from the comapny to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    By way of charge l/h vaughan parade and palk street torquay t/no DN301207. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Daywatch Limited
    Transaktionen
    • 10. März 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Jan. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Joint venture agreement
    Erstellt am 03. März 1994
    Geliefert am 10. März 1994
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £82,500.00 together with all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    By way of charge f/h white cloth hall 27 crown street leeds t/no wyk 193950. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Daywatch Limited
    Transaktionen
    • 10. März 1994Registrierung einer Belastung (395)
    Joint venture agreement
    Erstellt am 03. März 1994
    Geliefert am 10. März 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £36,500.00 together with all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    By way of charge the f/h 328/330 chepstow road newport gwent t/no wa 236678. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Daywatch Limited
    Transaktionen
    • 10. März 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Jan. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Joint venture agreement
    Erstellt am 03. März 1994
    Geliefert am 10. März 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £17,400.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    By way of charge l/h 1 & 2 rosebery court rosebery avenue london EC1 t/no ngl 704562. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Daywatch Limited
    Transaktionen
    • 10. März 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Jan. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Joint venture agreement
    Erstellt am 03. März 1994
    Geliefert am 10. März 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £38,125.00 together with all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    By way of a charge over l/h units 2 & 3 burrington way honicknowle plymouth devon t/no dn 323936. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Daywatch Limited
    Transaktionen
    • 10. März 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Jan. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Joint venture agreement
    Erstellt am 03. März 1994
    Geliefert am 10. März 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £32,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the joint venture agreement
    Kurze Angaben
    F/H-the marsh goose retaurant (formerly sheridans restaurant) high street moreton-in-marsh cotswold gloucestershire t/n-GR98033.
    Berechtigte Personen
    • Daywatch Limited
    Transaktionen
    • 10. März 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Jan. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Feb. 1994
    Geliefert am 11. Feb. 1994
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £570,000 and all other moneys due or to become due from the company to allied dunbar assurance PLC, under the terms of the charge,
    Kurze Angaben
    Leasehold property known as or being 3-4 vaughan parade and 3 palk street,torquay, devon, first floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Allied Dunbar Assurance PLC,
    Transaktionen
    • 11. Feb. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Feb. 1994
    Geliefert am 11. Feb. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £570,000 and all other moneys due or to become due from the company to allied dunbar assurance PLC, under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    All that freehold property known as or being 328 and 330 chepstow road, newport,gwent, first floating charge on. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Allied Dunbar Assurance PLC,
    Transaktionen
    • 11. Feb. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Jan. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge and floating charge
    Erstellt am 07. Jan. 1994
    Geliefert am 13. Jan. 1994
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £505,000.00 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    All that f/h propertry k/a the cloth hall 27 crown street leeds t/no wyk 193950 together with A. undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Allied Dunbar Assurance PLC
    Transaktionen
    • 13. Jan. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 25. Okt. 1993
    Geliefert am 08. Nov. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    For securing £200,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    The f/h land and buildings k/a the marsh goose restaurant high street moreton in marsh gloucestershire t/no gr 98033. undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Allied Dunbar Assurance PLC
    Transaktionen
    • 08. Nov. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Jan. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Feb. 1993
    Geliefert am 11. Feb. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £168,000 and all other monies due
    Kurze Angaben
    L/H 1& 2 rosebery court rosebery avenue london t/n ngl 616980. undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Allied Dunbar Assurance PLC
    Transaktionen
    • 11. Feb. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Jan. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Feb. 1993
    Geliefert am 11. Feb. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £220,500 and all other monies due
    Kurze Angaben
    L/H units 2 & 3 burrington way honicknowle plymouth devon t/n dn 202321. undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Allied Dunbar Assurance PLC
    Transaktionen
    • 11. Feb. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Juni 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0