BABCOCK S 2019 LIMITED
Überblick
Unternehmensname | BABCOCK S 2019 LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02759515 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BABCOCK S 2019 LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich BABCOCK S 2019 LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 33 Wigmore Street W1U 1QX London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von BABCOCK S 2019 LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
BABCOCK SERVICES LIMITED | 25. März 2008 | 25. März 2008 |
PETERHOUSE10 LIMITED | 24. Feb. 2006 | 24. Feb. 2006 |
GORSELINE INTERNATIONAL LIMITED | 27. Nov. 1992 | 27. Nov. 1992 |
TARBONA LIMITED | 27. Okt. 1992 | 27. Okt. 1992 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BABCOCK S 2019 LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für BABCOCK S 2019 LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 18. Dez. 2019
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 18. Okt. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Hinweis auf Namensänderung | 2 Seiten | CONNOT | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2019 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Okt. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2018 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 26. Okt. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2017 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Nicholas James William Borrett am 11. Jan. 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Nicholas James William Borrett am 13. Dez. 2016 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 27. Okt. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2016 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Iain Stuart Urquhart am 23. Aug. 2016 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 27. Okt. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Peter Lloyd Rogers als Geschäftsführer am 16. Juni 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Nicholas James William Borrett als Direktor am 16. Juni 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Iain Stuart Urquhart als Direktor am 16. Juni 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Franco Martinelli als Geschäftsführer am 16. Juni 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von BABCOCK S 2019 LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABCOCK CORPORATE SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Wigmore Street W1U 1QX London 33 United Kingdom |
| 173822100001 | ||||||||||
BORRETT, Nicholas James William | Geschäftsführer | Wigmore Street W1U 1QX London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | Group Company Secretary And General Counsel | 171010990002 | ||||||||
URQUHART, Iain Stuart | Geschäftsführer | Wigmore Street W1U 1QX London 33 | United Kingdom | British | Director | 104722420003 | ||||||||
BILLIALD, Stanley Alan Royall | Sekretär | Hyde Cottage Hyde Lane Churt GU10 2LP Farnham Surrey | Other | 35839210001 | ||||||||||
DODSON, Mark Warwick | Sekretär | Yandale Carrhouse Road Belton DN9 1PG Doncaster South Yorkshire | British | Company Accountant | 54927320001 | |||||||||
PALMER, Peter Edward | Sekretär | Hill Top Farm Asenby YO7 3QN Thirsk North Yorkshire | British | 21105820001 | ||||||||||
PAYNE, Eunice Ivy | Sekretär | 33 Wigmore Street W1U 1QX London Babcock International Group Plc England England | 171356440001 | |||||||||||
TELLER, Valerie Francine Anne | Sekretär | 33 Wigmore Street W1U 1QX London C/O Babcock International Group Plc United Kingdom | British | 139336240001 | ||||||||||
WOOLLHEAD, John Andrew | Sekretär | 23 Ruxley Ridge Claygate KT10 0HZ Esher Surrey | British | Company Secretary | 13072060002 | |||||||||
COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 900000080001 | |||||||||||
BEST, David Martin | Geschäftsführer | 34 Vicarage Meadows WF14 9JL Mirfield West Yorkshire | England | British | Director | 47892490001 | ||||||||
BRAMWELL, David Matthew | Geschäftsführer | Woodlands 2a Woodland Rise WF2 9DL Wakefield West Yorkshire | England | British | Director | 4250980001 | ||||||||
CAMPBELL, Edward | Geschäftsführer | Trouville Pontefract Road Hemsworth WF9 5LW Pontefract West Yorkshire | British | Company Director | 2609820001 | |||||||||
CRAIGHILL, Martin Arthur | Geschäftsführer | Fern Cottage Carr House Road Belton DN9 1PG Doncaster South Yorkshire | England | British | Drawing Office Manager | 33311140002 | ||||||||
DUNN, Steven John | Geschäftsführer | Dunolme 31 Poppyfields Way Branton DN3 3UA Doncaster South Yorkshire | British | Contracts Manager | 74788740001 | |||||||||
ELLIS, Dean Roger | Geschäftsführer | 6 Cookridge Drive Hatfield DN7 6JE Doncaster South Yorkshire | British | Systems Manager | 32313120001 | |||||||||
FARMER, John Anthony | Geschäftsführer | Knavesmire House 1 Manor Green Bolton Pocklington YO41 5RZ York | England | British | Chartered Accountant | 45802080001 | ||||||||
JACKSON, David James | Geschäftsführer | 10 Stone Rings Close HG2 9HZ Harrogate North Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 62867720010 | ||||||||
MARTINELLI, Franco | Geschäftsführer | 33 Wigmore Street W1U 1QX London C/O Babcock International Group Plc United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 85507440001 | ||||||||
PALMER, Peter Edward | Geschäftsführer | Hill Top Farm Asenby YO7 3QN Thirsk North Yorkshire | England | British | Director | 21105820001 | ||||||||
QUIRK, Bernard | Geschäftsführer | 23 Richmond Way Garforth LS25 1HT Leeds West Yorkshire | British | Technical Manager | 32313140001 | |||||||||
ROBERTSON, Alan Robert | Geschäftsführer | Foss Dyke Farm Red House Lane Moor Monkton Y026 8JG York North Yorkshire | British | Chief Executive | 63758950006 | |||||||||
ROGERS, Peter Lloyd | Geschäftsführer | 33 Wigmore Street W1U 1QX London C/O Babcock International Group Plc United Kingdom | England | British | Chief Executive | 49805580003 | ||||||||
COMBINED NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NA London | 900000090001 | |||||||||||
COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 900000080001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei BABCOCK S 2019 LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peterhouse6 (Ietg) Limited | 06. Apr. 2016 | Wigmore Street W1U 1QX London 33 United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat BABCOCK S 2019 LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Composite guarantee and trust debenture | Erstellt am 07. Okt. 2002 Geliefert am 09. Okt. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any of them to the trustee and or the beneficiaries or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 11. Dez. 1998 Geliefert am 11. Dez. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 18. Sept. 1997 Geliefert am 20. Sept. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 04. Dez. 1995 Geliefert am 12. Dez. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 02. Dez. 1994 Geliefert am 17. Dez. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 05. Feb. 1993 Geliefert am 19. Feb. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 05. Feb. 1993 Geliefert am 12. Feb. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 05. Feb. 1993 Geliefert am 12. Feb. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0