MTL TRUST HOLDINGS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMTL TRUST HOLDINGS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02764434
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MTL TRUST HOLDINGS LIMITED?

    • Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich MTL TRUST HOLDINGS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    11 Clifton Moor Business Village James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MTL TRUST HOLDINGS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2011

    Welche sind die letzten Einreichungen für MTL TRUST HOLDINGS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    8 Seiten4.71

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 1 Admiral Way Doxford International Business Park Sunderland Tyne & Wear SR3 3XP am 14. Sept. 2012

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 04. Sept. 2012

    LRESSP

    Ernennung von Mr Kenneth Mcintyre Carlaw als Direktor am 28. Aug. 2012

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Philip Martin Stone als Geschäftsführer am 28. Aug. 2012

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Richard Anthony Bowler als Geschäftsführer am 28. Aug. 2012

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    12 SeitenAA

    Änderung der Details des Sekretärs für Ms Elizabeth Anne Thorpe am 26. Mai 2012

    1 SeitenCH03

    Jahresrückblick erstellt bis 09. Nov. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital10. Nov. 2011

    Kapitalaufstellung am 10. Nov. 2011

    • Kapital: GBP 787,977.64
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    7 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 09. Nov. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    6 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Malcolm Gilkerson als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 09. Nov. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Malcolm Gilkerson am 10. Nov. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Philip Martin Stone am 10. Nov. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Richard Anthony Bowler am 10. Nov. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Ms Elizabeth Anne Thorpe am 10. Nov. 2009

    1 SeitenCH03

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    6 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    6 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten363a

    Wer sind die Geschäftsführer von MTL TRUST HOLDINGS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    DAVIES, Elizabeth Anne
    1 Admiral Way
    Doxford International Business
    SR3 3XP Park Sunderland
    Tyne & Wear
    Sekretär
    1 Admiral Way
    Doxford International Business
    SR3 3XP Park Sunderland
    Tyne & Wear
    British102907000002
    CARLAW, Kenneth Mcintyre
    James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11 Clifton Moor Business Village
    Geschäftsführer
    James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11 Clifton Moor Business Village
    EnglandBritishCompany Director161250030001
    BARLOW, Timothy John
    Oakdene 8 Thorley Lane
    Timperley
    WA15 7AZ Altrincham
    Cheshire
    Sekretär
    Oakdene 8 Thorley Lane
    Timperley
    WA15 7AZ Altrincham
    Cheshire
    BritishCompany Director79736350001
    BRADSHAW, Ronald Paul
    28 South Road
    Grassendale Park
    L19 0LT Liverpool
    Merseyside
    Sekretär
    28 South Road
    Grassendale Park
    L19 0LT Liverpool
    Merseyside
    British51422490001
    CAMPBELL, Iain Fraser
    3 Hallgate
    Daisy Hill Westhoughton
    BL5 2SF Bolton
    Lancashire
    Sekretär
    3 Hallgate
    Daisy Hill Westhoughton
    BL5 2SF Bolton
    Lancashire
    BritishCompany Director66379980001
    MILLINGTON, Ronald Gordon
    3 Teddington Close
    Dudlows Green
    WA4 5QG Warrington
    Cheshire
    Sekretär
    3 Teddington Close
    Dudlows Green
    WA4 5QG Warrington
    Cheshire
    BritishFinance Director & Company Secretary30257840002
    STRONACH, James Barker Robertson
    Arden Court 26 The Avenue
    Healing
    DN37 7NE Grimsby
    South Humberside
    Sekretär
    Arden Court 26 The Avenue
    Healing
    DN37 7NE Grimsby
    South Humberside
    BritishDirector69924310002
    TURNER, David Paul
    139 Eastern Way Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9RH Newcastle Upon Tyne
    Sekretär
    139 Eastern Way Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9RH Newcastle Upon Tyne
    British48937720001
    WOODWARD, Deborah Anne
    37a Lavender Gardens
    SW11 1DJ London
    Sekretär
    37a Lavender Gardens
    SW11 1DJ London
    British3219400004
    BOWLER, Richard Anthony
    1 Admiral Way
    Doxford International Business
    SR3 3XP Park Sunderland
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    1 Admiral Way
    Doxford International Business
    SR3 3XP Park Sunderland
    Tyne & Wear
    United KingdomBritishCompany Director35116070001
    BRADSHAW, Ronald Paul
    28 South Road
    Grassendale Park
    L19 0LT Liverpool
    Merseyside
    Geschäftsführer
    28 South Road
    Grassendale Park
    L19 0LT Liverpool
    Merseyside
    BritishSolicitor51422490001
    BRADY, Dominic
    54 High Street
    Hale Village
    L24 4AF Liverpool
    Merseyside
    Geschäftsführer
    54 High Street
    Hale Village
    L24 4AF Liverpool
    Merseyside
    UkBritishDirector125406360001
    CAMPBELL, Iain Fraser
    3 Hallgate
    Daisy Hill Westhoughton
    BL5 2SF Bolton
    Lancashire
    Geschäftsführer
    3 Hallgate
    Daisy Hill Westhoughton
    BL5 2SF Bolton
    Lancashire
    BritishDirector66379980001
    CHAPPLE GILL, Sandy Timothy
    80 Russell Road
    Mossley Hill
    L18 1EB Liverpool
    Merseyside
    Geschäftsführer
    80 Russell Road
    Mossley Hill
    L18 1EB Liverpool
    Merseyside
    BritishSolicitor55914280001
    CLAYTON, Stephen John
    New Hall Farmhouse Fanhams Hall
    Road Newhall Green Wareside
    SG12 7SD Ware
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    New Hall Farmhouse Fanhams Hall
    Road Newhall Green Wareside
    SG12 7SD Ware
    Hertfordshire
    EnglandBritishCompany Director46866840005
    COLEMAN, Alan Hague
    17 Kent Close
    Bromborough
    L63 0EF Wirral
    Merseyside
    Geschäftsführer
    17 Kent Close
    Bromborough
    L63 0EF Wirral
    Merseyside
    BritishPlanning Director18844210001
    COOMBES, Peter Geoffrey
    7 Mclauchlan Rise
    Aberdour
    KY3 0SS Burntisland
    Fife
    Scotland
    Geschäftsführer
    7 Mclauchlan Rise
    Aberdour
    KY3 0SS Burntisland
    Fife
    Scotland
    BritishChief Executive34146400001
    DALEY, James
    103 Bray Road
    Speke
    L24 3TL Liverpool
    Merseyside
    Geschäftsführer
    103 Bray Road
    Speke
    L24 3TL Liverpool
    Merseyside
    BritishClerical Officer32523310001
    DAVIES, Keith Henry
    8 Abbotts Close
    L18 7LA Liverpool
    Merseyside
    Geschäftsführer
    8 Abbotts Close
    L18 7LA Liverpool
    Merseyside
    United KingdomBritishDriver/Operator34109000001
    DAWSON, Robert, Doctor
    6 The Copse
    Eaves Green
    PR7 3PS Chorley
    Lancashire
    Geschäftsführer
    6 The Copse
    Eaves Green
    PR7 3PS Chorley
    Lancashire
    BritishDirector75187760001
    EVANS, David Martin
    18 Forest Road
    PR8 6ST Southport
    Merseyside
    Geschäftsführer
    18 Forest Road
    PR8 6ST Southport
    Merseyside
    BritishBus Driver32523340001
    EVANS, Paul
    252 Mackets Lane
    Halewood
    L25 9RT Liverpool
    Geschäftsführer
    252 Mackets Lane
    Halewood
    L25 9RT Liverpool
    BritishDriver45836770001
    FULLER, Colin Eric
    Broadmore House
    Broadmore Lane
    ST18 0LD Stowe-By-Chartley
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Broadmore House
    Broadmore Lane
    ST18 0LD Stowe-By-Chartley
    Staffordshire
    EnglandBritishCompany Director59600860003
    GILKERSON, Malcolm
    1 Admiral Way
    Doxford International Business
    SR3 3XP Park Sunderland
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    1 Admiral Way
    Doxford International Business
    SR3 3XP Park Sunderland
    Tyne & Wear
    United KingdomBritishEngineering Director46793270001
    HIND, Robert Andrew
    18 Maplewell Road
    Woodhouse Eaves
    LE12 8QZ Loughborough
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    18 Maplewell Road
    Woodhouse Eaves
    LE12 8QZ Loughborough
    Leicestershire
    United KingdomBritishCompany Director21961900002
    JOLLIFFE, Norman
    37 Fields End
    Huyton With Roby
    L36 5YQ Liverpool
    Merseyside
    Geschäftsführer
    37 Fields End
    Huyton With Roby
    L36 5YQ Liverpool
    Merseyside
    BritishBus Driver32708350001
    LLOYD, George Anthony
    24 Long Lane
    Wavertree
    L15 4HF Liverpool
    Merseyside
    Geschäftsführer
    24 Long Lane
    Wavertree
    L15 4HF Liverpool
    Merseyside
    BritishDriver51035790001
    LONSDALE, Stephen Philip
    5 Lintfort
    Picktree Farm Picktree
    NE38 9HX Chester Le Street
    County Durham
    Geschäftsführer
    5 Lintfort
    Picktree Farm Picktree
    NE38 9HX Chester Le Street
    County Durham
    United KingdomBritishChartered Accountant4971910001
    LOTHIAN, John Alexander
    74 Serpentine Road
    CH44 0AZ Wallasey
    Merseyside
    Geschäftsführer
    74 Serpentine Road
    CH44 0AZ Wallasey
    Merseyside
    BritishDriver34119170001
    MARTIN, David Robert
    Bondwood Barn Repton Shrubs
    Bretby
    DE15 0RJ Burton On Trent
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Bondwood Barn Repton Shrubs
    Bretby
    DE15 0RJ Burton On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritishCompany Director6874440001
    MCCANN, John Patrick
    44 Southmead Road
    Garston
    L19 5NB Liverpool
    Geschäftsführer
    44 Southmead Road
    Garston
    L19 5NB Liverpool
    BritishBus Driver34326540001
    MILLINGTON, Ronald Gordon
    3 Teddington Close
    Dudlows Green
    WA4 5QG Warrington
    Cheshire
    Geschäftsführer
    3 Teddington Close
    Dudlows Green
    WA4 5QG Warrington
    Cheshire
    BritishFinance Director & Company Secretary30257840002
    PRINCE, Michael John
    Holt Green House
    2 Brookfield Lane
    L39 6SP Aughton
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Holt Green House
    2 Brookfield Lane
    L39 6SP Aughton
    Lancashire
    EnglandBritishSolicitor40552310001
    RAFFLE, Timothy David
    Cramond House
    Regent Road
    WA14 1RR Altrincham
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Cramond House
    Regent Road
    WA14 1RR Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritishVenture Capitalist59084430001
    RAY, John Alfred
    50 The Gables
    Sedgefield
    TS21 3EU Stockton On Tees
    Cleveland
    Geschäftsführer
    50 The Gables
    Sedgefield
    TS21 3EU Stockton On Tees
    Cleveland
    BritishCompany Director58415290001

    Hat MTL TRUST HOLDINGS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Fixed charge over property interests
    Erstellt am 10. Jan. 2000
    Geliefert am 13. Jan. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from merseyside transport limited to the chargee under or pursuant to the mtl counter indemnity
    Kurze Angaben
    Freehold property k/a land and buildings comprising carnegie road garage green lane liverpool t/n MS379385 for further property charged please refer to form 395 together with the proceeds of sale all plant machinery all contracts and policies of insurance.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Jan. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Sept. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Key-man policies assignment
    Erstellt am 04. Jan. 1999
    Geliefert am 12. Jan. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All money and liabilities now or in the future due owing or incurred by the company or by any group company (as defined) to each beneficiary (as defined) under or pursuant to the finance documents (as defined) whether as principal or surety and whether or not the rlevant beneficiary was an original party to the relevant transaction
    Kurze Angaben
    The key-man policy being a policy on the life of peter geoffrey coombs in the sum of £1,000,000 with general accident life assurance policy no 272752OLE together with all substituted policies relating thereto and all monies including bonuses accrued please refer to form 395 for full details. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Jan. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Sept. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 04. Jan. 1999
    Geliefert am 12. Jan. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All money and liabilities now or in the future due owing or incurred by the chargor and each other company (except as a guarantor for the chargor) to the chargee under or pursuant to the finance documents
    Kurze Angaben
    By way of first legal mortgage all freehold and leasehold land as specified in part iv of the schedule to form 395 (see form for details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Jan. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Sept. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 14. Dez. 1998
    Geliefert am 24. Dez. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies and liabilities due owing or incurred from the company and all or any of the other companies named therein to the chargee (as security agent) and to each beneficiary (as defined) under or pursuant to the finance documents
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Dez. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Sept. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over deposit account
    Erstellt am 20. Mai 1997
    Geliefert am 09. Juni 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the underlease of even date and the indebtedness (as defined)
    Kurze Angaben
    All the assignor's rights title interest and benefit in all monies which are from time to time standing to the credit of the company on the account with the co-operative bank PLC account number 97885937. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Second Rood Hill Leasing Limited
    Transaktionen
    • 09. Juni 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Dez. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 22. Apr. 1997
    Geliefert am 25. Apr. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a lease of even date
    Kurze Angaben
    The sum of £8000 maintained in an interest earning account maintained at a clearing bank or building society together with the amount from time to time standing to the credit of such account including accrued interest not paid to thecompany.
    Berechtigte Personen
    • Allnatt London Properties PLC
    Transaktionen
    • 25. Apr. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Sept. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 07. Feb. 1997
    Geliefert am 27. Feb. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as security trustee on behalf of the beneficiaries as identified in the debenture dated 3RD july 1996) under the terms of this supplemental debenture dated 7TH february 1997 or by the debenture dated 3RD july 1996 (as supplemented by a supplemental deed dated 19TH december 1996)
    Kurze Angaben
    The company with full title guarantee charges in favour of the security trustee all its property, assets and undertaking on the terms set out in clause 4 of the debenture (as defined).. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • First National Bank of Boston
    Transaktionen
    • 27. Feb. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Jan. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 03. Juli 1996
    Geliefert am 22. Juli 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys obligations and liabilities due or to become due from the company or by any other company named therein to the chargee under the facility agreement and/or the security documents as defined in the guarantee and debenture
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings comprising edge lane works and garage liverpool, f/h land and buildings carnegie road garage green lane liverpool f/h land and buildings garston bus depot speke road liverpool t/no MS156996 f/h land and buildings gilmoss garage east lancashire road gilmoss liverpool and all the other properties as detailed in part v of the form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The First National Bank of Boston as Agent and Trustee for the Beneficiaries
    Transaktionen
    • 22. Juli 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Jan. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A deed of assignment of life policies
    Erstellt am 19. Sept. 1995
    Geliefert am 27. Sept. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due, in whatever manner, from the company or from any other charging company to:- barclays bank PLC under the facilities agreement dated 26TH october 1994 and/or the swap agreements; or intermediate capital group PLC or the mezzanine lenders under the mezzanine loan agreement; or the eci funds under the subordiated loan agreement and/or to any of them under the security documents (all defined terms above are as defined in the deed of assignment of life policies and the documents mentioned therein)
    Kurze Angaben
    Assigns all right title and interest in and to the policies being:-the key-man policies, policy numbers 2727520LE and 2727514LT and all other policies of whatsoever nature from time to time assigned including all new, amended and substituted policies relating thereto and all monies including bonuses accrued or which may accrue at any time after commencement date. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Sept. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Juli 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture as supplemented by a supplemental deed to the guarantee and debenture dated 26TH october 1994 and created by london northern bus limited
    Erstellt am 26. Okt. 1994
    Geliefert am 11. Nov. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the "security documents" (as defined in the charge)
    Kurze Angaben
    Various properties as specified on form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Nov. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Aug. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    • 20. Juli 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Dez. 1992
    Erworben am 03. Juli 1996
    Geliefert am 18. Juli 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or in respect of clause 5.4 of an agreement dated 17TH december 1992 on any account whatsoever under or in respect of the charge
    Kurze Angaben
    Part of the bus depot, speke road, garston, liverpool t/no: MS136996. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Merseyside Passenger Transport Authority
    Transaktionen
    • 18. Juli 1996Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 20. Aug. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 17. Dez. 1992
    Erworben am 03. Juli 1996
    Geliefert am 17. Juli 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Securing all monies
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Merseyside Passenger Transport Authority
    Transaktionen
    • 17. Juli 1996Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 28. Jan. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Dez. 1992
    Erworben am 03. Juli 1996
    Geliefert am 17. Juli 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Securing all monies
    Kurze Angaben
    F/H part of the bus depot and premises jackson street st.helens lancashire.
    Berechtigte Personen
    • Merseyside Passenger Transport Authority
    Transaktionen
    • 17. Juli 1996Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 28. Jan. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Dez. 1992
    Erworben am 03. Juli 1996
    Geliefert am 17. Juli 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Securing all monies
    Kurze Angaben
    F/H property stanley bus park cheadle avenue green lane liverpool.
    Berechtigte Personen
    • Merseyside Passenger Transport Authority
    Transaktionen
    • 17. Juli 1996Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 28. Jan. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Dez. 1992
    Erworben am 03. Juli 1996
    Geliefert am 17. Juli 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Securing all monies
    Kurze Angaben
    F/H property offices and bus park at hall street/shaw street st.helens lancashire.
    Berechtigte Personen
    • Merseyside Passenger Transport Authority
    Transaktionen
    • 17. Juli 1996Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 28. Jan. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Dez. 1992
    Erworben am 03. Juli 1996
    Geliefert am 17. Juli 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Securing all monies
    Kurze Angaben
    F/H property the bus depot carnegie road/green lane liverpool.
    Berechtigte Personen
    • Merseyside Passenger Transport Authority
    Transaktionen
    • 17. Juli 1996Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 28. Jan. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Dez. 1992
    Erworben am 03. Juli 1996
    Geliefert am 17. Juli 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Securing all monies
    Kurze Angaben
    F/H property edge lane works and garage edge lane liverpool.
    Berechtigte Personen
    • Merseyside Passenger Transport Authority
    Transaktionen
    • 17. Juli 1996Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 20. Aug. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Dez. 1992
    Erworben am 03. Juli 1996
    Geliefert am 17. Juli 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Securing all monies
    Kurze Angaben
    F/H property comprising the bus garage shaw road speke liverpool.
    Berechtigte Personen
    • Merseyside Passenger Transport Authority
    Transaktionen
    • 17. Juli 1996Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 28. Jan. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Dez. 1992
    Erworben am 03. Juli 1996
    Geliefert am 17. Juli 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Securing all monies
    Kurze Angaben
    F/H property gillmoss bus depot east lancashire road gillmoss liverpool.
    Berechtigte Personen
    • Merseyside Passenger Transport Authority
    Transaktionen
    • 17. Juli 1996Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 28. Jan. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Dez. 1992
    Erworben am 03. Juli 1996
    Geliefert am 17. Juli 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Securing all monies
    Kurze Angaben
    F/H bus depot laird street birkenhead merseyside. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Merseyside Passenger Transport Authority
    Transaktionen
    • 17. Juli 1996Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 28. Jan. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Dez. 1992
    Erworben am 03. Juli 1996
    Geliefert am 17. Juli 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Securing all monies
    Kurze Angaben
    F/H property bus garage canning road/cobden road southport lancashire. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Merseyside Passenger Transport Authority
    Transaktionen
    • 17. Juli 1996Registrierung eines Erwerbs (400)
    • 28. Jan. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 17. Dez. 1992
    Geliefert am 06. Jan. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Merseyside Passenger Transport Authority
    Transaktionen
    • 06. Jan. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Jan. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat MTL TRUST HOLDINGS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    08. Apr. 2013Aufgelöst am
    04. Sept. 2012Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Rob Sadler
    Begbies Traynor (Central) Llp 11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link, Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Praktiker
    Begbies Traynor (Central) Llp 11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link, Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Andrew Timothy Clay
    11 Clifton Moor Business Village James Nicholson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Praktiker
    11 Clifton Moor Business Village James Nicholson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0