MTL TRUST HOLDINGS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | MTL TRUST HOLDINGS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02764434 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MTL TRUST HOLDINGS LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich MTL TRUST HOLDINGS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 11 Clifton Moor Business Village James Nicolson Link Clifton Moor YO30 4XG York |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MTL TRUST HOLDINGS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für MTL TRUST HOLDINGS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 8 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 1 Admiral Way Doxford International Business Park Sunderland Tyne & Wear SR3 3XP am 14. Sept. 2012 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Kenneth Mcintyre Carlaw als Direktor am 28. Aug. 2012 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Philip Martin Stone als Geschäftsführer am 28. Aug. 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Anthony Bowler als Geschäftsführer am 28. Aug. 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Ms Elizabeth Anne Thorpe am 26. Mai 2012 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 09. Nov. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 09. Nov. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Malcolm Gilkerson als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 09. Nov. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Malcolm Gilkerson am 10. Nov. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Philip Martin Stone am 10. Nov. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Richard Anthony Bowler am 10. Nov. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Ms Elizabeth Anne Thorpe am 10. Nov. 2009 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a |
Wer sind die Geschäftsführer von MTL TRUST HOLDINGS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVIES, Elizabeth Anne | Sekretär | 1 Admiral Way Doxford International Business SR3 3XP Park Sunderland Tyne & Wear | British | 102907000002 | ||||||
CARLAW, Kenneth Mcintyre | Geschäftsführer | James Nicolson Link Clifton Moor YO30 4XG York 11 Clifton Moor Business Village | England | British | Company Director | 161250030001 | ||||
BARLOW, Timothy John | Sekretär | Oakdene 8 Thorley Lane Timperley WA15 7AZ Altrincham Cheshire | British | Company Director | 79736350001 | |||||
BRADSHAW, Ronald Paul | Sekretär | 28 South Road Grassendale Park L19 0LT Liverpool Merseyside | British | 51422490001 | ||||||
CAMPBELL, Iain Fraser | Sekretär | 3 Hallgate Daisy Hill Westhoughton BL5 2SF Bolton Lancashire | British | Company Director | 66379980001 | |||||
MILLINGTON, Ronald Gordon | Sekretär | 3 Teddington Close Dudlows Green WA4 5QG Warrington Cheshire | British | Finance Director & Company Secretary | 30257840002 | |||||
STRONACH, James Barker Robertson | Sekretär | Arden Court 26 The Avenue Healing DN37 7NE Grimsby South Humberside | British | Director | 69924310002 | |||||
TURNER, David Paul | Sekretär | 139 Eastern Way Darras Hall Ponteland NE20 9RH Newcastle Upon Tyne | British | 48937720001 | ||||||
WOODWARD, Deborah Anne | Sekretär | 37a Lavender Gardens SW11 1DJ London | British | 3219400004 | ||||||
BOWLER, Richard Anthony | Geschäftsführer | 1 Admiral Way Doxford International Business SR3 3XP Park Sunderland Tyne & Wear | United Kingdom | British | Company Director | 35116070001 | ||||
BRADSHAW, Ronald Paul | Geschäftsführer | 28 South Road Grassendale Park L19 0LT Liverpool Merseyside | British | Solicitor | 51422490001 | |||||
BRADY, Dominic | Geschäftsführer | 54 High Street Hale Village L24 4AF Liverpool Merseyside | Uk | British | Director | 125406360001 | ||||
CAMPBELL, Iain Fraser | Geschäftsführer | 3 Hallgate Daisy Hill Westhoughton BL5 2SF Bolton Lancashire | British | Director | 66379980001 | |||||
CHAPPLE GILL, Sandy Timothy | Geschäftsführer | 80 Russell Road Mossley Hill L18 1EB Liverpool Merseyside | British | Solicitor | 55914280001 | |||||
CLAYTON, Stephen John | Geschäftsführer | New Hall Farmhouse Fanhams Hall Road Newhall Green Wareside SG12 7SD Ware Hertfordshire | England | British | Company Director | 46866840005 | ||||
COLEMAN, Alan Hague | Geschäftsführer | 17 Kent Close Bromborough L63 0EF Wirral Merseyside | British | Planning Director | 18844210001 | |||||
COOMBES, Peter Geoffrey | Geschäftsführer | 7 Mclauchlan Rise Aberdour KY3 0SS Burntisland Fife Scotland | British | Chief Executive | 34146400001 | |||||
DALEY, James | Geschäftsführer | 103 Bray Road Speke L24 3TL Liverpool Merseyside | British | Clerical Officer | 32523310001 | |||||
DAVIES, Keith Henry | Geschäftsführer | 8 Abbotts Close L18 7LA Liverpool Merseyside | United Kingdom | British | Driver/Operator | 34109000001 | ||||
DAWSON, Robert, Doctor | Geschäftsführer | 6 The Copse Eaves Green PR7 3PS Chorley Lancashire | British | Director | 75187760001 | |||||
EVANS, David Martin | Geschäftsführer | 18 Forest Road PR8 6ST Southport Merseyside | British | Bus Driver | 32523340001 | |||||
EVANS, Paul | Geschäftsführer | 252 Mackets Lane Halewood L25 9RT Liverpool | British | Driver | 45836770001 | |||||
FULLER, Colin Eric | Geschäftsführer | Broadmore House Broadmore Lane ST18 0LD Stowe-By-Chartley Staffordshire | England | British | Company Director | 59600860003 | ||||
GILKERSON, Malcolm | Geschäftsführer | 1 Admiral Way Doxford International Business SR3 3XP Park Sunderland Tyne & Wear | United Kingdom | British | Engineering Director | 46793270001 | ||||
HIND, Robert Andrew | Geschäftsführer | 18 Maplewell Road Woodhouse Eaves LE12 8QZ Loughborough Leicestershire | United Kingdom | British | Company Director | 21961900002 | ||||
JOLLIFFE, Norman | Geschäftsführer | 37 Fields End Huyton With Roby L36 5YQ Liverpool Merseyside | British | Bus Driver | 32708350001 | |||||
LLOYD, George Anthony | Geschäftsführer | 24 Long Lane Wavertree L15 4HF Liverpool Merseyside | British | Driver | 51035790001 | |||||
LONSDALE, Stephen Philip | Geschäftsführer | 5 Lintfort Picktree Farm Picktree NE38 9HX Chester Le Street County Durham | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 4971910001 | ||||
LOTHIAN, John Alexander | Geschäftsführer | 74 Serpentine Road CH44 0AZ Wallasey Merseyside | British | Driver | 34119170001 | |||||
MARTIN, David Robert | Geschäftsführer | Bondwood Barn Repton Shrubs Bretby DE15 0RJ Burton On Trent Staffordshire | United Kingdom | British | Company Director | 6874440001 | ||||
MCCANN, John Patrick | Geschäftsführer | 44 Southmead Road Garston L19 5NB Liverpool | British | Bus Driver | 34326540001 | |||||
MILLINGTON, Ronald Gordon | Geschäftsführer | 3 Teddington Close Dudlows Green WA4 5QG Warrington Cheshire | British | Finance Director & Company Secretary | 30257840002 | |||||
PRINCE, Michael John | Geschäftsführer | Holt Green House 2 Brookfield Lane L39 6SP Aughton Lancashire | England | British | Solicitor | 40552310001 | ||||
RAFFLE, Timothy David | Geschäftsführer | Cramond House Regent Road WA14 1RR Altrincham Cheshire | England | British | Venture Capitalist | 59084430001 | ||||
RAY, John Alfred | Geschäftsführer | 50 The Gables Sedgefield TS21 3EU Stockton On Tees Cleveland | British | Company Director | 58415290001 |
Hat MTL TRUST HOLDINGS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Fixed charge over property interests | Erstellt am 10. Jan. 2000 Geliefert am 13. Jan. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from merseyside transport limited to the chargee under or pursuant to the mtl counter indemnity | |
Kurze Angaben Freehold property k/a land and buildings comprising carnegie road garage green lane liverpool t/n MS379385 for further property charged please refer to form 395 together with the proceeds of sale all plant machinery all contracts and policies of insurance. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Key-man policies assignment | Erstellt am 04. Jan. 1999 Geliefert am 12. Jan. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All money and liabilities now or in the future due owing or incurred by the company or by any group company (as defined) to each beneficiary (as defined) under or pursuant to the finance documents (as defined) whether as principal or surety and whether or not the rlevant beneficiary was an original party to the relevant transaction | |
Kurze Angaben The key-man policy being a policy on the life of peter geoffrey coombs in the sum of £1,000,000 with general accident life assurance policy no 272752OLE together with all substituted policies relating thereto and all monies including bonuses accrued please refer to form 395 for full details. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & debenture | Erstellt am 04. Jan. 1999 Geliefert am 12. Jan. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All money and liabilities now or in the future due owing or incurred by the chargor and each other company (except as a guarantor for the chargor) to the chargee under or pursuant to the finance documents | |
Kurze Angaben By way of first legal mortgage all freehold and leasehold land as specified in part iv of the schedule to form 395 (see form for details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee and debenture | Erstellt am 14. Dez. 1998 Geliefert am 24. Dez. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies and liabilities due owing or incurred from the company and all or any of the other companies named therein to the chargee (as security agent) and to each beneficiary (as defined) under or pursuant to the finance documents | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge over deposit account | Erstellt am 20. Mai 1997 Geliefert am 09. Juni 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the underlease of even date and the indebtedness (as defined) | |
Kurze Angaben All the assignor's rights title interest and benefit in all monies which are from time to time standing to the credit of the company on the account with the co-operative bank PLC account number 97885937. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Rent deposit deed | Erstellt am 22. Apr. 1997 Geliefert am 25. Apr. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under a lease of even date | |
Kurze Angaben The sum of £8000 maintained in an interest earning account maintained at a clearing bank or building society together with the amount from time to time standing to the credit of such account including accrued interest not paid to thecompany. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental debenture | Erstellt am 07. Feb. 1997 Geliefert am 27. Feb. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee (as security trustee on behalf of the beneficiaries as identified in the debenture dated 3RD july 1996) under the terms of this supplemental debenture dated 7TH february 1997 or by the debenture dated 3RD july 1996 (as supplemented by a supplemental deed dated 19TH december 1996) | |
Kurze Angaben The company with full title guarantee charges in favour of the security trustee all its property, assets and undertaking on the terms set out in clause 4 of the debenture (as defined).. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee and debenture | Erstellt am 03. Juli 1996 Geliefert am 22. Juli 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys obligations and liabilities due or to become due from the company or by any other company named therein to the chargee under the facility agreement and/or the security documents as defined in the guarantee and debenture | |
Kurze Angaben F/H land and buildings comprising edge lane works and garage liverpool, f/h land and buildings carnegie road garage green lane liverpool f/h land and buildings garston bus depot speke road liverpool t/no MS156996 f/h land and buildings gilmoss garage east lancashire road gilmoss liverpool and all the other properties as detailed in part v of the form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A deed of assignment of life policies | Erstellt am 19. Sept. 1995 Geliefert am 27. Sept. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due, in whatever manner, from the company or from any other charging company to:- barclays bank PLC under the facilities agreement dated 26TH october 1994 and/or the swap agreements; or intermediate capital group PLC or the mezzanine lenders under the mezzanine loan agreement; or the eci funds under the subordiated loan agreement and/or to any of them under the security documents (all defined terms above are as defined in the deed of assignment of life policies and the documents mentioned therein) | |
Kurze Angaben Assigns all right title and interest in and to the policies being:-the key-man policies, policy numbers 2727520LE and 2727514LT and all other policies of whatsoever nature from time to time assigned including all new, amended and substituted policies relating thereto and all monies including bonuses accrued or which may accrue at any time after commencement date. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee and debenture as supplemented by a supplemental deed to the guarantee and debenture dated 26TH october 1994 and created by london northern bus limited | Erstellt am 26. Okt. 1994 Geliefert am 11. Nov. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the "security documents" (as defined in the charge) | |
Kurze Angaben Various properties as specified on form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 17. Dez. 1992 Erworben am 03. Juli 1996 Geliefert am 18. Juli 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or in respect of clause 5.4 of an agreement dated 17TH december 1992 on any account whatsoever under or in respect of the charge | |
Kurze Angaben Part of the bus depot, speke road, garston, liverpool t/no: MS136996. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & debenture | Erstellt am 17. Dez. 1992 Erworben am 03. Juli 1996 Geliefert am 17. Juli 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Securing all monies | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 17. Dez. 1992 Erworben am 03. Juli 1996 Geliefert am 17. Juli 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Securing all monies | |
Kurze Angaben F/H part of the bus depot and premises jackson street st.helens lancashire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 17. Dez. 1992 Erworben am 03. Juli 1996 Geliefert am 17. Juli 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Securing all monies | |
Kurze Angaben F/H property stanley bus park cheadle avenue green lane liverpool. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 17. Dez. 1992 Erworben am 03. Juli 1996 Geliefert am 17. Juli 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Securing all monies | |
Kurze Angaben F/H property offices and bus park at hall street/shaw street st.helens lancashire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 17. Dez. 1992 Erworben am 03. Juli 1996 Geliefert am 17. Juli 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Securing all monies | |
Kurze Angaben F/H property the bus depot carnegie road/green lane liverpool. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 17. Dez. 1992 Erworben am 03. Juli 1996 Geliefert am 17. Juli 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Securing all monies | |
Kurze Angaben F/H property edge lane works and garage edge lane liverpool. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 17. Dez. 1992 Erworben am 03. Juli 1996 Geliefert am 17. Juli 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Securing all monies | |
Kurze Angaben F/H property comprising the bus garage shaw road speke liverpool. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 17. Dez. 1992 Erworben am 03. Juli 1996 Geliefert am 17. Juli 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Securing all monies | |
Kurze Angaben F/H property gillmoss bus depot east lancashire road gillmoss liverpool. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 17. Dez. 1992 Erworben am 03. Juli 1996 Geliefert am 17. Juli 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Securing all monies | |
Kurze Angaben F/H bus depot laird street birkenhead merseyside. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 17. Dez. 1992 Erworben am 03. Juli 1996 Geliefert am 17. Juli 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Securing all monies | |
Kurze Angaben F/H property bus garage canning road/cobden road southport lancashire. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 17. Dez. 1992 Geliefert am 06. Jan. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat MTL TRUST HOLDINGS LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0