MEP SOLUTIONS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | MEP SOLUTIONS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02769705 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MEP SOLUTIONS LIMITED?
- Herstellung von Metallkonstruktionen und Teilen von Konstruktionen (25110) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich MEP SOLUTIONS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | c/o DELOITTE LLP Four Brindley Place B1 2HZ Birmingham |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von MEP SOLUTIONS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| A-BELCO LIMITED | 12. Okt. 2001 | 12. Okt. 2001 |
| BALS ENGINEERING GROUP LIMITED | 20. Aug. 1993 | 20. Aug. 1993 |
| COPYLIMIT LIMITED | 01. Dez. 1992 | 01. Dez. 1992 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MEP SOLUTIONS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2015 |
Welche sind die letzten Einreichungen für MEP SOLUTIONS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung | 19 Seiten | AM23 | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 19 Seiten | AM10 | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 20 Seiten | AM10 | ||||||||||
Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung | 3 Seiten | AM19 | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters | 20 Seiten | AM10 | ||||||||||
Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge | 41 Seiten | F2.18 | ||||||||||
Vorschlag des Verwalters | 41 Seiten | 2.17B | ||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular 2.14B | 8 Seiten | 2.16B | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Deloitte Four Brindley Place Birmingham B1 2HZ zum C/O Deloitte Llp Four Brindley Place Birmingham B1 2HZ am 10. Nov. 2016 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Jubilee Industrial Estate Ashington Northumberland NE63 8UG zum Deloitte Four Brindley Place Birmingham B1 2HZ am 02. Nov. 2016 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines Verwalters | 1 Seiten | 2.12B | ||||||||||
Eintragung der Belastung 027697050012, erstellt am 21. Juni 2016 | 39 Seiten | MR01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. März 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2015 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Kevin Robert Wills als Direktor am 03. Nov. 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Linda Billings als Geschäftsführer am 30. Apr. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. März 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2014 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Eintragung der Belastung 027697050011 | 32 Seiten | MR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. März 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Kapitalaufstellung am 14. März 2014
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 027697050010 | 33 Seiten | MR01 | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von MEP SOLUTIONS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRENCH, Brian Irving | Sekretär | c/o Deloitte Llp Brindley Place B1 2HZ Birmingham Four | 152515670001 | |||||||
| TRENCH, Brian Irving | Geschäftsführer | c/o Deloitte Llp Brindley Place B1 2HZ Birmingham Four | United Kingdom | British | 110877740001 | |||||
| WILLS, Kevin Robert | Geschäftsführer | c/o Deloitte Llp Brindley Place B1 2HZ Birmingham Four | England | British | 106492050001 | |||||
| ALLAN, Peter Riddle | Sekretär | Valley View Iveston Lane DH8 7TD Consett County Durham | British | 35573440002 | ||||||
| JACKSON, Stephen | Sekretär | 39 Highside Drive Humbledon Hill SR3 1UL Sunderland Tyne & Wear | British | 36996160001 | ||||||
| KELLY, Michael John | Sekretär | Threeways Tranwell Woods NE61 6AQ Morpeth Northumberland | British | 36411030002 | ||||||
| KETCHIN, John Scott | Sekretär | 65 Cheviot View Ponteland NE20 9BH Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 19040640001 | ||||||
| WATSON, Alan Roy | Sekretär | 5 Thornlea NE61 6NY Hepscott Northumberland | British | 93102570001 | ||||||
| JL NOMINEES TWO LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 1 Saville Chambers 5 North Street NE1 8DF Newcastle Upon Tyne | 900007220001 | |||||||
| BALS, Gunter | Geschäftsführer | Burgweg 23 Kirchhumden 57399 Germany | German | 39717660002 | ||||||
| BEGBIE, Roderick Mcintosh | Geschäftsführer | 17/1 St Leonards Lane EH8 9SD Edinburgh Midlothian Scotland | British | 54412390001 | ||||||
| BILLINGS, Linda | Geschäftsführer | Jubilee Industrial Estate Ashington NE63 8UG Northumberland | England | Irish | 111924870001 | |||||
| BROWN, Colin Martin | Geschäftsführer | Churchburn Drive Loansdean NE61 2BZ Morpeth 48 Northumberland | United Kingdom | British | 131092030001 | |||||
| DUFFY, Frank Thomas | Geschäftsführer | 6 South View Hepscott Park Stannington NE61 6NG Morpeth Northumberland | British | 36030990001 | ||||||
| DYER, Ian | Geschäftsführer | 13 Hareside Whitelea Glade NE23 6BH Cramlington Northumberland | United Kingdom | British | 39072930001 | |||||
| GIBSON, John | Geschäftsführer | 72 Heron Drive Sandal WF2 6SP Wakefield West Yorkshire | British | 37005950001 | ||||||
| HANDS, Stephen Christopher | Geschäftsführer | Flat 24 Tower House Tower Street NE1 2HW Newcastle Upon Tyne Tyne And Wear | British | 66910630002 | ||||||
| HUGHES, Robert Charles | Geschäftsführer | 15 Hawkshead Drive B93 9QE Knowle West Midlands | British | 84757480002 | ||||||
| JACKSON, Stephen | Geschäftsführer | 39 Highside Drive Humbledon Hill SR3 1UL Sunderland Tyne & Wear | United Kingdom | British | 36996160001 | |||||
| JASAT, Azim | Geschäftsführer | 3 Greenwood Close B14 6ET Birmingham West Midlands | British | 107438550001 | ||||||
| KELLY, Michael John | Geschäftsführer | Threeways Tranwell Woods NE61 6AQ Morpeth Northumberland | United Kingdom | British | 36411030002 | |||||
| KETCHIN, John Scott | Geschäftsführer | 65 Cheviot View Ponteland NE20 9BH Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | England | British | 19040640001 | |||||
| METCALF, Edward Alexander | Geschäftsführer | Oldfield House 11 Station Close NE44 6HE Riding Mill Northumberland | British | 31125570001 | ||||||
| MURRAY, Kenneth Roderick | Geschäftsführer | 42 St Andrews Square EH2 2AD Edinburgh | British | 43513870003 | ||||||
| POWELL, Robert | Geschäftsführer | Derry Jane House Stocks Hill Belton DN9 1PE Doncaster South Yorkshire | British | 37005880002 | ||||||
| SCHOLEY, Derek | Geschäftsführer | 228 Oakwood Lane LS8 2PE Leeds Yorkshire | British | 23788760001 | ||||||
| SKUCHA, Nicholas Paul | Geschäftsführer | 5 The Elms Porthill ST5 8RP Newcastle Under Lyme Staffordshire | United Kingdom | British | 117468110001 | |||||
| WATSON, Alan Roy | Geschäftsführer | 5 Thornlea NE61 6NY Hepscott Northumberland | England | British | 93102570001 | |||||
| JL NOMINEES ONE LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 1 Saville Chambers 5 North Street NE1 8DF Newcastle Upon Tyne | 900007210001 |
Hat MEP SOLUTIONS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 21. Juni 2016 Geliefert am 28. Juni 2016 | Ausstehend | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 30. Mai 2014 Geliefert am 04. Juni 2014 | Ausstehend | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 06. März 2014 Geliefert am 08. März 2014 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 16. Apr. 2010 Geliefert am 17. Apr. 2010 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 28. Nov. 2005 Geliefert am 30. Nov. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Deposit of £5,728.13. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture containing fixed and floating charges | Erstellt am 30. Sept. 2003 Geliefert am 07. Okt. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 07. Okt. 2002 Geliefert am 09. Okt. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over cash deposit created by the company (formerly known as bals engineering group limited) in favour of the bank | Erstellt am 04. Okt. 2001 Geliefert am 13. Okt. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All monies standing to the credit of the account of the company with bank of scotland which is blocked or designated as charged to bank of scotland now numbered 00136818 as may be replaced redesignated renumbered or rearranged from time to time. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 04. Okt. 2001 Geliefert am 09. Okt. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies and liabilities whether principal interest or otherwise which may now or at any time hereafter become due owing or payable by sandco 708 limited and/or bals industrial accessories limited to the chargees as listed in schedule 1 of a loan agreement dated 4 october 2001 and made between the company the security trustees and such lenders ("the loan agreement") | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignation of keyman policy | Erstellt am 25. Apr. 1997 Geliefert am 01. Mai 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Allied dunbar assurance PLC adaptable term plan, policy number 23036-088-das, date: 1/2/97, sum: £250,000, life assured: michael john kelly together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Collateral secured debenture | Erstellt am 07. Sept. 1994 Geliefert am 16. Sept. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from bals industrial accessories limited to the chargee under the terms of a debenture dated 7 september 1994 | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 22. Okt. 1993 Geliefert am 30. Okt. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat MEP SOLUTIONS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| In Verwaltung |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0