MEP SOLUTIONS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMEP SOLUTIONS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02769705
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MEP SOLUTIONS LIMITED?

    • Herstellung von Metallkonstruktionen und Teilen von Konstruktionen (25110) / Verarbeitendes Gewerbe

    Wo befindet sich MEP SOLUTIONS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o DELOITTE LLP
    Four
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von MEP SOLUTIONS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    A-BELCO LIMITED12. Okt. 200112. Okt. 2001
    BALS ENGINEERING GROUP LIMITED20. Aug. 199320. Aug. 1993
    COPYLIMIT LIMITED01. Dez. 199201. Dez. 1992

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MEP SOLUTIONS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2015

    Welche sind die letzten Einreichungen für MEP SOLUTIONS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung

    19 SeitenAM23

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    19 SeitenAM10

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    20 SeitenAM10

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    3 SeitenAM19

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    20 SeitenAM10

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    41 SeitenF2.18

    Vorschlag des Verwalters

    41 Seiten2.17B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    8 Seiten2.16B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Deloitte Four Brindley Place Birmingham B1 2HZ zum C/O Deloitte Llp Four Brindley Place Birmingham B1 2HZ am 10. Nov. 2016

    2 SeitenAD01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Jubilee Industrial Estate Ashington Northumberland NE63 8UG zum Deloitte Four Brindley Place Birmingham B1 2HZ am 02. Nov. 2016

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Eintragung der Belastung 027697050012, erstellt am 21. Juni 2016

    39 SeitenMR01

    Jahresrückblick erstellt bis 31. März 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital07. Apr. 2016

    Kapitalaufstellung am 07. Apr. 2016

    • Kapital: GBP 305,010.1
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2015

    17 SeitenAA

    Ernennung von Mr Kevin Robert Wills als Direktor am 03. Nov. 2015

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Linda Billings als Geschäftsführer am 30. Apr. 2015

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 31. März 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital29. Apr. 2015

    Kapitalaufstellung am 29. Apr. 2015

    • Kapital: GBP 305,010.1
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2014

    17 SeitenAA

    Eintragung der Belastung 027697050011

    32 SeitenMR01
    Anmerkungen
    DatumAnmerkung
    05. Juni 2014The electronic copy of the certified copy instrument associated with this transaction contains some elements which may not be legible. This is a result of a loss of definition in our image-conversion process. If you would like to view a copy of the instrument as presented to the registrar, please call 02920 381367.

    Jahresrückblick erstellt bis 31. März 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital09. Mai 2014

    Kapitalaufstellung am 09. Mai 2014

    • Kapital: GBP 305,010.1
    SH01

    Kapitalaufstellung am 14. März 2014

    • Kapital: GBP 305,010.1
    5 SeitenSH19

    Eintragung der Belastung 027697050010

    33 SeitenMR01

    legacy

    2 SeitenSH20

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Wer sind die Geschäftsführer von MEP SOLUTIONS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    TRENCH, Brian Irving
    c/o Deloitte Llp
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Four
    Sekretär
    c/o Deloitte Llp
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Four
    152515670001
    TRENCH, Brian Irving
    c/o Deloitte Llp
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Four
    Geschäftsführer
    c/o Deloitte Llp
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Four
    United KingdomBritish110877740001
    WILLS, Kevin Robert
    c/o Deloitte Llp
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Four
    Geschäftsführer
    c/o Deloitte Llp
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Four
    EnglandBritish106492050001
    ALLAN, Peter Riddle
    Valley View
    Iveston Lane
    DH8 7TD Consett
    County Durham
    Sekretär
    Valley View
    Iveston Lane
    DH8 7TD Consett
    County Durham
    British35573440002
    JACKSON, Stephen
    39 Highside Drive
    Humbledon Hill
    SR3 1UL Sunderland
    Tyne & Wear
    Sekretär
    39 Highside Drive
    Humbledon Hill
    SR3 1UL Sunderland
    Tyne & Wear
    British36996160001
    KELLY, Michael John
    Threeways
    Tranwell Woods
    NE61 6AQ Morpeth
    Northumberland
    Sekretär
    Threeways
    Tranwell Woods
    NE61 6AQ Morpeth
    Northumberland
    British36411030002
    KETCHIN, John Scott
    65 Cheviot View
    Ponteland
    NE20 9BH Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Sekretär
    65 Cheviot View
    Ponteland
    NE20 9BH Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British19040640001
    WATSON, Alan Roy
    5 Thornlea
    NE61 6NY Hepscott
    Northumberland
    Sekretär
    5 Thornlea
    NE61 6NY Hepscott
    Northumberland
    British93102570001
    JL NOMINEES TWO LIMITED
    1 Saville Chambers
    5 North Street
    NE1 8DF Newcastle Upon Tyne
    Bevollmächtigter Sekretär
    1 Saville Chambers
    5 North Street
    NE1 8DF Newcastle Upon Tyne
    900007220001
    BALS, Gunter
    Burgweg 23
    Kirchhumden 57399
    Germany
    Geschäftsführer
    Burgweg 23
    Kirchhumden 57399
    Germany
    German39717660002
    BEGBIE, Roderick Mcintosh
    17/1 St Leonards Lane
    EH8 9SD Edinburgh
    Midlothian
    Scotland
    Geschäftsführer
    17/1 St Leonards Lane
    EH8 9SD Edinburgh
    Midlothian
    Scotland
    British54412390001
    BILLINGS, Linda
    Jubilee Industrial Estate
    Ashington
    NE63 8UG Northumberland
    Geschäftsführer
    Jubilee Industrial Estate
    Ashington
    NE63 8UG Northumberland
    EnglandIrish111924870001
    BROWN, Colin Martin
    Churchburn Drive
    Loansdean
    NE61 2BZ Morpeth
    48
    Northumberland
    Geschäftsführer
    Churchburn Drive
    Loansdean
    NE61 2BZ Morpeth
    48
    Northumberland
    United KingdomBritish131092030001
    DUFFY, Frank Thomas
    6 South View
    Hepscott Park Stannington
    NE61 6NG Morpeth
    Northumberland
    Geschäftsführer
    6 South View
    Hepscott Park Stannington
    NE61 6NG Morpeth
    Northumberland
    British36030990001
    DYER, Ian
    13 Hareside
    Whitelea Glade
    NE23 6BH Cramlington
    Northumberland
    Geschäftsführer
    13 Hareside
    Whitelea Glade
    NE23 6BH Cramlington
    Northumberland
    United KingdomBritish39072930001
    GIBSON, John
    72 Heron Drive
    Sandal
    WF2 6SP Wakefield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    72 Heron Drive
    Sandal
    WF2 6SP Wakefield
    West Yorkshire
    British37005950001
    HANDS, Stephen Christopher
    Flat 24 Tower House
    Tower Street
    NE1 2HW Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    Geschäftsführer
    Flat 24 Tower House
    Tower Street
    NE1 2HW Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    British66910630002
    HUGHES, Robert Charles
    15 Hawkshead Drive
    B93 9QE Knowle
    West Midlands
    Geschäftsführer
    15 Hawkshead Drive
    B93 9QE Knowle
    West Midlands
    British84757480002
    JACKSON, Stephen
    39 Highside Drive
    Humbledon Hill
    SR3 1UL Sunderland
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    39 Highside Drive
    Humbledon Hill
    SR3 1UL Sunderland
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish36996160001
    JASAT, Azim
    3 Greenwood Close
    B14 6ET Birmingham
    West Midlands
    Geschäftsführer
    3 Greenwood Close
    B14 6ET Birmingham
    West Midlands
    British107438550001
    KELLY, Michael John
    Threeways
    Tranwell Woods
    NE61 6AQ Morpeth
    Northumberland
    Geschäftsführer
    Threeways
    Tranwell Woods
    NE61 6AQ Morpeth
    Northumberland
    United KingdomBritish36411030002
    KETCHIN, John Scott
    65 Cheviot View
    Ponteland
    NE20 9BH Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    65 Cheviot View
    Ponteland
    NE20 9BH Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    EnglandBritish19040640001
    METCALF, Edward Alexander
    Oldfield House 11 Station Close
    NE44 6HE Riding Mill
    Northumberland
    Geschäftsführer
    Oldfield House 11 Station Close
    NE44 6HE Riding Mill
    Northumberland
    British31125570001
    MURRAY, Kenneth Roderick
    42 St Andrews Square
    EH2 2AD Edinburgh
    Geschäftsführer
    42 St Andrews Square
    EH2 2AD Edinburgh
    British43513870003
    POWELL, Robert
    Derry Jane House
    Stocks Hill Belton
    DN9 1PE Doncaster
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    Derry Jane House
    Stocks Hill Belton
    DN9 1PE Doncaster
    South Yorkshire
    British37005880002
    SCHOLEY, Derek
    228 Oakwood Lane
    LS8 2PE Leeds
    Yorkshire
    Geschäftsführer
    228 Oakwood Lane
    LS8 2PE Leeds
    Yorkshire
    British23788760001
    SKUCHA, Nicholas Paul
    5 The Elms
    Porthill
    ST5 8RP Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    5 The Elms
    Porthill
    ST5 8RP Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    United KingdomBritish117468110001
    WATSON, Alan Roy
    5 Thornlea
    NE61 6NY Hepscott
    Northumberland
    Geschäftsführer
    5 Thornlea
    NE61 6NY Hepscott
    Northumberland
    EnglandBritish93102570001
    JL NOMINEES ONE LIMITED
    1 Saville Chambers
    5 North Street
    NE1 8DF Newcastle Upon Tyne
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    1 Saville Chambers
    5 North Street
    NE1 8DF Newcastle Upon Tyne
    900007210001

    Hat MEP SOLUTIONS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 21. Juni 2016
    Geliefert am 28. Juni 2016
    Ausstehend
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Close Brothers Limited (The "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 28. Juni 2016Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 30. Mai 2014
    Geliefert am 04. Juni 2014
    Ausstehend
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Juni 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 06. März 2014
    Geliefert am 08. März 2014
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. März 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    Debenture
    Erstellt am 16. Apr. 2010
    Geliefert am 17. Apr. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Apr. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 28. Nov. 2005
    Geliefert am 30. Nov. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Deposit of £5,728.13.
    Berechtigte Personen
    • Im Properties (Coleshill) Limited
    Transaktionen
    • 30. Nov. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Aug. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture containing fixed and floating charges
    Erstellt am 30. Sept. 2003
    Geliefert am 07. Okt. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 07. Okt. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Aug. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 07. Okt. 2002
    Geliefert am 09. Okt. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 09. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Aug. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Charge over cash deposit created by the company (formerly known as bals engineering group limited) in favour of the bank
    Erstellt am 04. Okt. 2001
    Geliefert am 13. Okt. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All monies standing to the credit of the account of the company with bank of scotland which is blocked or designated as charged to bank of scotland now numbered 00136818 as may be replaced redesignated renumbered or rearranged from time to time.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 13. Okt. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Aug. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 04. Okt. 2001
    Geliefert am 09. Okt. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies and liabilities whether principal interest or otherwise which may now or at any time hereafter become due owing or payable by sandco 708 limited and/or bals industrial accessories limited to the chargees as listed in schedule 1 of a loan agreement dated 4 october 2001 and made between the company the security trustees and such lenders ("the loan agreement")
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • D a Scholey, S Jackson, M J Kelly (As Security Trustees).
    Transaktionen
    • 09. Okt. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Aug. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Assignation of keyman policy
    Erstellt am 25. Apr. 1997
    Geliefert am 01. Mai 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Allied dunbar assurance PLC adaptable term plan, policy number 23036-088-das, date: 1/2/97, sum: £250,000, life assured: michael john kelly together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 01. Mai 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. Mai 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Collateral secured debenture
    Erstellt am 07. Sept. 1994
    Geliefert am 16. Sept. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from bals industrial accessories limited to the chargee under the terms of a debenture dated 7 september 1994
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • British Coal Enterprise Limited
    Transaktionen
    • 16. Sept. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Juli 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 22. Okt. 1993
    Geliefert am 30. Okt. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 30. Okt. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. Mai 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat MEP SOLUTIONS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    18. Okt. 2016Beginn der Verwaltung
    23. Okt. 2018Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Adrian Peter Berry
    Deloitte Llp
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    Praktiker
    Deloitte Llp
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    Clare Boardman
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    Praktiker
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0