EUROSTAR PROPERTY MANAGEMENTS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | EUROSTAR PROPERTY MANAGEMENTS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02770654 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von EUROSTAR PROPERTY MANAGEMENTS LIMITED?
- Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich EUROSTAR PROPERTY MANAGEMENTS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 150 Clapton Common E5 9AG London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von EUROSTAR PROPERTY MANAGEMENTS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| EUROSTAR PROPERTIES LIMITED | 03. Dez. 1992 | 03. Dez. 1992 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von EUROSTAR PROPERTY MANAGEMENTS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2014 |
Welche sind die letzten Einreichungen für EUROSTAR PROPERTY MANAGEMENTS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt | 1 Seiten | DISS40 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 03. Dez. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Deborah Ginsberg als Geschäftsführer am 11. Dez. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt | 1 Seiten | DISS40 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 03. Dez. 2016 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Notification of Jacob Meisels as a person with significant control on 30. Juni 2016 | 2 Seiten | PSC01 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 027706540015 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 027706540017, erstellt am 12. Juli 2016 | 13 Seiten | MR01 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 027706540016, erstellt am 12. Juli 2016 | 7 Seiten | MR01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 03. Dez. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Jacob Meisels als Direktor am 01. Dez. 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Mitteilung über die Beendigung der Tätigkeit als Receiver oder Manager | 4 Seiten | RM02 | ||||||||||
Mitteilung über die Beendigung der Tätigkeit als Receiver oder Manager | 4 Seiten | RM02 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 27. Nov. 2015 | 3 Seiten | 3.6 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 027706540015, erstellt am 25. Sept. 2015 | 30 Seiten | MR01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 4 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 11 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 10 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von EUROSTAR PROPERTY MANAGEMENTS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEISELS, Jacob | Sekretär | 15 Craven Walk N16 6BS London | British | 48873870001 | ||||||
| MEISELS, Jacob | Geschäftsführer | Overlea Road E5 9BG London 29 England | United Kingdom | British | Company Director | 48873870006 | ||||
| BIBERFIELD, Mindy | Sekretär | 15 Craven Walk N16 6BS London | British | 72832680001 | ||||||
| HALBERSTAM, Sarah | Sekretär | 41 Ashtead Road E5 9BG London | British | 24954940006 | ||||||
| LUDMIR, Hannah | Sekretär | 24 Overlea Road E5 9BG London | British | 58956950001 | ||||||
| MEISELS, Joshua Vilmos | Sekretär | 29 Overlea Road E5 9BG London | Usa | Director | 59538040001 | |||||
| MEISELS, Joshua William | Sekretär | 15 Craven Walk N16 6BS London | British | 59538040003 | ||||||
| MEISELS, Moishe | Sekretär | 9 Gilda Crescent N16 6JT London | British | Company Director | 71798640001 | |||||
| M & K NOMINEE SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 43 Wellington Avenue N15 6AX London | 900004570001 | |||||||
| BIBERFELD, Hindy | Geschäftsführer | 15 Craven Walk N16 6BS London | United Kingdom | British | Director | 39374600005 | ||||
| GINSBERG, Deborah | Geschäftsführer | 17 Overlea Road E5 9BG London | United Kingdom | British | Director | 126275530001 | ||||
| HALBERSTAM, Sarah | Geschäftsführer | 41 Ashtead Road E5 9BG London | British | Director | 24954940006 | |||||
| MEISELS, Jacob | Geschäftsführer | 15 Craven Walk N16 6BS London | England | British | Director | 48873870001 | ||||
| MEISELS, Joshua Vilmos | Geschäftsführer | 29 Overlea Road E5 9BG London | Usa | Director | 59538040001 | |||||
| MEISELS, Minia | Geschäftsführer | 29 Overlea Road E5 9BG London | United Kingdom | Other | Director | 43994910001 | ||||
| MEISELS, Moishe | Geschäftsführer | 9 Gilda Crescent N16 6JT London | England | British | Director | 71798640001 | ||||
| M & K NOMINEE SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 43 Wellington Avenue N15 6AX London | 900004570001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei EUROSTAR PROPERTY MANAGEMENTS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
|---|---|---|---|
| Mr Jacob Meisels | 30. Juni 2016 | Overlea Road E5 9BG London 29 England | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Hat EUROSTAR PROPERTY MANAGEMENTS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 12. Juli 2016 Geliefert am 14. Juli 2016 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung 335-337 new cross road, london SE14 6AT. Title number: 77710.. 333 new cross road, london SE14 6AT. Title number: LN118589.. 4 and 6 achilles street, london. Title number: LN60025.. Land lying between new cross road and achilles street, london. Title number: 250244.. land at the back of 4 and 6 achilles street, london. Title number: LN122429. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 12. Juli 2016 Geliefert am 14. Juli 2016 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung 335-337 new cross road, london SE14 6AT. Title number: 77710.. 333 new cross road, london SE14 6AT. Title number: LN118589.. 4 and 6 achilles street, london. Title number: LN60025.. Land at the back of 4 and 6 achilles street, london. Title number: LN122429.. Land lying between new cross road and achilles street, london. Title number: 250244. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 25. Sept. 2015 Geliefert am 28. Sept. 2015 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung 333-337 new cross road, london SE14 6AT, 4-6 achilles street, london and land lying between new cross road and achilles street, london (title numbers: LN122429, LN18589, 250244, 77710 and LN60025). Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 16. Mai 2006 Geliefert am 24. Mai 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H 3331/2, 335 337 new cross road and 4 & 6 achilles street, land at the back of 4 & 6 achilles street and lying between new cross road and achills street t/nos LN118589, 77710, LN60025, LN122429 and 250244 the goodwill. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| ||||
| Rent charge agreement | Erstellt am 13. Juni 2003 Geliefert am 20. Juni 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All rents now owing or hereafter to become owing. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 13. Juni 2003 Geliefert am 20. Juni 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 13. Juni 2003 Geliefert am 20. Juni 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a 333 1/2 new cross road; f/h property k/a 335 and 337 new cross road and f/h property lying between new cross road and achilles street t/nos: LN118589 77710 250244 LN60025 LN122429. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Floating charge | Erstellt am 23. Aug. 2001 Geliefert am 04. Sept. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All its undertaking and all its property and other assets of whatsoever nature both present and future including its uncalled capital for the time being. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 23. Aug. 2001 Geliefert am 04. Sept. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under any agreement | |
Kurze Angaben All that f/h property k/a 396 billett road, walthamstow, london E15 t/no EGL238692. By way of first fixed legal charge all rents, all its interest in all or any monies, any contracts or agreements, proceeds of sale.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Floating charge | Erstellt am 09. Dez. 1993 Geliefert am 17. Dez. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 09. Dez. 1993 Geliefert am 17. Dez. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a 102 aldriche way highams park london EGL234463 together with all buildings erections fixtures fittings fixed plant and machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 09. Dez. 1993 Geliefert am 17. Dez. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H propety k/a 76B clarendon road tottenham t/n EGL238134 together with all buildings and erections and fixtures and fittings and fixed plant and machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 09. Dez. 1993 Geliefert am 17. Dez. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a flat 39 taymount grange taymount rise forest hill t/n SGL289137 together with all buildings and erections and fixtures and fittings and fixed plant and machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 09. Dez. 1993 Geliefert am 17. Dez. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a flat 4 taymount grange taymount rise forest hill t/n SGL292743 together with all buildings and erections and fixtures and fittings and fixed plant and machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 09. Dez. 1993 Geliefert am 17. Dez. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H 6 mallard walk footscray sidcup kent t/n SGL530615 together with all buildings and erections and fixtures and fiitings and fixed plant and machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 09. Dez. 1993 Geliefert am 17. Dez. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a 131A clarence road t/n EGL194862 together with all buildings and erections and fixtures and fittings fixed plant and machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 20. Okt. 1993 Geliefert am 27. Okt. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a 637 commercial road, london l/b of tower hamlets t/no: ngl 122287. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat EUROSTAR PROPERTY MANAGEMENTS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Receiver/Manager bestellt |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0