FARLANE JOHNSON LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | FARLANE JOHNSON LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02774215 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von FARLANE JOHNSON LIMITED?
- (1824) /
Wo befindet sich FARLANE JOHNSON LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Johnson House Monks Way Preston Brook WA7 3GH Runcorn Cheshire United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FARLANE JOHNSON LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2008 |
Welche sind die letzten Einreichungen für FARLANE JOHNSON LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Dez. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mrs Yvonne May Monaghan am 01. Okt. 2009 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Timothy James Morris am 01. Okt. 2009 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Mrs Yvonne May Monaghan am 01. Okt. 2009 | 3 Seiten | CH03 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 190 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 353 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 353 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von FARLANE JOHNSON LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONAGHAN, Yvonne May | Sekretär | Monks Way Preston Brook WA7 3GH Runcorn Johnson House Cheshire United Kingdom | British | 7934540003 | ||||||
| MONAGHAN, Yvonne May | Geschäftsführer | Monks Way Preston Brook WA7 3GH Runcorn Johnson House Cheshire United Kingdom | England | British | 7934540003 | |||||
| MORRIS, Timothy James | Geschäftsführer | Monks Way Preston Brook WA7 3GH Runcorn Johnson House Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | 126969480001 | |||||
| FARMAH, Ramesh Kumar | Sekretär | Kenrick House 40 Fairlands Park CV4 7DS Coventry West Midlands | British | 96769100001 | ||||||
| HOLMES, Gary William | Sekretär | 48 Badgers Way DT10 1EP Sturminster Newton Dorset | British | 93975060001 | ||||||
| PEARSON, Graham | Sekretär | 21 The Orchards Pickmere WA16 0LS Knutsford Cheshire | British | 95884040002 | ||||||
| L & A SECRETARIAL LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 31 Corsham Street N1 6DR London | 900001450001 | |||||||
| BROOME, Raymond | Geschäftsführer | 309 Sandy Lane Droylsden M43 7JU Manchester | British | 36826020001 | ||||||
| FARMAH, Pardeep Kumar | Geschäftsführer | 59 Kenilworth Road CV4 7AF Coventry W Mids | United Kingdom | British | 11196200001 | |||||
| FARMAH, Ramesh Kumar | Geschäftsführer | Kenrick House 40 Fairlands Park CV4 7DS Coventry West Midlands | United Kingdom | British | 96769100001 | |||||
| FARMAH, Suresh | Geschäftsführer | 59 Kenilworth Road CV4 7AF Coventry | British | 48951400001 | ||||||
| JOHNSON, Michael Stanley | Geschäftsführer | Etchells Paddock Auden Close DE65 5AG Church Broughton Derbyshire | British | 8654800001 | ||||||
| PEARSON, Richard Barrett | Geschäftsführer | 20 Croft Road Edwalton NG12 4BW Nottingham Nottinghamshire | England | British | 121732790001 | |||||
| TOON, David Robert | Geschäftsführer | 4 Sheridan Place Winwick WA2 8XG Warrington Cheshire | England | United Kingdom | 126976110001 | |||||
| L & A REGISTRARS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 31 Corsham Street N1 6DR London | 900001440001 |
Hat FARLANE JOHNSON LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Fixed charge supplemental to a debenture dated 30TH august 1995 issuesd by the company | Erstellt am 27. Apr. 1998 Geliefert am 06. Mai 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed charge all right title and interest in and to the charged deeds (as defined) and all book debts and other debts the subject thereof. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. Aug. 1995 Geliefert am 11. Sept. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 21. Apr. 1993 Geliefert am 29. Apr. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0