02774680 LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    Unternehmensname02774680 LIMITED
    UnternehmensstatusAktiv
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02774680
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von 02774680 LIMITED?

    • (3410) /

    Wo befindet sich 02774680 LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House 33 Wellington
    LS1 4JP Street Leeds
    West Yorkshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von 02774680 LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    LEYLAND DAF VANS LIMITED26. Apr. 199326. Apr. 1993
    PRAINSITE LIMITED17. Dez. 199217. Dez. 1992

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von 02774680 LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am31. Dez. 2005
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am31. Okt. 2006
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2004

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für 02774680 LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis17. Dez. 2016
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung31. Dez. 2016
    ÜberfälligJa

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für 02774680 LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung
    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis
    ÜberfälligJa

    Welche sind die letzten Einreichungen für 02774680 LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss

    2 SeitenAC92

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss

    4 SeitenAC92

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Beendigung der Bestellung von Paul Downes als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von John Ellis als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss

    3 SeitenAC92

    legacy

    1 SeitenLIQ

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung

    6 Seiten2.35B

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    6 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    6 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    7 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    6 Seiten2.24B

    Ergebnis der Gläubigerversammlung

    47 Seiten2.23B

    Geänderte Bescheinigung über die Zusammensetzung des Gläubigerausschusses

    1 Seiten2.26B

    Vorschlag des Verwalters

    47 Seiten2.17B

    Vermögensübersicht

    42 Seiten2.16B

    legacy

    1 Seiten287

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    legacy

    2 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    Wer sind die Geschäftsführer von 02774680 LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    OGILVIE, Kenneth David Buchanan
    Forge Cottage
    Main Street
    NG14 7GH Bleasby
    Nottinghamshire
    Sekretär
    Forge Cottage
    Main Street
    NG14 7GH Bleasby
    Nottinghamshire
    British77982570001
    AMEY, Allan William
    Glebe House
    Haugh Of Urr
    DG7 3LB Castle Douglas
    Kirkcudbrightshire
    Geschäftsführer
    Glebe House
    Haugh Of Urr
    DG7 3LB Castle Douglas
    Kirkcudbrightshire
    British34879900002
    FELL, Nicholas Hugh
    Martin Hall
    Drury Lane
    WR3 8TD Martin Hussingtree
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    Martin Hall
    Drury Lane
    WR3 8TD Martin Hussingtree
    Worcestershire
    EnglandBritish104468370001
    LEWIS, Antony James
    25 Lynnon Field
    CV34 6DH Warwick
    Geschäftsführer
    25 Lynnon Field
    CV34 6DH Warwick
    British62050480002
    LINES, Alan Edward
    2 Chatsworth Avenue
    Great Notley
    CM77 7ZB Braintree
    Essex
    Geschäftsführer
    2 Chatsworth Avenue
    Great Notley
    CM77 7ZB Braintree
    Essex
    British107142100001
    MADDRELL, Geoffrey Keggen
    28 Sussex Street
    SW1V 4RL London
    Geschäftsführer
    28 Sussex Street
    SW1V 4RL London
    United KingdomBritish17150180001
    OGILVIE, Kenneth David Buchanan
    Forge Cottage
    Main Street
    NG14 7GH Bleasby
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Forge Cottage
    Main Street
    NG14 7GH Bleasby
    Nottinghamshire
    EnglandBritish77982570001
    STANTON, Keith
    Hurst Cottage
    Hurst Lane Owslebury
    SO21 1JQ Winchester
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Hurst Cottage
    Hurst Lane Owslebury
    SO21 1JQ Winchester
    Hampshire
    British106559470001
    BARKER, Jack
    Cloth Hall Court
    Infirmary Street
    LS1 2JB Leeds
    West Yorkshire
    Sekretär
    Cloth Hall Court
    Infirmary Street
    LS1 2JB Leeds
    West Yorkshire
    British3218120001
    CABLE, Roger Ernest
    Stevenshill
    Harnage Cressage
    SY5 6EG Shrewsbury
    Sekretär
    Stevenshill
    Harnage Cressage
    SY5 6EG Shrewsbury
    British30782250003
    DWYER, Daniel John
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    Bevollmächtigter Sekretär
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British900003970001
    ROBERTS, Ian David
    15 Sandhill Court
    LS17 6AH Leeds
    West Yorkshire
    Sekretär
    15 Sandhill Court
    LS17 6AH Leeds
    West Yorkshire
    British51592030001
    ARROWSMITH, James Vaughan
    1 Doctors Hill
    Tanworth In Arden
    B94 5BS Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    1 Doctors Hill
    Tanworth In Arden
    B94 5BS Solihull
    West Midlands
    EnglandBritish96477140001
    BARKER, Jack
    Cloth Hall Court
    Infirmary Street
    LS1 2JB Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Cloth Hall Court
    Infirmary Street
    LS1 2JB Leeds
    West Yorkshire
    British3218120001
    BONNER, Trevor Courtnay
    Brae House
    17 Lovelace Avenue
    B91 3JR Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Brae House
    17 Lovelace Avenue
    B91 3JR Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritish11064070002
    BRADLEY, John
    Century Cottage
    Somersal Heath
    DE6 5PE Ashbourne
    Geschäftsführer
    Century Cottage
    Somersal Heath
    DE6 5PE Ashbourne
    United KingdomBritish110194710001
    CABLE, Roger Ernest
    Stevenshill
    Harnage Cressage
    SY5 6EG Shrewsbury
    Geschäftsführer
    Stevenshill
    Harnage Cressage
    SY5 6EG Shrewsbury
    British30782250003
    CHO, Young Kab
    87 Gluska St
    Lublin
    FOREIGN Poland
    20-380
    Poland
    Geschäftsführer
    87 Gluska St
    Lublin
    FOREIGN Poland
    20-380
    Poland
    Republic Of Korea62547130001
    DOWNES, Paul William Edwin
    Seven Acres
    Horsell Common
    GU21 4XY Woking
    Surrey
    Geschäftsführer
    Seven Acres
    Horsell Common
    GU21 4XY Woking
    Surrey
    United KingdomBritish18135910002
    DOYLE, Betty June
    8 The Bartons
    Elstree Hill North
    WD6 3EN Elstree
    Herts
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    8 The Bartons
    Elstree Hill North
    WD6 3EN Elstree
    Herts
    British900003960001
    DWYER, Daniel John
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British900003970001
    ELLIS, John
    The Dell
    64 Kneeton Road
    NG13 8PJ East Bridgford
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    The Dell
    64 Kneeton Road
    NG13 8PJ East Bridgford
    Nottinghamshire
    EnglandBritish197053420001
    GARDNER, David Paul
    Dormy Cottage Cross Oak Road
    HP4 3NA Berkhamsted
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Dormy Cottage Cross Oak Road
    HP4 3NA Berkhamsted
    Hertfordshire
    British48902750001
    GRIFFITHS, Clive Alan
    The Crossing House
    117 Tiddington Road
    CV37 7AA Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    The Crossing House
    117 Tiddington Road
    CV37 7AA Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    United KingdomBritish92348820001
    GRIMES, Michael Leonard Julian
    27 Mountfields
    Clarendon Road
    LS2 9PQ Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    27 Mountfields
    Clarendon Road
    LS2 9PQ Leeds
    West Yorkshire
    British33571640001
    JEFFERIES, Malcolm William
    The Old School
    Ratley
    OX15 6DS Banbury
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    The Old School
    Ratley
    OX15 6DS Banbury
    Oxfordshire
    British30110070001
    JOHNSON, Robin Stuart Craig
    Paylors Cottage
    Church View
    LS22 5JD Hunsingore
    Wetherey
    Geschäftsführer
    Paylors Cottage
    Church View
    LS22 5JD Hunsingore
    Wetherey
    British46365320003
    MCKINNON, Ian Bannochie
    219 Inner Promenade
    FY8 1EA Lytham St Annes
    Lancashire
    Geschäftsführer
    219 Inner Promenade
    FY8 1EA Lytham St Annes
    Lancashire
    EnglandBritish980160001
    MOLONEY, Maria Victoria, Dr
    51 Newforge Lane
    Malone Road
    BT9 5NW Belfast
    N Ireland
    Geschäftsführer
    51 Newforge Lane
    Malone Road
    BT9 5NW Belfast
    N Ireland
    Northern IrelandBritish46630440001
    PARKS, James
    High Cross House 72 Kelsey Lane
    Balsall Common
    CV7 7GL Coventry
    Geschäftsführer
    High Cross House 72 Kelsey Lane
    Balsall Common
    CV7 7GL Coventry
    British34434990002
    RAE, John
    Stonehaven 15a Coxwell Road
    SN7 7EB Faringdon
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Stonehaven 15a Coxwell Road
    SN7 7EB Faringdon
    Oxfordshire
    British34434980002
    RICHARDSON, Ian Ashley
    The Old Vicarage, Back Street
    Aldborough, Boroughbridge
    YO51 9EX York
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    The Old Vicarage, Back Street
    Aldborough, Boroughbridge
    YO51 9EX York
    North Yorkshire
    British66535330001
    ROBERTS, Ian David
    15 Sandhill Court
    LS17 6AH Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    15 Sandhill Court
    LS17 6AH Leeds
    West Yorkshire
    British51592030001
    SERGEANT, Anthony Arthur William
    9 Holt Castle Barns
    WR6 6NJ Holt
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    9 Holt Castle Barns
    WR6 6NJ Holt
    Worcestershire
    United KingdomBritish98900040001
    YARDLEY, Gordon John
    Gable End Quarry Park Road
    Pedmore
    DY8 2RE Stourbridge
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Gable End Quarry Park Road
    Pedmore
    DY8 2RE Stourbridge
    West Midlands
    British28580100001

    Hat 02774680 LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 16. Sept. 2005
    Geliefert am 28. Sept. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the security trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • 3I Investments PLC as Security Trustee on Behalf of the Investors (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 28. Sept. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 07. Juli 2005
    Geliefert am 16. Juli 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the investors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property being on the north west side of the common lane, ward end, birmingham t/no WM803456; f/h property being land forming part of common lane, birmingham t/no WM590733; f/h property being land on the north west side of drews lane, ward end, birmingham t/no WM573847, for details of further properties charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • 3I Investments PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 16. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Trustee debenture
    Erstellt am 08. Apr. 2005
    Geliefert am 16. Apr. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the security trustee ot any of the investor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property being on the north west side of common lane ward end birmingham t/no WM803456,f/h property being land forming part of common lane birmingham t/no WM590733,f/h property being land on the north west of drews lane ward end birmingham t/no WM573847 (for details of further properties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • 3I Investment PLC ("Security Trustee")
    Transaktionen
    • 16. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over cash deposit
    Erstellt am 12. Feb. 2004
    Geliefert am 18. Feb. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the right title benefit and interest in the account whatsoever present and future and in any certificates of deposit, deposit receipts or other instruments or securities relating thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Secretary of State for Trade and Industry
    Transaktionen
    • 18. Feb. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of charge over credit balances
    Erstellt am 06. Feb. 2004
    Geliefert am 14. Feb. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Barclays bank PLC re ldv limited business premium account account number 50879215. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Feb. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Assignment
    Erstellt am 20. Jan. 2004
    Geliefert am 30. Jan. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All monies standing to the credit in account number 0477558 and all rights to such account including the right to receive interest and any other sum or sums deposited. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • United Dominions Trust Limited
    Transaktionen
    • 30. Jan. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 20. Jan. 2004
    Geliefert am 23. Jan. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to 3I investments PLC as security trustee (or any successor to 3I investments PLC as security trustee) or to any of the following: 3I group PLC; eac fund iii limited partnership; eac fund iii gmbh & co; or cavendish nominees limited as nominee for barings english grthis is 7LANDS) LP
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • 3I Investments PLC
    Transaktionen
    • 23. Jan. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Sept. 2003
    Geliefert am 24. Sept. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The l/h property k/a land and buildings k/a the ldv site drews lane washwood heath birmingham B8 2QG and the goodwill of any business.
    Berechtigte Personen
    • Birmingham City Council
    Transaktionen
    • 24. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 05. Sept. 2003
    Geliefert am 24. Sept. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first fixed equitable charge the balance from time to time standing to the credit of an interest bearing deposit account opened with the royal bank of scotland PLC (or such other clearing bank as the landlord shall from time to time elect) in the name of axa sun life PLC but designated with the name of the company and the address of the premises.
    Berechtigte Personen
    • Axa Sun Life PLC
    Transaktionen
    • 24. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Apr. 2003
    Geliefert am 17. Apr. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land on the north side of drews lane birmingham west midlands t/n WM645315.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Okt. 2002
    Geliefert am 21. Okt. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a land on the north wesr side of drews lane, ward end, birmingham t/no. WM573847.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. Dez. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Okt. 2002
    Geliefert am 21. Okt. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a land lying north west of drews lane, ward end, birmingham t/no. WM638441.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. Dez. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Okt. 2002
    Geliefert am 21. Okt. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h property k/a land 600 millimetres below the surface of part of the west car park, common lane, ward end, birmingham t/no. WM574452.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. Dez. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Okt. 2002
    Geliefert am 21. Okt. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a land forming part of common lane, birmingham t/no. WM590733.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. Dez. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 07. Dez. 2001
    Geliefert am 20. Dez. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Dez. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 07. Dez. 2001
    Geliefert am 17. Dez. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or in connection with a letter dated 23 april 1998 from the dti to the company or under the mortgage of even date therein
    Kurze Angaben
    The freehold land known as land 600M below the surface of part of the west car park, common lane, ward end, birmingham t/no: WM574452, all that freehold property being land lying to the north west of drews lane, ward end, birmingham t/no: WM638441 all that freehold property being land forming part of common lane birmingham t/no: WM590733 all that freehold property being land on the north west of drews lane, birmingham t/no: WM573847 together with all buildings and fixtures (including trade fixtures, tenant's fixtures and fixed plant and machinery) and/or the proceeds of sale thereof.
    Berechtigte Personen
    • The Secretary of State for Trade and Industry
    Transaktionen
    • 17. Dez. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 07. Dez. 2001
    Geliefert am 13. Dez. 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The leasehold and freehold land and premises of the company registered under title numbers WM574452,WM638441,WM590733 and WM573847 together with all buildings fixtures anf fixed plant and machinery from time to time thereon,.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • United Dominions Trust Limited
    Transaktionen
    • 13. Dez. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Charge of deposit
    Erstellt am 05. Okt. 2001
    Geliefert am 17. Okt. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All deposits now and in the future credited to account with the bank and any deposit or account of any other currency. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 17. Okt. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Jan. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Mai 2001
    Geliefert am 09. Juni 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee as specified in a grant agreement of even date (as defined therein)
    Kurze Angaben
    Bromford house drews lane birmingham.
    Berechtigte Personen
    • Birmingham City Council
    Transaktionen
    • 09. Juni 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. Dez. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 11. Juli 2000
    Geliefert am 13. Juli 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to each of the operative documents
    Kurze Angaben
    F/H and l/h land to the north of drews lane birmingham t/no WM574452 WM638441 WM590733 WM645315 and WM573847. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Mercantile Business Finance Limited (Secured Party)
    Transaktionen
    • 13. Juli 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Apr. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 11. Juli 2000
    Geliefert am 13. Juli 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to each of the operative documents
    Kurze Angaben
    F/H and l/h land to the north of drews lane birmingham t/no WM574452 WM638441 WM590733 WM645315 and WM573847 and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Sovereign Financial Services (Manchester) Limited (Secured Party)
    Transaktionen
    • 13. Juli 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Apr. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 20. Juni 2000
    Geliefert am 11. Juli 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of the terms of the grant offer letter
    Kurze Angaben
    Bromford house drews lane birmingham B8 2QG and all plant machinery or equipment owned by the company.
    Berechtigte Personen
    • The Secretary of State for Trade & Industry
    Transaktionen
    • 11. Juli 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Jan. 2002Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    Debenture
    Erstellt am 30. Mai 2000
    Geliefert am 07. Juni 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to each of the operative documents to which the company and the chargee are a party and all monies due from the company in relation to the debenture
    Kurze Angaben
    Floating charge all balances standing to the credit of any current deposit or other account, all book and other debts and all stock-in-trade.
    Berechtigte Personen
    • Sovereign Financial Services (Manchester) Limited
    Transaktionen
    • 07. Juni 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Apr. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 30. Mai 2000
    Geliefert am 07. Juni 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to each of the operative documents to which the company and the chargee are a party and all monies due from the company in relation to the debenture
    Kurze Angaben
    Floating charge all balances standing to the credit of any current deposit or other account, all book and other debts and all stock-in-trade.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Mercantile Business Finance Limited
    Transaktionen
    • 07. Juni 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Apr. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 20. Dez. 1999
    Geliefert am 21. Dez. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • United Dominions Trust Limited
    Transaktionen
    • 21. Dez. 1999Registrierung einer Belastung (395)

    Hat 02774680 LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    16. Dez. 2005Beginn der Verwaltung
    17. Sept. 2007Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Anthony Victor Lomas
    Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 3DT Birmingham
    Praktiker
    Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 3DT Birmingham
    Robert Jonathan Hunt
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Cornwall Court
    B3 2DT 19 Cornwall Street
    Birmingham
    Praktiker
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Cornwall Court
    B3 2DT 19 Cornwall Street
    Birmingham
    Mark David Charles Hopkins
    Pricewaterhousecoopers
    Cornwall Court
    B3 2DT Cornwall Street
    Birmingham
    Praktiker
    Pricewaterhousecoopers
    Cornwall Court
    B3 2DT Cornwall Street
    Birmingham

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0