CORICH COMMUNITY CARE LIMITED

CORICH COMMUNITY CARE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCORICH COMMUNITY CARE LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02783652
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CORICH COMMUNITY CARE LIMITED?

    • Betreuungseinrichtungen für ältere und behinderte Menschen (87300) / Gesundheits- und Sozialwesen

    Wo befindet sich CORICH COMMUNITY CARE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CORICH COMMUNITY CARE LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2019

    Welche sind die letzten Einreichungen für CORICH COMMUNITY CARE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erfüllung der Belastung 027836520016 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 027836520015 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 8 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 9 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 10 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 12 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 14 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 11 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 13 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 027836520017 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 26. Jan. 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2019

    2 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 26. Jan. 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Notification of Consensus Support Services as a person with significant control on 06. Apr. 2016

    2 SeitenPSC02

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2018

    2 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 26. Jan. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2017

    2 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 26. Jan. 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2016

    6 SeitenAA

    Das gesamte Eigentum oder Unternehmen wurde aus der Belastung entlassen 9

    2 SeitenMR05

    **Ein Teil des Eigentums oder Unternehmens wurde aus der Belastung entlassen ** 8

    2 SeitenMR05

    Das gesamte Eigentum oder Unternehmen wurde aus der Belastung entlassen 12

    2 SeitenMR05

    Wer sind die Geschäftsführer von CORICH COMMUNITY CARE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SCHOFIELD, Nigel Bennett
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Sekretär
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    BritishCompany Director148139420001
    HILL, Peter Martin
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Geschäftsführer
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    EnglandBritishAccountant130983750001
    JEFFERY, Paul Anthony Keith
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Geschäftsführer
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    United KingdomBritishAccountant65609290003
    SCHOFIELD, Nigel Bennett
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Geschäftsführer
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    United KingdomBritishSolicitor148139420001
    RICHARDS, Alexandra Lois
    Tanglewood
    Newdigate Road Beare Green
    RH5 4QE Dorking
    Surrey
    Sekretär
    Tanglewood
    Newdigate Road Beare Green
    RH5 4QE Dorking
    Surrey
    EnglishDirector32423630001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Bevollmächtigter Sekretär
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    COREN, Barrie Roger
    The Haven
    RH14 9BE Nr. Billingshurst
    Lower Lodge House
    West Sussex
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    The Haven
    RH14 9BE Nr. Billingshurst
    Lower Lodge House
    West Sussex
    United Kingdom
    United KingdomBritishManaging Director137269930001
    COREN, Sally Ann
    Lower Toat Cottage
    Five Oaks Road, Slinfold
    RH13 0RL Horsham
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Lower Toat Cottage
    Five Oaks Road, Slinfold
    RH13 0RL Horsham
    West Sussex
    BritishDirector33433240002
    CORMACK, Derek George
    Pillars
    Grantley Avenue, Wonersh
    GU5 0QN Guildford
    Surrey
    Geschäftsführer
    Pillars
    Grantley Avenue, Wonersh
    GU5 0QN Guildford
    Surrey
    EnglandIrishAccountant67400530015
    RICHARDS, Alexandra Lois
    Tanglewood
    Newdigate Road Beare Green
    RH5 4QE Dorking
    Surrey
    Geschäftsführer
    Tanglewood
    Newdigate Road Beare Green
    RH5 4QE Dorking
    Surrey
    EnglishDirector32423630001
    WHITE, Ian James
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Geschäftsführer
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    EnglandBritishAccountant133383410003
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CORICH COMMUNITY CARE LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Mr Paul Anthony Keith Jeffery
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    06. Apr. 2016
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: England
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 50%, aber nicht mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    Consensus Support Services
    830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Bradbury House
    England
    06. Apr. 2016
    830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Bradbury House
    England
    Nein
    RechtsformPrivate Limited Company
    RegistrierungslandUnited Kingdom
    RechtsgrundlageEngland And Wales
    RegistrierungsortEngland And Wales
    Registrierungsnummer4081379
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat CORICH COMMUNITY CARE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 11. Sept. 2013
    Geliefert am 19. Sept. 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC (In Its Capacity as Security Agent and Trustee for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 19. Sept. 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 03. Apr. 2020Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 11. Sept. 2013
    Geliefert am 17. Sept. 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Griffin-American Healthcare Reit Ii, Inc
    Transaktionen
    • 17. Sept. 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 16. Apr. 2020Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 11. Sept. 2013
    Geliefert am 16. Sept. 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Ga Hc Reit Ii Ch UK Senior Housing Portfolio LTD
    Transaktionen
    • 16. Sept. 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 16. Apr. 2020Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 28. Juli 2010
    Geliefert am 06. Aug. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each chargor to the chargee and to all or any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. For details of property charged please refer to form MG01.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    Transaktionen
    • 06. Aug. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 03. Apr. 2020Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 16. Nov. 2007
    Geliefert am 27. Nov. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the chargors to the chargee for the secured finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Ascot house 28 wingrove road fenham,34 and 36 wingrove road newcastle upon tynet/no's TY221509 and TY52154,bradbury house bradbury house new street braintree t/no ESX647090, cheshire house 22 st mary's road ashton on mersey t/no GM54543 (for details of further properties charged. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 27. Nov. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Apr. 2020Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Nov. 2007
    Geliefert am 26. Nov. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property known as buttercups and railway cottage 8 ford road arundel t/n WSX222325,. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 26. Nov. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Juli 2016Das gesamte Grundstück oder Unternehmen wurde von der Belastung freigegeben (MR05)
    • 03. Apr. 2020Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Nov. 2007
    Geliefert am 26. Nov. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property known as huntley care home 76 richmond road worthing t/n WSX46996,. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 26. Nov. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Juli 2016Das gesamte Grundstück oder Unternehmen wurde von der Belastung freigegeben (MR05)
    • 03. Apr. 2020Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Nov. 2007
    Geliefert am 26. Nov. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property known as courtwick park and strawberry field courtwick lane wick littlehampton west sussex t/n WSX123650,. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 26. Nov. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Juli 2016Das gesamte Grundstück oder Unternehmen wurde von der Belastung freigegeben (MR05)
    • 03. Apr. 2020Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Nov. 2007
    Geliefert am 26. Nov. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property known as sunny brook 88 lyndhurst road ashurst southampton t/n HP132158,. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 26. Nov. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Juli 2016Das gesamte Grundstück oder Unternehmen wurde von der Belastung freigegeben (MR05)
    • 03. Apr. 2020Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 07. Nov. 2007
    Geliefert am 26. Nov. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    For details of properties charged please refer to form 395, fixed and floating charges over all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC (Security Trustee)
    Transaktionen
    • 26. Nov. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Juli 2016Ein Teil des Grundstücks oder Unternehmens wurde von der Belastung freigegeben (MR05)
    • 03. Apr. 2020Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage
    Erstellt am 05. Sept. 2006
    Geliefert am 06. Sept. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a hollystone house ashurst hampshire t/no HP132158 and HP660050. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Sept. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Mai 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage
    Erstellt am 15. Apr. 2005
    Geliefert am 23. Apr. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a shaky doo, ford, arundel, west sussex. T/no WSX222325. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Mai 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage deed
    Erstellt am 11. Apr. 2000
    Geliefert am 18. Apr. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a or being huntley 76 richmond road woerthing west sussex BN11 4AF t/n wsx 46996. together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Apr. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Mai 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage deed
    Erstellt am 06. Apr. 1998
    Geliefert am 09. Apr. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Courtwick park court wick lane lyminster littlehampton t/no;-wsx 123650. together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Apr. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Mai 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture deed
    Erstellt am 06. Apr. 1998
    Geliefert am 09. Apr. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Apr. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Mai 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 07. Juli 1997
    Geliefert am 11. Juli 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Juli 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Juli 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 18. März 1997
    Geliefert am 27. März 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Courtwick park courtwick lane lyminster littlehampton west sussex t/n-wsx 123650.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. März 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Juli 1998Registrierung einer Belastung
    • 02. Juli 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0