TJH GROUP LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTJH GROUP LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02788607
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von TJH GROUP LIMITED?

    • (7415) /

    Wo befindet sich TJH GROUP LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Lynton House
    Ackhurst Park Foxhole Road
    PR7 1NY Chorley
    Lancashire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von TJH GROUP LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CITY MANOR LIMITED10. Feb. 199310. Feb. 1993

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TJH GROUP LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2011

    Welche sind die letzten Einreichungen für TJH GROUP LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    legacy

    4 SeitenMG02

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 18. Nov. 2011

    RES15

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2011

    11 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 06. Juni 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital09. Juni 2011

    Kapitalaufstellung am 09. Juni 2011

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2010

    9 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 06. Juni 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Änderung der Details des Sekretärs für John David Holden am 06. Juni 2010

    1 SeitenCH03

    Änderung der Details des Direktors für John Clement Kay am 06. Juni 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Miss Kathryn Revitt am 06. Juni 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Mark Lorimer Widders am 06. Juni 2010

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2009

    9 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    3 Seiten403a

    Beschlüsse

    Resolutions
    10 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Annahme der Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    11 Seiten395

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Approve board minutes 26/02/2009
    RES13

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2008

    9 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2007

    9 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    Wer sind die Geschäftsführer von TJH GROUP LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HOLDEN, John David
    Lynton House
    Ackhurst Park Foxhole Road
    PR7 1NY Chorley
    Lancashire
    Sekretär
    Lynton House
    Ackhurst Park Foxhole Road
    PR7 1NY Chorley
    Lancashire
    British137210330001
    KAY, John Clement
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    EnglandBritish27891540001
    REVITT, Kathryn
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    United KingdomBritish49315020001
    WIDDERS, Mark Lorimer
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    EnglandBritish2272770002
    KAY, John Clement
    7 Beechfield Road
    Mayfield
    PR25 3BG Leyland
    Lancashire
    Sekretär
    7 Beechfield Road
    Mayfield
    PR25 3BG Leyland
    Lancashire
    British27891540001
    LIVESEY, Frederick Joseph
    Wal Mar
    Dawbers Lane, Euxton
    PR7 6ED Chorley
    Lancashire
    Sekretär
    Wal Mar
    Dawbers Lane, Euxton
    PR7 6ED Chorley
    Lancashire
    British32145610004
    SIMMONDS, Gordon Graham
    Flat 1 20 Harrington Gardens
    SW7 4LS London
    Sekretär
    Flat 1 20 Harrington Gardens
    SW7 4LS London
    British34446930003
    STOTT, St John
    17 Uplands Chase
    Fulwood
    PR2 7AW Preston
    Sekretär
    17 Uplands Chase
    Fulwood
    PR2 7AW Preston
    British83024660001
    WIDDERS, Mark Lorimer
    12 Clovelly Drive
    Hillside
    PR8 3AJ Southport
    Merseyside
    Sekretär
    12 Clovelly Drive
    Hillside
    PR8 3AJ Southport
    Merseyside
    British2272770002
    GRAVITAS COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    25-31 Moorgate
    London
    Bevollmächtigter Sekretär
    25-31 Moorgate
    London
    900007520001
    HEMMINGS, Trevor James
    The Penthouse Retraite De La Mielle
    Route De La Haule St Brelade
    JE3 8BA Jersey
    Channel Islands
    Geschäftsführer
    The Penthouse Retraite De La Mielle
    Route De La Haule St Brelade
    JE3 8BA Jersey
    Channel Islands
    United KingdomBritish65090920001
    JACKSON, Nigel Spencer
    27 St Johns Road
    NW11 0PE London
    Geschäftsführer
    27 St Johns Road
    NW11 0PE London
    EnglandBritish53249050001
    JOHNS, Michael Stephen Mackelcan
    22 Bowerdean Street
    London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    22 Bowerdean Street
    London
    British900007510001
    KAY, John Clement
    7 Beechfield Road
    Mayfield
    PR25 3BG Leyland
    Lancashire
    Geschäftsführer
    7 Beechfield Road
    Mayfield
    PR25 3BG Leyland
    Lancashire
    EnglandBritish27891540001
    KENT-LEMON, Nigel William
    29 Queensdale Road
    W11 4SB London
    Geschäftsführer
    29 Queensdale Road
    W11 4SB London
    British6467990001
    LIVESEY, Frederick Joseph
    Wal Mar
    Dawbers Lane, Euxton
    PR7 6ED Chorley
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Wal Mar
    Dawbers Lane, Euxton
    PR7 6ED Chorley
    Lancashire
    British32145610004
    STOTT, St John
    17 Uplands Chase
    Fulwood
    PR2 7AW Preston
    Geschäftsführer
    17 Uplands Chase
    Fulwood
    PR2 7AW Preston
    United KingdomBritish83024660001
    WIDDERS, Mark Lorimer
    12 Clovelly Drive
    Hillside
    PR8 3AJ Southport
    Merseyside
    Geschäftsführer
    12 Clovelly Drive
    Hillside
    PR8 3AJ Southport
    Merseyside
    EnglandBritish2272770002

    Hat TJH GROUP LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 27. Feb. 2009
    Geliefert am 09. März 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Secured Parties or Any Person Appointed as Security Trustee from Time to Time in Accordance Withe the Terms of the Facility Agreement
    Transaktionen
    • 09. März 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. März 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Supplemental debenture between the company and the governor and company of the bank of scotland as agent and security trustee for the secured parties (the security trustee)
    Erstellt am 15. Sept. 2000
    Geliefert am 02. Okt. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The actual contingent present and/or future obligations and liabilities of the company to any of the secured parties under or pursuant to the supplemental debenture and any of the financing documents
    Kurze Angaben
    The company assigned (as continuing security in favour of the security trustee) (as defined) with full title guarantee by way of security all of its rights title and interest (both present and future) in all and each of the acquisition documents (as defined).
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 02. Okt. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Apr. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 01. Okt. 1993
    Geliefert am 19. Okt. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this charge and any of the financing documents (as therein defined)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotlandas Agent and Trustee for the Secured Parties (As Therein Defined)
    Transaktionen
    • 19. Okt. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Apr. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0