TJH GROUP LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | TJH GROUP LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02788607 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von TJH GROUP LIMITED?
- (7415) /
Wo befindet sich TJH GROUP LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Lynton House Ackhurst Park Foxhole Road PR7 1NY Chorley Lancashire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von TJH GROUP LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| CITY MANOR LIMITED | 10. Feb. 1993 | 10. Feb. 1993 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TJH GROUP LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für TJH GROUP LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | MG02 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2011 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 06. Juni 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2010 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 06. Juni 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für John David Holden am 06. Juni 2010 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für John Clement Kay am 06. Juni 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Miss Kathryn Revitt am 06. Juni 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Mark Lorimer Widders am 06. Juni 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2009 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 403a | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 10 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 11 Seiten | 395 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2008 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2007 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von TJH GROUP LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLDEN, John David | Sekretär | Lynton House Ackhurst Park Foxhole Road PR7 1NY Chorley Lancashire | British | 137210330001 | ||||||
| KAY, John Clement | Geschäftsführer | Dawbers Lane Euxton PR7 6EA Chorley Gleadhill House Lancashire | England | British | 27891540001 | |||||
| REVITT, Kathryn | Geschäftsführer | Dawbers Lane Euxton PR7 6EA Chorley Gleadhill House Lancashire | United Kingdom | British | 49315020001 | |||||
| WIDDERS, Mark Lorimer | Geschäftsführer | Dawbers Lane Euxton PR7 6EA Chorley Gleadhill House Lancashire | England | British | 2272770002 | |||||
| KAY, John Clement | Sekretär | 7 Beechfield Road Mayfield PR25 3BG Leyland Lancashire | British | 27891540001 | ||||||
| LIVESEY, Frederick Joseph | Sekretär | Wal Mar Dawbers Lane, Euxton PR7 6ED Chorley Lancashire | British | 32145610004 | ||||||
| SIMMONDS, Gordon Graham | Sekretär | Flat 1 20 Harrington Gardens SW7 4LS London | British | 34446930003 | ||||||
| STOTT, St John | Sekretär | 17 Uplands Chase Fulwood PR2 7AW Preston | British | 83024660001 | ||||||
| WIDDERS, Mark Lorimer | Sekretär | 12 Clovelly Drive Hillside PR8 3AJ Southport Merseyside | British | 2272770002 | ||||||
| GRAVITAS COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 25-31 Moorgate London | 900007520001 | |||||||
| HEMMINGS, Trevor James | Geschäftsführer | The Penthouse Retraite De La Mielle Route De La Haule St Brelade JE3 8BA Jersey Channel Islands | United Kingdom | British | 65090920001 | |||||
| JACKSON, Nigel Spencer | Geschäftsführer | 27 St Johns Road NW11 0PE London | England | British | 53249050001 | |||||
| JOHNS, Michael Stephen Mackelcan | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 22 Bowerdean Street London | British | 900007510001 | ||||||
| KAY, John Clement | Geschäftsführer | 7 Beechfield Road Mayfield PR25 3BG Leyland Lancashire | England | British | 27891540001 | |||||
| KENT-LEMON, Nigel William | Geschäftsführer | 29 Queensdale Road W11 4SB London | British | 6467990001 | ||||||
| LIVESEY, Frederick Joseph | Geschäftsführer | Wal Mar Dawbers Lane, Euxton PR7 6ED Chorley Lancashire | British | 32145610004 | ||||||
| STOTT, St John | Geschäftsführer | 17 Uplands Chase Fulwood PR2 7AW Preston | United Kingdom | British | 83024660001 | |||||
| WIDDERS, Mark Lorimer | Geschäftsführer | 12 Clovelly Drive Hillside PR8 3AJ Southport Merseyside | England | British | 2272770002 |
Hat TJH GROUP LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 27. Feb. 2009 Geliefert am 09. März 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental debenture between the company and the governor and company of the bank of scotland as agent and security trustee for the secured parties (the security trustee) | Erstellt am 15. Sept. 2000 Geliefert am 02. Okt. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The actual contingent present and/or future obligations and liabilities of the company to any of the secured parties under or pursuant to the supplemental debenture and any of the financing documents | |
Kurze Angaben The company assigned (as continuing security in favour of the security trustee) (as defined) with full title guarantee by way of security all of its rights title and interest (both present and future) in all and each of the acquisition documents (as defined). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 01. Okt. 1993 Geliefert am 19. Okt. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this charge and any of the financing documents (as therein defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0