VICTREX PLC

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameVICTREX PLC
    UnternehmensstatusAktiv
    RechtsformAktiengesellschaft
    Unternehmensnummer 02793780
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenNein
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von VICTREX PLC?

    • Herstellung von Kunststoffen in Primärform (20160) / Verarbeitendes Gewerbe

    Wo befindet sich VICTREX PLC?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Victrex Technology Centre
    Hillhouse International
    FY5 4QD Thornton Cleveleys
    Lancashire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von VICTREX PLC?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    MANDORLA LIMITED25. Feb. 199325. Feb. 1993

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von VICTREX PLC?

    ÜberfälligNein
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am30. Sept. 2026
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am31. März 2027
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2025

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für VICTREX PLC?

    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis10. Dez. 2026
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung24. Dez. 2026
    Letzte Bestätigungsbescheinigung
    Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis10. Dez. 2025
    ÜberfälligNein

    Welche sind die letzten Einreichungen für VICTREX PLC?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 23. März 2026

    • Kapital: GBP 871,237.11
    3 SeitenSH01

    Ernennung von Mr Peter Anthony Kiernan als Direktor am 01. März 2026

    2 SeitenAP01

    Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 12. Feb. 2026

    • Kapital: GBP 870,941.81
    3 SeitenSH01

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Re: short notice of a meeting other than an annual general meeting 06/02/2026
    RES13
    capital

    Beschluss zur Aufhebung der Bezugsrechte

    RES11
    capital

    Beschluss zur Ermächtigung zum Erwerb einer bestimmten Anzahl von Aktien

    RES09

    Beendigung der Bestellung von Jakob Oskar Sigurdsson als Geschäftsführer am 06. Feb. 2026

    1 SeitenTM01

    Konzernabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2025

    1 SeitenAA

    Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 15. Jan. 2026

    • Kapital: GBP 870,726.8
    3 SeitenSH01

    Ernennung von James Mathew Routh als Direktor am 01. Jan. 2026

    2 SeitenAP01

    Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 17. Dez. 2025

    • Kapital: GBP 870,711.24
    3 SeitenSH01

    Bestätigungserklärung erstellt am 10. Dez. 2025 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 21. März 2025

    • Kapital: GBP 870,521.07
    3 SeitenSH01

    Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 17. März 2025

    • Kapital: GBP 870,495.43
    3 SeitenSH01

    Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 10. März 2025

    • Kapital: GBP 870,454.71
    3 SeitenSH01

    Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 06. März 2025

    • Kapital: GBP 870,438
    3 SeitenSH01

    Beschlüsse

    Resolutions
    3 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Re - renewal of directors powers 07/02/2025
    RES13
    capital

    Beschluss zur Ermächtigung zum Erwerb einer bestimmten Anzahl von Aktien

    RES09
    capital

    Beschluss zur Zuteilung von Wertpapieren

    RES10

    Bestätigungserklärung erstellt am 24. Feb. 2025 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Konzernabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2024

    203 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Jane Elizabeth Toogood als Geschäftsführer am 07. Feb. 2025

    1 SeitenTM01

    Beschlüsse

    Resolutions
    4 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Aufhebung der Bezugsrechte

    RES11
    capital

    Beschlüsse

    Re: a general meeting of the company, other than an agm, may be called on not less than 14 clear days' notice. 09/02/2024
    RES13
    capital

    Beschluss zur Zuteilung von Wertpapieren

    RES10

    Ernennung von Urmi Prasad Richardson als Direktor am 01. Mai 2024

    2 SeitenAP01

    Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 18. März 2024

    • Kapital: GBP 870,349.03
    3 SeitenSH01

    Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 14. März 2024

    • Kapital: GBP 870,303.95
    3 SeitenSH01

    Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 07. März 2024

    • Kapital: GBP 870,251.71
    3 SeitenSH01

    Bestätigungserklärung erstellt am 24. Feb. 2024 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Konzernabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2023

    196 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von VICTREX PLC?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BRISLEY, Jane
    Thornton
    FY5 4QD Cleveleys
    Victrex Technology Centre Hillhouse International
    Lancashire
    United Kingdom
    Sekretär
    Thornton
    FY5 4QD Cleveleys
    Victrex Technology Centre Hillhouse International
    Lancashire
    United Kingdom
    284882140001
    ASHDOWN, Janet Elizabeth
    Victrex Technology Centre
    Hillhouse International
    FY5 4QD Thornton Cleveleys
    Victrex Plc
    Lancashire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Victrex Technology Centre
    Hillhouse International
    FY5 4QD Thornton Cleveleys
    Victrex Plc
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritish115126780001
    CONNOLLY, Brendan
    Victrex Technology Centre
    Hillhouse International
    FY5 4QD Thornton Cleveleys
    Victrex Plc
    Lancashire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Victrex Technology Centre
    Hillhouse International
    FY5 4QD Thornton Cleveleys
    Victrex Plc
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritish220417140001
    COX, Vivienne, Dr
    Victrex Technology Centre
    Hillhouse International
    FY5 4QD Thornton Cleveleys
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Victrex Technology Centre
    Hillhouse International
    FY5 4QD Thornton Cleveleys
    Lancashire
    United KingdomBritish290093100001
    KIERNAN, Peter Anthony
    Victrex Technology Centre
    Hillhouse International
    FY5 4QD Thornton Cleveleys
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Victrex Technology Centre
    Hillhouse International
    FY5 4QD Thornton Cleveleys
    Lancashire
    United KingdomBritish141911950001
    MELLING, Ian Clifford
    Victrex Technology Centre
    Hillhouse International
    FY5 4QD Thornton Cleveleys
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Victrex Technology Centre
    Hillhouse International
    FY5 4QD Thornton Cleveleys
    Lancashire
    United KingdomBritish297680690001
    RICHARDSON, Urmi Prasad
    Victrex Technology Centre
    Hillhouse International
    FY5 4QD Thornton Cleveleys
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Victrex Technology Centre
    Hillhouse International
    FY5 4QD Thornton Cleveleys
    Lancashire
    GermanyAmerican322618610001
    RIVAZ, Ros Catherine, Dr
    Victrex Technology Centre
    Hillhouse International
    FY5 4QD Thornton Cleveleys
    Victrex Plc
    Lancashire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Victrex Technology Centre
    Hillhouse International
    FY5 4QD Thornton Cleveleys
    Victrex Plc
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritish193793680001
    ROUTH, James Mathew
    Victrex Technology Centre
    Hillhouse International
    FY5 4QD Thornton Cleveleys
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Victrex Technology Centre
    Hillhouse International
    FY5 4QD Thornton Cleveleys
    Lancashire
    EnglandBritish343938890001
    THOMAS, David
    Victrex Technology Centre
    Hillhouse International
    FY5 4QD Thornton Cleveleys
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Victrex Technology Centre
    Hillhouse International
    FY5 4QD Thornton Cleveleys
    Lancashire
    United KingdomBritish246440710001
    BATESON, Anne Rosalind
    High Trees
    Great Holland
    CO13 0HZ Frinton On Sea
    Essex
    Bevollmächtigter Sekretär
    High Trees
    Great Holland
    CO13 0HZ Frinton On Sea
    Essex
    British900007490001
    BUTTERWORTH, Howard Alan
    Cartref 63 Manor Road
    BH31 6DT Verwood
    Dorset
    Sekretär
    Cartref 63 Manor Road
    BH31 6DT Verwood
    Dorset
    British36244060001
    GLADDEN, Brett
    Hilhouse International
    FY5 4QD Thornton Cleveleys
    Victrex Technology Centre
    Lancashire
    United Kingdom
    Sekretär
    Hilhouse International
    FY5 4QD Thornton Cleveleys
    Victrex Technology Centre
    Lancashire
    United Kingdom
    204326000001
    HULME, Gary Michael
    Victrex Technology Centre
    Hillhouse International
    FY5 4QD Thornton Cleveleys
    Lancashire
    Sekretär
    Victrex Technology Centre
    Hillhouse International
    FY5 4QD Thornton Cleveleys
    Lancashire
    English73159370002
    JACOBS, Muireann
    Hilhouse International
    FY5 4QD Thornton Cleveleys
    Victrex Technology Centre
    Lancashire
    United Kingdom
    Sekretär
    Hilhouse International
    FY5 4QD Thornton Cleveleys
    Victrex Technology Centre
    Lancashire
    United Kingdom
    202302840001
    KONCAREVIC, Suzana
    Victrex Technology Centre
    Hillhouse International
    FY5 4QD Thornton Cleveleys
    Lancashire
    Sekretär
    Victrex Technology Centre
    Hillhouse International
    FY5 4QD Thornton Cleveleys
    Lancashire
    169666300001
    PEACOCK, Michael William
    Etchilhampton
    SN10 3JR Devizes
    Box Hedge Cottage
    Wiltshire
    Sekretär
    Etchilhampton
    SN10 3JR Devizes
    Box Hedge Cottage
    Wiltshire
    British42159970010
    ROWLEY, Peter John, Dr
    14 Bennett Close
    The Pines
    AL7 4JA Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Sekretär
    14 Bennett Close
    The Pines
    AL7 4JA Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    British34531930001
    TILSTON, David Frank
    The Orchard
    1 Hare Lane
    KT10 9BT Claygate
    Surrey
    Sekretär
    The Orchard
    1 Hare Lane
    KT10 9BT Claygate
    Surrey
    British157476100001
    WALDEK, Louise
    Victrex Technology Centre
    Hillhouse International
    FY5 4QD Thornton Cleveleys
    Lancashire
    Sekretär
    Victrex Technology Centre
    Hillhouse International
    FY5 4QD Thornton Cleveleys
    Lancashire
    246440690001
    ARMITAGE, Richard James
    Victrex Technology Centre
    Hillhouse International
    FY5 4QD Thornton Cleveleys
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Victrex Technology Centre
    Hillhouse International
    FY5 4QD Thornton Cleveleys
    Lancashire
    EnglandBritish127111970004
    AZIZ, Jonathan Giles Ashley
    Lower Westwood
    BA15 2AF Bradford-On-Avon
    Westwood Manor
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    Lower Westwood
    BA15 2AF Bradford-On-Avon
    Westwood Manor
    Wiltshire
    British71198840007
    BAMFORD, John
    57 Meadow Crescent
    Carleton
    FY6 7QX Poulton Le Fylde
    Lancashire
    Geschäftsführer
    57 Meadow Crescent
    Carleton
    FY6 7QX Poulton Le Fylde
    Lancashire
    EnglandBritish36439000001
    BARROW, Andrew Stephen
    Victrex Technology Centre
    Hillhouse International
    FY5 4QD Thornton Cleveleys
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Victrex Technology Centre
    Hillhouse International
    FY5 4QD Thornton Cleveleys
    Lancashire
    EnglandBritish163605710001
    BREAM, Peter Edward
    Victrex Technology Centre
    Hillhouse International
    FY5 4QD Thornton Cleveleys
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Victrex Technology Centre
    Hillhouse International
    FY5 4QD Thornton Cleveleys
    Lancashire
    EnglandBritish77236000001
    BURDETT, Louisa Sachiko, Group Finance Director
    Victrex Technology Centre
    Hillhouse International
    FY5 4QD Thornton Cleveleys
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Victrex Technology Centre
    Hillhouse International
    FY5 4QD Thornton Cleveleys
    Lancashire
    United KingdomBritish184778640001
    BUTTERWORTH, Howard Alan
    Cartref 63 Manor Road
    BH31 6DT Verwood
    Dorset
    Geschäftsführer
    Cartref 63 Manor Road
    BH31 6DT Verwood
    Dorset
    British36244060001
    CARTER-MEGGS, Jonathan Charles
    73 Nasmyth Street
    Hammersmith
    W6 0HA London
    Geschäftsführer
    73 Nasmyth Street
    Hammersmith
    W6 0HA London
    British8112940001
    CLINCH, Anthony Gorman
    1 Crispin Way
    Farnham Common
    SL2 3UD Slough
    Berkshire
    Geschäftsführer
    1 Crispin Way
    Farnham Common
    SL2 3UD Slough
    Berkshire
    British35558850001
    COOPER, Timothy John
    Victrex Technology Centre
    Hillhouse International
    FY5 4QD Thornton Cleveleys
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Victrex Technology Centre
    Hillhouse International
    FY5 4QD Thornton Cleveleys
    Lancashire
    EnglandBritish175727970001
    COURT, Martin Lindsay
    Victrex Technology Centre
    Hillhouse International
    FY5 4QD Thornton Cleveleys
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Victrex Technology Centre
    Hillhouse International
    FY5 4QD Thornton Cleveleys
    Lancashire
    EnglandBritish196421380001
    DE SMEDT, Patrick Jean-Marie
    Victrex Technology Centre
    Hillhouse International
    FY5 4QD Thornton Cleveleys
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Victrex Technology Centre
    Hillhouse International
    FY5 4QD Thornton Cleveleys
    Lancashire
    EnglandBelgian147867630001
    DOUGAL, Andrew James Harrower
    Hilhouse International
    FY5 4QD Thornton Cleveleys
    Victrex Technology Centre
    Lancashire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Hilhouse International
    FY5 4QD Thornton Cleveleys
    Victrex Technology Centre
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritish42737230007
    FREW, Anita Margaret
    Victrex Technology Centre
    Hillhouse International
    FY5 4QD Thornton Cleveleys
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Victrex Technology Centre
    Hillhouse International
    FY5 4QD Thornton Cleveleys
    Lancashire
    United KingdomBritish24689070004
    HARPER, Peter Joseph
    Mayhall Lodge
    Oakway
    HP6 5PQ Amersham
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Mayhall Lodge
    Oakway
    HP6 5PQ Amersham
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish133340001

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0