VICTREX PLC
Überblick
| Unternehmensname | VICTREX PLC |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aktiv |
| Rechtsform | Aktiengesellschaft |
| Unternehmensnummer | 02793780 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Nein |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von VICTREX PLC?
- Herstellung von Kunststoffen in Primärform (20160) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich VICTREX PLC?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Victrex Technology Centre Hillhouse International FY5 4QD Thornton Cleveleys Lancashire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von VICTREX PLC?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| MANDORLA LIMITED | 25. Feb. 1993 | 25. Feb. 1993 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von VICTREX PLC?
| Überfällig | Nein |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 30. Sept. 2026 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 31. März 2027 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2025 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für VICTREX PLC?
| Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 10. Dez. 2026 |
|---|---|
| Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 24. Dez. 2026 |
| Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
| Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 10. Dez. 2025 |
| Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für VICTREX PLC?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 23. März 2026
| 3 Seiten | SH01 | ||||||||||||||||||
Ernennung von Mr Peter Anthony Kiernan als Direktor am 01. März 2026 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 12. Feb. 2026
| 3 Seiten | SH01 | ||||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jakob Oskar Sigurdsson als Geschäftsführer am 06. Feb. 2026 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2025 | 1 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 15. Jan. 2026
| 3 Seiten | SH01 | ||||||||||||||||||
Ernennung von James Mathew Routh als Direktor am 01. Jan. 2026 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 17. Dez. 2025
| 3 Seiten | SH01 | ||||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Dez. 2025 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 21. März 2025
| 3 Seiten | SH01 | ||||||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 17. März 2025
| 3 Seiten | SH01 | ||||||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 10. März 2025
| 3 Seiten | SH01 | ||||||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 06. März 2025
| 3 Seiten | SH01 | ||||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 24. Feb. 2025 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2024 | 203 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jane Elizabeth Toogood als Geschäftsführer am 07. Feb. 2025 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 4 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Ernennung von Urmi Prasad Richardson als Direktor am 01. Mai 2024 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 18. März 2024
| 3 Seiten | SH01 | ||||||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 14. März 2024
| 3 Seiten | SH01 | ||||||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 07. März 2024
| 3 Seiten | SH01 | ||||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 24. Feb. 2024 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2023 | 196 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von VICTREX PLC?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRISLEY, Jane | Sekretär | Thornton FY5 4QD Cleveleys Victrex Technology Centre Hillhouse International Lancashire United Kingdom | 284882140001 | |||||||
| ASHDOWN, Janet Elizabeth | Geschäftsführer | Victrex Technology Centre Hillhouse International FY5 4QD Thornton Cleveleys Victrex Plc Lancashire United Kingdom | England | British | 115126780001 | |||||
| CONNOLLY, Brendan | Geschäftsführer | Victrex Technology Centre Hillhouse International FY5 4QD Thornton Cleveleys Victrex Plc Lancashire United Kingdom | United Kingdom | British | 220417140001 | |||||
| COX, Vivienne, Dr | Geschäftsführer | Victrex Technology Centre Hillhouse International FY5 4QD Thornton Cleveleys Lancashire | United Kingdom | British | 290093100001 | |||||
| KIERNAN, Peter Anthony | Geschäftsführer | Victrex Technology Centre Hillhouse International FY5 4QD Thornton Cleveleys Lancashire | United Kingdom | British | 141911950001 | |||||
| MELLING, Ian Clifford | Geschäftsführer | Victrex Technology Centre Hillhouse International FY5 4QD Thornton Cleveleys Lancashire | United Kingdom | British | 297680690001 | |||||
| RICHARDSON, Urmi Prasad | Geschäftsführer | Victrex Technology Centre Hillhouse International FY5 4QD Thornton Cleveleys Lancashire | Germany | American | 322618610001 | |||||
| RIVAZ, Ros Catherine, Dr | Geschäftsführer | Victrex Technology Centre Hillhouse International FY5 4QD Thornton Cleveleys Victrex Plc Lancashire United Kingdom | United Kingdom | British | 193793680001 | |||||
| ROUTH, James Mathew | Geschäftsführer | Victrex Technology Centre Hillhouse International FY5 4QD Thornton Cleveleys Lancashire | England | British | 343938890001 | |||||
| THOMAS, David | Geschäftsführer | Victrex Technology Centre Hillhouse International FY5 4QD Thornton Cleveleys Lancashire | United Kingdom | British | 246440710001 | |||||
| BATESON, Anne Rosalind | Bevollmächtigter Sekretär | High Trees Great Holland CO13 0HZ Frinton On Sea Essex | British | 900007490001 | ||||||
| BUTTERWORTH, Howard Alan | Sekretär | Cartref 63 Manor Road BH31 6DT Verwood Dorset | British | 36244060001 | ||||||
| GLADDEN, Brett | Sekretär | Hilhouse International FY5 4QD Thornton Cleveleys Victrex Technology Centre Lancashire United Kingdom | 204326000001 | |||||||
| HULME, Gary Michael | Sekretär | Victrex Technology Centre Hillhouse International FY5 4QD Thornton Cleveleys Lancashire | English | 73159370002 | ||||||
| JACOBS, Muireann | Sekretär | Hilhouse International FY5 4QD Thornton Cleveleys Victrex Technology Centre Lancashire United Kingdom | 202302840001 | |||||||
| KONCAREVIC, Suzana | Sekretär | Victrex Technology Centre Hillhouse International FY5 4QD Thornton Cleveleys Lancashire | 169666300001 | |||||||
| PEACOCK, Michael William | Sekretär | Etchilhampton SN10 3JR Devizes Box Hedge Cottage Wiltshire | British | 42159970010 | ||||||
| ROWLEY, Peter John, Dr | Sekretär | 14 Bennett Close The Pines AL7 4JA Welwyn Garden City Hertfordshire | British | 34531930001 | ||||||
| TILSTON, David Frank | Sekretär | The Orchard 1 Hare Lane KT10 9BT Claygate Surrey | British | 157476100001 | ||||||
| WALDEK, Louise | Sekretär | Victrex Technology Centre Hillhouse International FY5 4QD Thornton Cleveleys Lancashire | 246440690001 | |||||||
| ARMITAGE, Richard James | Geschäftsführer | Victrex Technology Centre Hillhouse International FY5 4QD Thornton Cleveleys Lancashire | England | British | 127111970004 | |||||
| AZIZ, Jonathan Giles Ashley | Geschäftsführer | Lower Westwood BA15 2AF Bradford-On-Avon Westwood Manor Wiltshire | British | 71198840007 | ||||||
| BAMFORD, John | Geschäftsführer | 57 Meadow Crescent Carleton FY6 7QX Poulton Le Fylde Lancashire | England | British | 36439000001 | |||||
| BARROW, Andrew Stephen | Geschäftsführer | Victrex Technology Centre Hillhouse International FY5 4QD Thornton Cleveleys Lancashire | England | British | 163605710001 | |||||
| BREAM, Peter Edward | Geschäftsführer | Victrex Technology Centre Hillhouse International FY5 4QD Thornton Cleveleys Lancashire | England | British | 77236000001 | |||||
| BURDETT, Louisa Sachiko, Group Finance Director | Geschäftsführer | Victrex Technology Centre Hillhouse International FY5 4QD Thornton Cleveleys Lancashire | United Kingdom | British | 184778640001 | |||||
| BUTTERWORTH, Howard Alan | Geschäftsführer | Cartref 63 Manor Road BH31 6DT Verwood Dorset | British | 36244060001 | ||||||
| CARTER-MEGGS, Jonathan Charles | Geschäftsführer | 73 Nasmyth Street Hammersmith W6 0HA London | British | 8112940001 | ||||||
| CLINCH, Anthony Gorman | Geschäftsführer | 1 Crispin Way Farnham Common SL2 3UD Slough Berkshire | British | 35558850001 | ||||||
| COOPER, Timothy John | Geschäftsführer | Victrex Technology Centre Hillhouse International FY5 4QD Thornton Cleveleys Lancashire | England | British | 175727970001 | |||||
| COURT, Martin Lindsay | Geschäftsführer | Victrex Technology Centre Hillhouse International FY5 4QD Thornton Cleveleys Lancashire | England | British | 196421380001 | |||||
| DE SMEDT, Patrick Jean-Marie | Geschäftsführer | Victrex Technology Centre Hillhouse International FY5 4QD Thornton Cleveleys Lancashire | England | Belgian | 147867630001 | |||||
| DOUGAL, Andrew James Harrower | Geschäftsführer | Hilhouse International FY5 4QD Thornton Cleveleys Victrex Technology Centre Lancashire United Kingdom | United Kingdom | British | 42737230007 | |||||
| FREW, Anita Margaret | Geschäftsführer | Victrex Technology Centre Hillhouse International FY5 4QD Thornton Cleveleys Lancashire | United Kingdom | British | 24689070004 | |||||
| HARPER, Peter Joseph | Geschäftsführer | Mayhall Lodge Oakway HP6 5PQ Amersham Buckinghamshire | United Kingdom | British | 133340001 |
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0