OAKAPPLE ESTATES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameOAKAPPLE ESTATES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02795253
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von OAKAPPLE ESTATES LIMITED?

    • (7011) /

    Wo befindet sich OAKAPPLE ESTATES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    9th Floor Bond Court
    LS1 2JZ Leeds
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von OAKAPPLE ESTATES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CHANGEADAPT LIMITED03. März 199303. März 1993

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von OAKAPPLE ESTATES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Aug. 2007

    Welche sind die letzten Einreichungen für OAKAPPLE ESTATES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Aug. 2013

    5 Seiten4.68

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    19 Seiten4.72

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Glendevon House Hawthorn Park Coal Road Leeds West Yorkshire LS14 1PQ am 11. Juli 2013

    2 SeitenAD01

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. März 2013

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Sept. 2012

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. März 2012

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Sept. 2011

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. März 2011

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 20. Sept. 2010

    5 Seiten4.68

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    5 Seiten4.20

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren am 21. Sept. 2009

    LRESEX

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2007

    18 SeitenAA

    legacy

    5 Seiten395

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    3 Seiten395

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2006

    20 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    7 Seiten363s

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    3 Seiten395

    Wer sind die Geschäftsführer von OAKAPPLE ESTATES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    KERNYCKYJ, Simon Marcus
    26 Airedale Drive
    Horsforth
    LS18 5ED Leeds
    West Yorkshire
    Sekretär
    26 Airedale Drive
    Horsforth
    LS18 5ED Leeds
    West Yorkshire
    BritishSolicitor104714080001
    MARSH, David Howard
    8 Harlech Fold
    Lodge Moor
    S10 4NS Sheffield
    South Yorkshire
    Geschäftsführer
    8 Harlech Fold
    Lodge Moor
    S10 4NS Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritishChartered Accountant94938960001
    TAYLOR, Philip John
    Bridge House
    3 Woodlands Drive
    BD10 0NX Bradford
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Bridge House
    3 Woodlands Drive
    BD10 0NX Bradford
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector86072370001
    COGGINS, Ian
    9 Priory Close
    LS22 7TH Wetherby
    West Yorkshire
    Sekretär
    9 Priory Close
    LS22 7TH Wetherby
    West Yorkshire
    BritishAccountant60571740001
    ELLIS, Margaret Hannah
    12 Appletree Way
    Sherburn In Elmet
    LS25 6DQ Leeds
    Sekretär
    12 Appletree Way
    Sherburn In Elmet
    LS25 6DQ Leeds
    BritishAccountant11468600003
    RUSHWORTH, Justin Gary
    The Crossing Cottage
    Horncastle Road
    PE21 9HY Boston
    Lincolnshire
    Sekretär
    The Crossing Cottage
    Horncastle Road
    PE21 9HY Boston
    Lincolnshire
    British41583160001
    TAYLOR, June
    The Bungalow 10a Hill Rise Grove
    LS13 2HQ Leeds
    West Yorkshire
    Sekretär
    The Bungalow 10a Hill Rise Grove
    LS13 2HQ Leeds
    West Yorkshire
    British26745470001
    TAYLOR, Philip John
    Bridge House
    3 Woodlands Drive
    BD10 0NX Bradford
    West Yorkshire
    Sekretär
    Bridge House
    3 Woodlands Drive
    BD10 0NX Bradford
    West Yorkshire
    British86072370001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    RATCLIFFE, David
    4 Elmfield Court
    Birkenshaw
    BD11 2LR Bradford
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    4 Elmfield Court
    Birkenshaw
    BD11 2LR Bradford
    West Yorkshire
    BritishManaging Director61365920002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Hat OAKAPPLE ESTATES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 08. Juli 2008
    Geliefert am 09. Juli 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Juli 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 26. März 2008
    Geliefert am 28. März 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land on the east side of ravenscliffe avenue eccleshill bradford t/n WYK387655.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. März 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 26. Okt. 2006
    Geliefert am 01. Nov. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land k/a land on the east side of ravenscliffe avenue eccleshill bradford. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 01. Nov. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Shares charge
    Erstellt am 11. Juni 2003
    Geliefert am 20. Juni 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The deposited property being share certificates of 5,000 ordinary shares of £1.00 each and undated stock transfer form and/or the proceeds of sale thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Fortis Bank S.A./N.V.
    Transaktionen
    • 20. Juni 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Juli 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee bond
    Erstellt am 06. Sept. 2002
    Geliefert am 19. Sept. 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £150,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The band and the account and all money from time to time. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Kone PLC
    Transaktionen
    • 19. Sept. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 27. Juli 2001
    Geliefert am 31. Juli 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land and premises at clare hill headlands huddersfield t/no WYK624543.. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 31. Juli 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 12. Nov. 1999
    Geliefert am 16. Nov. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 16. Nov. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 12. Nov. 1999
    Geliefert am 16. Nov. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h land k/a the manor house the cad beeston leeds west yorkshire. T/no. Wyk 470958.. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 16. Nov. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 12. Nov. 1999
    Geliefert am 16. Nov. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a 16 liinnhe avenue meadway bradford west yorkshire. T/no. Wyk 361774.. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 16. Nov. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 12. Nov. 1999
    Geliefert am 16. Nov. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All f/h land k/a 8-16 (even) nelson street and 27-29 (odd) wellington road dewsbury kirklees west yorkshire t/no. Wyk 627704, wyk 627708 and wyk 258522. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 16. Nov. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 12. Nov. 1999
    Geliefert am 16. Nov. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a land and buildings 85 and 87 daisy hill dewsbury west yorkshire. T/no. Wyk 567777.. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 16. Nov. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Okt. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 24. Juni 1999
    Geliefert am 02. Juli 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Philip John Taylor
    Transaktionen
    • 02. Juli 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Nov. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 18. Dez. 1998
    Geliefert am 05. Jan. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H the manor cad beeston leeds west yorkshire-WYK470958. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Jan. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Nov. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Juli 1998
    Geliefert am 17. Juli 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The presbytery st anthonys church wrose road wrose bradford. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Juli 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Okt. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 21. Apr. 1998
    Geliefert am 06. Mai 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H 16 lhinne avenue meadway bradford west yorkshire t/n-WYK361774.. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Mai 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Nov. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Apr. 1998
    Geliefert am 14. Apr. 1998
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £105,000 and any other monies owed from time to time due from the company to the chargee under the terms of this legal charge
    Kurze Angaben
    F/H part of the 3RD floor 8, 10 and 12 nelson street dewsbury west yorkshire t/n-WYK258522.
    Berechtigte Personen
    • The Council of the Borough of Kirklees
    Transaktionen
    • 14. Apr. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Apr. 1998
    Geliefert am 14. Apr. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Legal charge over 8-16 nelson street 27-29 wellington road dewsbury west yorkshire t/n-WYK258522. Floating charge over all unfixed plant machinery and other assets and equipment. Assignment of the goodwill of the business and the benefit of the licence or certificate.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Co-Operative Bank P.L.C.
    Transaktionen
    • 14. Apr. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Nov. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assignment of rents
    Erstellt am 19. Dez. 1997
    Geliefert am 31. Dez. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Assignment of the benefit of all rents licence or tenancy fees payable by any lessee licensee or tenant of any part of the property k/a machells mill foundry street dewsbury west yorkshire t/n-WYK537208.
    Berechtigte Personen
    • Newcastle Building Society
    Transaktionen
    • 31. Dez. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Nov. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 19. Dez. 1997
    Geliefert am 31. Dez. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H machells mill foundry street dewsbury west yorkshire t/n-WKY537208 together with all buildings erections fixtures fittings and fixed plant and machinery and materials for the time being thereon or to be erected thereon or fixed to or incorporated in all buildings erected ot to be erected on the property and all improvments and additions thereto.
    Berechtigte Personen
    • Newcastle Building Society
    Transaktionen
    • 31. Dez. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Nov. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of floating charge
    Erstellt am 19. Dez. 1997
    Geliefert am 31. Dez. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of floating charge all its undertaking and all its property assets and rights whatsoever and wheresoever present and/or future.
    Berechtigte Personen
    • Newcastle Building Society
    Transaktionen
    • 31. Dez. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Nov. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 31. Dez. 1996
    Geliefert am 09. Jan. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H machells mill foundry street dewsbury west yorkshire t/no WYK537208 and the proceeds of sale thereof and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Jan. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Nov. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 08. Dez. 1994
    Geliefert am 13. Dez. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Dez. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Nov. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 01. Nov. 1994
    Geliefert am 04. Nov. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a part of zone 4 harrogate road apperley bridge bradford west yorks. T/n WYK326748 and or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Nov. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Nov. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat OAKAPPLE ESTATES LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    21. Sept. 2009Beginn der Liquidation
    17. Dez. 2013Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    David Frederick Wilson
    Begbies Traynor
    Glendevon House
    LS14 1PQ Hawthorn Park
    Coal Road Leeds
    Praktiker
    Begbies Traynor
    Glendevon House
    LS14 1PQ Hawthorn Park
    Coal Road Leeds
    Gerald Maurice Krasner
    Glendevon House Hawthorn Park
    Coal Road
    LS14 1PQ Leeds
    Praktiker
    Glendevon House Hawthorn Park
    Coal Road
    LS14 1PQ Leeds

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0