TELEWEST COMMUNICATIONS (MIDLANDS AND NORTH WEST) LIMITED

TELEWEST COMMUNICATIONS (MIDLANDS AND NORTH WEST) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTELEWEST COMMUNICATIONS (MIDLANDS AND NORTH WEST) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02795350
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von TELEWEST COMMUNICATIONS (MIDLANDS AND NORTH WEST) LIMITED?

    • Sonstige Telekommunikationsaktivitäten (61900) / Information und Kommunikation

    Wo befindet sich TELEWEST COMMUNICATIONS (MIDLANDS AND NORTH WEST) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von TELEWEST COMMUNICATIONS (MIDLANDS AND NORTH WEST) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    SBC CABLECOMMS (UK) LIMITED22. Apr. 199322. Apr. 1993
    PIPPIN25. Feb. 199325. Feb. 1993

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TELEWEST COMMUNICATIONS (MIDLANDS AND NORTH WEST) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2020

    Welche sind die letzten Einreichungen für TELEWEST COMMUNICATIONS (MIDLANDS AND NORTH WEST) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    11 SeitenLIQ13

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 10. Dez. 2021

    LRESSP

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    5 SeitenLIQ01

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse 500 Brook Drive Reading RG2 6UU verlegt

    2 SeitenAD03

    Die Adresse der Registerinspektion wurde auf 500 Brook Drive Reading RG2 6UU geändert

    2 SeitenAD02

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 500 Brook Drive Reading RG2 6UU United Kingdom zum 1 More London Place London SE1 2AF am 16. Dez. 2021

    2 SeitenAD01

    legacy

    91 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    1 SeitenAGREEMENT1

    legacy

    1 SeitenAGREEMENT1

    Ernennung von Vmed O2 Secretaries Limited als Sekretär am 01. Nov. 2021

    2 SeitenAP04

    Beendigung der Bestellung von Gillian Elizabeth James als Sekretär am 01. Nov. 2021

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Mine Ozkan Hifzi als Geschäftsführer am 01. Nov. 2021

    1 SeitenTM01

    legacy

    91 SeitenPARENT_ACC

    Beendigung der Bestellung von Caroline Bernadette Elizabeth Withers als Geschäftsführer am 01. Okt. 2021

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Roderick Gregor Mcneil als Geschäftsführer am 01. Okt. 2021

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Mark David Hardman als Direktor am 01. Okt. 2021

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Julia Louise Boyle als Direktor am 01. Okt. 2021

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Luke Milner als Geschäftsführer am 31. Aug. 2021

    1 SeitenTM01

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE1

    Änderung der Details des Direktors für Caroline Bernadette Elizabeth Withers am 26. Apr. 2021

    2 SeitenCH01

    Ernennung von Luke Milner als Direktor am 01. März 2021

    2 SeitenAP01

    legacy

    89 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    1 SeitenAGREEMENT1

    Wer sind die Geschäftsführer von TELEWEST COMMUNICATIONS (MIDLANDS AND NORTH WEST) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    VMED O2 SECRETARIES LIMITED
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    260
    Berkshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Bath Road
    SL1 4DX Slough
    260
    Berkshire
    United Kingdom
    Art des AusweisesBritische Gesellschaft mit beschränkter Haftung
    Registrierungsnummer04272689
    79050630041
    BOYLE, Julia Louise
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Geschäftsführer
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    United KingdomBritish287980330001
    HARDMAN, Mark David
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Geschäftsführer
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    United KingdomBritish201468840001
    BURNS, Clive
    The Cottage
    Lamer Hill Gate Lower Gustard Wood
    AL4 8RX Wheathampstead
    Hertfordshire
    Sekretär
    The Cottage
    Lamer Hill Gate Lower Gustard Wood
    AL4 8RX Wheathampstead
    Hertfordshire
    British71073800001
    HULL, Victoria Mary, Sol
    Flat 2
    53 Palace Gardens Terrace Kensington
    W8 4SB London
    Sekretär
    Flat 2
    53 Palace Gardens Terrace Kensington
    W8 4SB London
    British77283810001
    JAMES, Gillian Elizabeth
    Brook Drive
    RG2 6UU Reading
    500
    United Kingdom
    Sekretär
    Brook Drive
    RG2 6UU Reading
    500
    United Kingdom
    151395740001
    LAVER, John Michael
    Brook House Homestead Road
    TN8 6JD Edenbridge
    Kent
    Sekretär
    Brook House Homestead Road
    TN8 6JD Edenbridge
    Kent
    British8207040001
    MOORE, Lois Mendenhall
    Flat 12
    3 Rutland Gate
    SW7 1BL London
    Middlesex
    Sekretär
    Flat 12
    3 Rutland Gate
    SW7 1BL London
    Middlesex
    American33384190002
    SUGDEN, Andrew
    9 Grange Park
    GU21 4BX Woking
    Surrey
    Sekretär
    9 Grange Park
    GU21 4BX Woking
    Surrey
    British75703620001
    TURNER, John Michael
    Pine Lodge
    East Road
    KT13 0LG Weybridge
    Surrey
    England
    Sekretär
    Pine Lodge
    East Road
    KT13 0LG Weybridge
    Surrey
    England
    American35605270001
    VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Sekretär
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107380002
    BRYAN, Danny Frank
    The Marble Suite
    The Mansion Ottershaw Park
    KT16 0QG Ottershaw
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Marble Suite
    The Mansion Ottershaw Park
    KT16 0QG Ottershaw
    Surrey
    American41071470001
    BURDICK, Charles James
    9 Ormonde Place
    SW1W 8HX London
    Geschäftsführer
    9 Ormonde Place
    SW1W 8HX London
    British-American52311710004
    CAREY, Ernest James
    Fairoaks
    Fairoaks Lane
    KT22 0TQ Oxshott
    Surrey
    Geschäftsführer
    Fairoaks
    Fairoaks Lane
    KT22 0TQ Oxshott
    Surrey
    Usa35979290002
    CASTELL, William Thomas
    Brook Drive
    RG2 6UU Reading
    500
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Brook Drive
    RG2 6UU Reading
    500
    United Kingdom
    EnglandBritish248424970001
    COOK, Stephen Sands
    24a Redcliffe Square
    SW10 9JY London
    Geschäftsführer
    24a Redcliffe Square
    SW10 9JY London
    British73000530008
    DALVI, Ajit
    1400 Lake Hearn Drive
    30319 Atlanta
    Georgia
    Usa
    Geschäftsführer
    1400 Lake Hearn Drive
    30319 Atlanta
    Georgia
    Usa
    Indian56767100001
    DAVIDSON, Stephen James
    Hughenden Close
    Denner Hill
    HP16 0JJ Great Missenden
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Hughenden Close
    Denner Hill
    HP16 0JJ Great Missenden
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish92784240001
    DUNN, Robert Dominic
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    EnglandBritish179134020002
    ELSON, Barry Russell
    1400 Lake Hearn Drive
    30319 Atlanta
    Georgia
    Usa
    Geschäftsführer
    1400 Lake Hearn Drive
    30319 Atlanta
    Georgia
    Usa
    American34726960001
    GALE, Robert Charles
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    EnglandBritish96956740001
    GILLIAM, Michael Newell
    Cedar House
    7 Orchards Close Elmstead Road
    KT14 6SG West Byfleet
    Surrey
    Geschäftsführer
    Cedar House
    7 Orchards Close Elmstead Road
    KT14 6SG West Byfleet
    Surrey
    Us37473900001
    HAYES, James
    1400 Lake Hearn Drive
    30319 Atlanta
    Georgia
    United States Of America
    Geschäftsführer
    1400 Lake Hearn Drive
    30319 Atlanta
    Georgia
    United States Of America
    American34461310001
    HIFZI, Mine Ozkan
    Brook Drive
    RG2 6UU Reading
    500
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Brook Drive
    RG2 6UU Reading
    500
    United Kingdom
    EnglandBritish182167230001
    HOWE, Gerard Joseph
    Silvergarth
    19 Badgers Hill Wentworth
    GU25 4BA Virginia Water
    Surrey
    Geschäftsführer
    Silvergarth
    19 Badgers Hill Wentworth
    GU25 4BA Virginia Water
    Surrey
    American35926250001
    HULL, Victoria Mary, Sol
    Flat 2
    53 Palace Gardens Terrace Kensington
    W8 4SB London
    Geschäftsführer
    Flat 2
    53 Palace Gardens Terrace Kensington
    W8 4SB London
    British77283810001
    ILLSLEY, Anthony Kim
    4 St Peters Road
    TW1 1QX Twickenham
    Middlesex
    Geschäftsführer
    4 St Peters Road
    TW1 1QX Twickenham
    Middlesex
    United KingdomBritish43836970001
    KELLEY, Lloyd Earl
    Willow Hale Thorley Close
    KT14 6JE West Byfleet
    Surrey
    Geschäftsführer
    Willow Hale Thorley Close
    KT14 6JE West Byfleet
    Surrey
    American40812990001
    MACKENZIE, Robert Mario
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    United KingdomBritish47785600002
    MCNEIL, Roderick Gregor
    Brook Drive
    RG2 6UU Reading
    500
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Brook Drive
    RG2 6UU Reading
    500
    United Kingdom
    EnglandBritish267964620001
    MCWHIRTER, Anthony Sheridan
    18 Bagleys Lane
    SW6 2AR London
    Geschäftsführer
    18 Bagleys Lane
    SW6 2AR London
    British66053570001
    MICHELS, Alan
    Catalina Abbotswood Drive
    St Georges Hill
    KT13 0LT Weybridge
    Surrey
    Geschäftsführer
    Catalina Abbotswood Drive
    St Georges Hill
    KT13 0LT Weybridge
    Surrey
    British43658810001
    MILNER, Luke
    Brook Drive
    RG2 6UU Reading
    500
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Brook Drive
    RG2 6UU Reading
    500
    United Kingdom
    EnglandBritish279697130001
    MOORE, Lois Mendenhall
    Flat 12
    3 Rutland Gate
    SW7 1BL London
    Middlesex
    Geschäftsführer
    Flat 12
    3 Rutland Gate
    SW7 1BL London
    Middlesex
    American33384190002
    PASCU, Severina-Pompilia
    Brook Drive
    RG2 6UU Reading
    500
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Brook Drive
    RG2 6UU Reading
    500
    United Kingdom
    SwitzerlandRomanian267797160001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei TELEWEST COMMUNICATIONS (MIDLANDS AND NORTH WEST) LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Brook Drive
    RG2 6UU Reading
    500
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    Brook Drive
    RG2 6UU Reading
    500
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandEngland And Wales
    RechtsgrundlageUk England And Wales
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer3291383
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat TELEWEST COMMUNICATIONS (MIDLANDS AND NORTH WEST) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 21. März 2017
    Geliefert am 23. März 2017
    Vollständig erfüllt
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch as Security Trustee
    Transaktionen
    • 23. März 2017Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 04. Mai 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 01. Feb. 2017
    Geliefert am 07. Feb. 2017
    Vollständig erfüllt
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch as Security Trustee
    Transaktionen
    • 07. Feb. 2017Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 04. Mai 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 26. Apr. 2016
    Geliefert am 27. Apr. 2016
    Vollständig erfüllt
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch as Security Trustee
    Transaktionen
    • 27. Apr. 2016Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 04. Mai 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 30. Apr. 2015
    Geliefert am 06. Mai 2015
    Vollständig erfüllt
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 06. Mai 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 04. Mai 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 30. März 2015
    Geliefert am 01. Apr. 2015
    Vollständig erfüllt
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 01. Apr. 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 04. Mai 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 28. Jan. 2015
    Geliefert am 06. Feb. 2015
    Vollständig erfüllt
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 06. Feb. 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 04. Mai 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 04. Apr. 2014
    Geliefert am 10. Apr. 2014
    Vollständig erfüllt
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 10. Apr. 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 04. Mai 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 28. März 2014
    Geliefert am 02. Apr. 2014
    Vollständig erfüllt
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 02. Apr. 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 04. Mai 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 07. Juni 2013
    Geliefert am 14. Juni 2013
    Vollständig erfüllt
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag,London Branch
    Transaktionen
    • 14. Juni 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 04. Mai 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Confirmation deed
    Erstellt am 03. März 2011
    Geliefert am 15. März 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the security trustee, all monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and all monies due or to become due from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The chargor acknowledges and agrees to the issuance of the new notes, the new guarantees and the new indenture and the transactions contemplated thereby and hereby confirms all payment and performance obligations contingent or otherwise and undertakings arising under or in connection with its respective agreements, guarantees, pledges and grants of liens under and subject to the terms of the liens, the group intercreditor agreement and each security document to which it is party. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 15. März 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 04. Mai 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Composite debenture
    Erstellt am 29. Juni 2010
    Geliefert am 08. Juli 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee, all monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and all monies due or to become due from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 08. Juli 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 04. Mai 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Confirmation deed
    Erstellt am 15. Apr. 2010
    Geliefert am 29. Apr. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) on any account whatosover under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The chargor acknowledges and agrees to the new sfa and the transactions contemplated thereby and confirm all payment and performance obligations contingent or otherwise and undertakings arising under or in connection with its respective agreements, guarantees, pledges and grants of encumbrances under and subject to the terms of the group intercreditor agreement and each security document to which it is party. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 29. Apr. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 04. Mai 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A composite debenture
    Erstellt am 19. Jan. 2010
    Geliefert am 22. Jan. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag London Branch (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 22. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 04. Mai 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Composite debenture
    Erstellt am 19. Jan. 2010
    Geliefert am 22. Jan. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag London Branch (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 22. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 28. Mai 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Composite debenture
    Erstellt am 03. März 2006
    Geliefert am 10. März 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee, from the obligors (or any one or more of them) to the finance parties (or any one or more of them) on any account whatsoever, from all or any of the obligors to the restructuring swap counterparties and/or the existing hedge counter parties and to the new hedge counterparties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch (As Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 10. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Mai 2010Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 24. Mai 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Composite debenture
    Erstellt am 21. Dez. 2004
    Geliefert am 23. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (As Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 23. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    New composite guarantee and debenture
    Erstellt am 14. Juli 2004
    Geliefert am 28. Juli 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    A first equitable charge over the stocks, shares and any other interests of the company in front row television LTD, any tcn entity or any joint venture. A first floating charge over all other present and future assets of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cibc World Markets PLC in Its Capacity as New Security Trustee for the New Beneficiaries
    Transaktionen
    • 28. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Juli 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    New composite guarantee and debenture
    Erstellt am 14. Juli 2004
    Geliefert am 22. Juli 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    A first equitable charge over the stocks, shares and any other interests of tcn in front row television LTD, any tcn entity or any joint venture. A first floating charge over all other present and future assets of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cibc World Markets PLC in Its Capacity as New Security Trustee for the New Beneficiaries
    Transaktionen
    • 22. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Juli 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Guarantee and debenture made between (1) telewest communications networks limited, (2) the original charging subsidiaries, (3) the original charging partnerships and (4) telewest finance corporation (the "us "borrower") 5). cibc world markets PLC in its capacity as security trustee issued by the company.
    Erstellt am 16. März 2001
    Geliefert am 23. März 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    A).all amounts payable to cibc world markets PLC as security trustee to the extent only of the amount payable to the security trustee (for its own account) pursuant to the agreement or any of the security trustee security documents in relation to the period up to and including its retirement as security trustee pursuant to the provisions of the intercreditor deed and all amounts payable to any other person who may be appointed as security trustee pursuant to the provisions of the intercreditor deed to the extent only of the amounts payable to the security trustee (for its own account) pursuant to the agreement or any of the security trustee security documents in relation to the period up to and including its retirement as security trustee pursuant to the provisions of the intercreditor deed; (b) all indebtedness covenanted to be paid or discharged by all or any of the chargors to all or any of the finance parties under the senior documents; (c) all indebtedness covenanted to be paid or discharged by all or any of the chargors to the hedge counterparties under the hedging arrangements; (d) all indebtedness of the lessees to the lessors (or any of them) under the lease documents; and (e) all financial obligations due to crosby under the crosby documents
    Kurze Angaben
    I). all the company's present and future rights, title, benefit and interest in and under the loan stock (as defined) from time to time ii). All rights title benefit and interest in and to amounts payable to the company arising under the bbc jv management services agreement, and the UK gold jv management services agreement iii). All rights title benefit and interest in and to amounts payable to the company under the bbc jv agreement, the UK gold jv agreement and any other subscription and shareholder agreement entered into in relation to a joint venture, including (but not limited to) all amounts payable under clauses 19 and 20 of the bbc jv agreement and clauses 19 and 20 of the UK gold jv agreement and iv). All the company's present and future rights title benefit and interest in and under the intercompany loan agreement together with first floating charge all the company's undertaking property and assets not charged by way of fixed charge .
    Berechtigte Personen
    • Cibc World Markets PLC (In Its Capacity as Security Trustee)
    Transaktionen
    • 23. März 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Juli 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Guarantee and debenture made between (1) telewest communications networks limited, (2) the original charging subsidiaries, (3) the original charging partnerships and (4) cibc world markets PLC in its capacity as security trustee issued by the company
    Erstellt am 20. Mai 1999
    Geliefert am 03. Juni 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    (A) all amounts payable to cibc world markets PLC as security trustee to the extent only of the amount payable to the security trustee (for its own account) pursuant to the agreement or any of the security trustee security documents in relation to the period up to and including its retirement as security trustee pursuant to the provisions of the intercreditor deed and all amounts payable to any other person who may be appointed as security trustee pursuant to the provisions of the intercreditor deed to the extent only of the amounts payable to the security trustee (for its own account) pursuant to the agreement or any of the security trustee security documents in relation to the period up to and including its retirement as security trustee pursuant to the provisions of the intercreditor deed; (b) all indebtedness covenanted to be paid or discharged by all or any of the chargors to all or any of the finance parties under the senior documents; (c) all indebtedness covenanted to be paid or discharged by all or any of the chargors to the hedge counterparties under the hedging arrangements; (d) all indebtedness of the lessees to the lessors (or any of them) under the lease documents; and (e) all financial obligations due to crosby under the crosby documents
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge (I) without prejudice to clause 3.1(b) of the debenture all the company's right, title and interest in and to all claims to which the company is at the date of the debenture or may thereafter become entitled under and in relation to each of the lease documents to which it is a party.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cibc World Markets PLC (In Its Capacity as Security Trustee)
    Transaktionen
    • 03. Juni 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Dez. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture dated 26TH september 1998 made between (1)telewest communications networks limited,(1) the original charging subsidiaries (2) the original charging partnerships (3) and the toronto-dominion bank in its capacity as security trustee (4)
    Erstellt am 26. Sept. 1998
    Geliefert am 08. Okt. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies, obligations and liabilities whether actual or contingent which are covenanted or guaranteed to be paid by each chargor (as defined therein) to the chargees under or pursuant to the agreement dated 27TH march 1998 and/or the security trust deed and/or all or any of the other security documents (as defined)
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Toronto Dominion Bank (In Its Capacity as Security Trustee,Agent and First Beneficiary Under the Terms of the Debenture), the Arrangers and the Banks (or Any of Them).
    Transaktionen
    • 08. Okt. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Juni 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 24. Juli 1996
    Geliefert am 07. Aug. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies, obligations and liabilities whether actual or contingent which are covenanted or guaranteed to be paid by each chargor (as defined therein) to cibc wood gundy PLC (in its capacity as security trustee) for the account of (a) the agent, the security trustee, the arrangers and the banks (or any of them) under or pursuant to the agreement dated 22ND may 1996 and/or this deed and/or the security trust deed and/or any of the other security documents; (b) the interest rate beneficiaries (or any of them) in respect of the interest rate protection arrangements; and (c) the bond providers (or any of them) in respect of any indemnity from each chargor issued in connection with the bond provision arrangements (all as defined in the deed) (collectively the beneficiaries) whether by acceleration or otherwise
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cibc Wood Gundy PLC (As Security Trustee)
    Transaktionen
    • 07. Aug. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Juni 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat TELEWEST COMMUNICATIONS (MIDLANDS AND NORTH WEST) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    19. Nov. 2022Soll aufgelöst werden am
    10. Dez. 2021Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Derek Hyslop
    Atria One, 144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    Praktiker
    Atria One, 144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praktiker
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0