SINGLEPOINT (4U) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | SINGLEPOINT (4U) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02795597 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SINGLEPOINT (4U) LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich SINGLEPOINT (4U) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von SINGLEPOINT (4U) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| 4U LIMITED | 03. Okt. 1994 | 03. Okt. 1994 |
| CAUDWELL AIRTIME SERVICES LIMITED | 28. Mai 1993 | 28. Mai 1993 |
| HAJCO 117 LIMITED | 03. März 1993 | 03. März 1993 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SINGLEPOINT (4U) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für SINGLEPOINT (4U) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 15. März 2021
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mrs Janine Butler als Direktor am 23. Feb. 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Nigel Evans als Geschäftsführer am 23. Feb. 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. Feb. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. Feb. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. März 2019 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 256 Seiten | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | AGREEMENT2 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||||||||||
Ernennung von Mr Andrew Michael Yorston als Direktor am 02. Apr. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Diane Josephine Mcintyre als Geschäftsführer am 16. März 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. Feb. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2018 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 1 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. Feb. 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2017 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. Feb. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von SINGLEPOINT (4U) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VODAFONE CORPORATE SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | 75473330004 | |||||||
| BUTLER, Janine | Geschäftsführer | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | England | British | 277534960001 | |||||
| YORSTON, Andrew Michael | Geschäftsführer | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | British | 257275320001 | |||||
| BENNETT, Craig | Sekretär | 14 Conway Road Knypersley ST8 7AL Stoke On Trent Staffordshire | British | 34704080001 | ||||||
| HOWIE, Philip Robert Sutherland | Sekretär | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | British | 77939460004 | ||||||
| HAJCO SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Berkeley Court Borough Road ST5 1TT Newcastle Under Lyme Staffordshire | 900006890001 | |||||||
| ALLEN, Christian Philip Quentin | Geschäftsführer | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | British | 123612980001 | ||||||
| BARTON, John Michael | Geschäftsführer | 30 Deerings Drive HA5 2NZ Pinner Middlesex | British | 34831450001 | ||||||
| BENNETT, Craig | Geschäftsführer | 14 Conway Road Knypersley ST8 7AL Stoke On Trent Staffordshire | British | 34704080001 | ||||||
| BIRNEY, James Gary | Geschäftsführer | Three Acre Wood Bridgemere Lane CW5 7PL Nantwich Cheshire | British | 86869670001 | ||||||
| BROCKLEHURST, Nigel | Geschäftsführer | 1 The Hollyhocks Reading Road, Harwell OX11 0LX Didcot Oxfordshire | British | 83126790001 | ||||||
| BROWN, Peter | Geschäftsführer | Hawthorne Cottage 19 Station Road Barlaston ST12 9DH Stoke-On-Trent Staffordshire | British | 58317370001 | ||||||
| CAUDWELL, Brian | Geschäftsführer | Fradswell Hall Fradswell ST18 0EX Stafford Staffordshire England | British | 15920410002 | ||||||
| CAUDWELL, John David | Geschäftsführer | Broughton Hall Broughton ST21 6NS Eccleshall Staffordshire | England | British | 21185880002 | |||||
| CHESWORTH, Paul | Geschäftsführer | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | British | 99525280001 | ||||||
| DARBY, Gavin John | Geschäftsführer | Rodona House Rodona Road St Georges Hill KT13 0NP Weybridge Surrey | England | British | 99277850001 | |||||
| DAVIES, Andrew Mark | Geschäftsführer | 19 Burnside WA15 0SG Halebarns Cheshire | British | 86869710001 | ||||||
| DOBSON, Philip | Geschäftsführer | The Holtridge Norbury Nr Cholmondeley SY13 4JA Whitchurch Shropshire | British | 95437530001 | ||||||
| EVANS, David Nigel | Geschäftsführer | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | British | 134975040001 | |||||
| EVANS, Mark | Geschäftsführer | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | British | 127017870001 | ||||||
| FINCH, Joanne Sarah | Geschäftsführer | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | British | 158146620001 | |||||
| HUMPHREYS, Christopher Andrew | Geschäftsführer | Bowden House Bowden Lane, Marple SK6 6ND Stockport Cheshire | British | 77737010001 | ||||||
| JACKSON, Stephen Paul | Geschäftsführer | 11 Pollard Drive Stapeley CW5 7EQ Nantwich Cheshire | British | 74412960001 | ||||||
| KEAYS, Helen Margaret | Geschäftsführer | The Old Vicarage Temple Grafton B49 6NX Alcester Warwickshire | United Kingdom | British | 81221470001 | |||||
| LANGSTON, Edward | Geschäftsführer | 23 Manilla Road Clifton BS8 4EB Bristol Avon | Uk | British | 24471140001 | |||||
| LEE, Simon Christopher | Geschäftsführer | Moorlands Harrow Road West RH4 3BH Dorking Surrey | United Kingdom | British | 86697870001 | |||||
| MCINTYRE, Diane Josephine, Cfo | Geschäftsführer | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | British | 173703620001 | |||||
| MORROW, William Thomas | Geschäftsführer | 5415 Blackhawk Drive Danville California 94506 Usa | American | 95677940001 | ||||||
| NOWAK, Thomas, Dr | Geschäftsführer | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | German | 174443800001 | |||||
| PHILLIPS, Thomas Adam | Geschäftsführer | The Old Stable House Sun Farm Fradswell ST18 0EY Stafford | United Kingdom | British | 55928770001 | |||||
| PURKESS, Martin John | Geschäftsführer | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | England | British | 139360020001 | |||||
| READ, Nicholas Jonathan | Geschäftsführer | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | British | 87149560001 | |||||
| SCHÄFER, Richard Wolfgang Henry | Geschäftsführer | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 158146600001 | |||||
| STEWART, Gregory Kenneth | Geschäftsführer | 1 The Grove CW6 0GB Tarporley Cheshire | British | 80561450001 | ||||||
| TOURNON, Emanuele | Geschäftsführer | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | Italian | 103542080002 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei SINGLEPOINT (4U) LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone Uk Limited | 06. Apr. 2016 | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat SINGLEPOINT (4U) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 03. Feb. 2003 Geliefert am 14. Feb. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge | Erstellt am 26. März 2002 Geliefert am 03. Apr. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All claims choses in action intellectual property and goodwill of the company present and future in so far as the same are comprised in the subscriber base arising under the service provider agreement and any other rights benefits or interests now and in the future comprised in the subscriber base. All book debts now and in the future owing to the company. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge | Erstellt am 03. Jan. 2002 Geliefert am 16. Jan. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first floating charge its undertaking and assets both present and future. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 22. Dez. 1997 Geliefert am 29. Dez. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 07. Dez. 1994 Geliefert am 15. Dez. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 19. Sept. 1994 Geliefert am 23. Sept. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge | Erstellt am 22. Juli 1993 Geliefert am 24. Juli 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under or in respect of the service provider agreements or either of them or any subsequent agreement (as defined) | |
Kurze Angaben The interest of the company in its customers from time to time concerning or inrelation to telecommunications services provided in whole or part on the vodafone network and all goodwill associated therewith (the subscriber base), first fixed charge all goodwill and uncalled capital intellectual property rights all book debts and other debts and first floating charge charge the remainder of the subscriber base. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0