SINGLEPOINT (4U) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSINGLEPOINT (4U) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02795597
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von SINGLEPOINT (4U) LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich SINGLEPOINT (4U) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von SINGLEPOINT (4U) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    4U LIMITED03. Okt. 199403. Okt. 1994
    CAUDWELL AIRTIME SERVICES LIMITED28. Mai 199328. Mai 1993
    HAJCO 117 LIMITED03. März 199303. März 1993

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SINGLEPOINT (4U) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2019

    Welche sind die letzten Einreichungen für SINGLEPOINT (4U) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    1 SeitenDS01

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 15. März 2021

    • Kapital: GBP 1
    3 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Ernennung von Mrs Janine Butler als Direktor am 23. Feb. 2021

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von David Nigel Evans als Geschäftsführer am 23. Feb. 2021

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 14. Feb. 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Erfüllung der Belastung 6 vollständig

    2 SeitenMR04

    Bestätigungserklärung erstellt am 14. Feb. 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. März 2019

    10 SeitenAA

    legacy

    256 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    2 SeitenAGREEMENT2

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE2

    Ernennung von Mr Andrew Michael Yorston als Direktor am 02. Apr. 2019

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Diane Josephine Mcintyre als Geschäftsführer am 16. März 2019

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 14. Feb. 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2018

    5 SeitenAA

    Erfüllung der Belastung 5 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 1 vollständig

    2 SeitenMR04

    Bestätigungserklärung erstellt am 14. Feb. 2018 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2017

    5 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 14. Feb. 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Wer sind die Geschäftsführer von SINGLEPOINT (4U) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    VODAFONE CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Sekretär
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    75473330004
    BUTLER, Janine
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    EnglandBritish277534960001
    YORSTON, Andrew Michael
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish257275320001
    BENNETT, Craig
    14 Conway Road
    Knypersley
    ST8 7AL Stoke On Trent
    Staffordshire
    Sekretär
    14 Conway Road
    Knypersley
    ST8 7AL Stoke On Trent
    Staffordshire
    British34704080001
    HOWIE, Philip Robert Sutherland
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Sekretär
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British77939460004
    HAJCO SECRETARIES LIMITED
    Berkeley Court
    Borough Road
    ST5 1TT Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Bevollmächtigter Sekretär
    Berkeley Court
    Borough Road
    ST5 1TT Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    900006890001
    ALLEN, Christian Philip Quentin
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British123612980001
    BARTON, John Michael
    30 Deerings Drive
    HA5 2NZ Pinner
    Middlesex
    Geschäftsführer
    30 Deerings Drive
    HA5 2NZ Pinner
    Middlesex
    British34831450001
    BENNETT, Craig
    14 Conway Road
    Knypersley
    ST8 7AL Stoke On Trent
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    14 Conway Road
    Knypersley
    ST8 7AL Stoke On Trent
    Staffordshire
    British34704080001
    BIRNEY, James Gary
    Three Acre Wood
    Bridgemere Lane
    CW5 7PL Nantwich
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Three Acre Wood
    Bridgemere Lane
    CW5 7PL Nantwich
    Cheshire
    British86869670001
    BROCKLEHURST, Nigel
    1 The Hollyhocks
    Reading Road, Harwell
    OX11 0LX Didcot
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    1 The Hollyhocks
    Reading Road, Harwell
    OX11 0LX Didcot
    Oxfordshire
    British83126790001
    BROWN, Peter
    Hawthorne Cottage
    19 Station Road Barlaston
    ST12 9DH Stoke-On-Trent
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Hawthorne Cottage
    19 Station Road Barlaston
    ST12 9DH Stoke-On-Trent
    Staffordshire
    British58317370001
    CAUDWELL, Brian
    Fradswell Hall Fradswell
    ST18 0EX Stafford
    Staffordshire
    England
    Geschäftsführer
    Fradswell Hall Fradswell
    ST18 0EX Stafford
    Staffordshire
    England
    British15920410002
    CAUDWELL, John David
    Broughton Hall
    Broughton
    ST21 6NS Eccleshall
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Broughton Hall
    Broughton
    ST21 6NS Eccleshall
    Staffordshire
    EnglandBritish21185880002
    CHESWORTH, Paul
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British99525280001
    DARBY, Gavin John
    Rodona House
    Rodona Road St Georges Hill
    KT13 0NP Weybridge
    Surrey
    Geschäftsführer
    Rodona House
    Rodona Road St Georges Hill
    KT13 0NP Weybridge
    Surrey
    EnglandBritish99277850001
    DAVIES, Andrew Mark
    19 Burnside
    WA15 0SG Halebarns
    Cheshire
    Geschäftsführer
    19 Burnside
    WA15 0SG Halebarns
    Cheshire
    British86869710001
    DOBSON, Philip
    The Holtridge
    Norbury Nr Cholmondeley
    SY13 4JA Whitchurch
    Shropshire
    Geschäftsführer
    The Holtridge
    Norbury Nr Cholmondeley
    SY13 4JA Whitchurch
    Shropshire
    British95437530001
    EVANS, David Nigel
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish134975040001
    EVANS, Mark
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British127017870001
    FINCH, Joanne Sarah
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish158146620001
    HUMPHREYS, Christopher Andrew
    Bowden House
    Bowden Lane, Marple
    SK6 6ND Stockport
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Bowden House
    Bowden Lane, Marple
    SK6 6ND Stockport
    Cheshire
    British77737010001
    JACKSON, Stephen Paul
    11 Pollard Drive
    Stapeley
    CW5 7EQ Nantwich
    Cheshire
    Geschäftsführer
    11 Pollard Drive
    Stapeley
    CW5 7EQ Nantwich
    Cheshire
    British74412960001
    KEAYS, Helen Margaret
    The Old Vicarage
    Temple Grafton
    B49 6NX Alcester
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    The Old Vicarage
    Temple Grafton
    B49 6NX Alcester
    Warwickshire
    United KingdomBritish81221470001
    LANGSTON, Edward
    23 Manilla Road
    Clifton
    BS8 4EB Bristol
    Avon
    Geschäftsführer
    23 Manilla Road
    Clifton
    BS8 4EB Bristol
    Avon
    UkBritish24471140001
    LEE, Simon Christopher
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    Geschäftsführer
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    United KingdomBritish86697870001
    MCINTYRE, Diane Josephine, Cfo
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish173703620001
    MORROW, William Thomas
    5415 Blackhawk Drive
    Danville
    California 94506
    Usa
    Geschäftsführer
    5415 Blackhawk Drive
    Danville
    California 94506
    Usa
    American95677940001
    NOWAK, Thomas, Dr
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomGerman174443800001
    PHILLIPS, Thomas Adam
    The Old Stable House Sun Farm
    Fradswell
    ST18 0EY Stafford
    Geschäftsführer
    The Old Stable House Sun Farm
    Fradswell
    ST18 0EY Stafford
    United KingdomBritish55928770001
    PURKESS, Martin John
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    EnglandBritish139360020001
    READ, Nicholas Jonathan
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish87149560001
    SCHÄFER, Richard Wolfgang Henry
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish158146600001
    STEWART, Gregory Kenneth
    1 The Grove
    CW6 0GB Tarporley
    Cheshire
    Geschäftsführer
    1 The Grove
    CW6 0GB Tarporley
    Cheshire
    British80561450001
    TOURNON, Emanuele
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomItalian103542080002

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei SINGLEPOINT (4U) LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageUnited Kingdom (England)
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer2227940
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat SINGLEPOINT (4U) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 03. Feb. 2003
    Geliefert am 14. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. März 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge
    Erstellt am 26. März 2002
    Geliefert am 03. Apr. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All claims choses in action intellectual property and goodwill of the company present and future in so far as the same are comprised in the subscriber base arising under the service provider agreement and any other rights benefits or interests now and in the future comprised in the subscriber base. All book debts now and in the future owing to the company. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bt Cellnet
    Transaktionen
    • 03. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Juli 2020Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of charge
    Erstellt am 03. Jan. 2002
    Geliefert am 16. Jan. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first floating charge its undertaking and assets both present and future.
    Berechtigte Personen
    • Vodafone Limited
    Transaktionen
    • 16. Jan. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Dez. 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 22. Dez. 1997
    Geliefert am 29. Dez. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Dez. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Dez. 2005Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 22. März 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 07. Dez. 1994
    Geliefert am 15. Dez. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Dez. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Dez. 2005Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 22. März 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 19. Sept. 1994
    Geliefert am 23. Sept. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Sept. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. März 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge
    Erstellt am 22. Juli 1993
    Geliefert am 24. Juli 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in respect of the service provider agreements or either of them or any subsequent agreement (as defined)
    Kurze Angaben
    The interest of the company in its customers from time to time concerning or inrelation to telecommunications services provided in whole or part on the vodafone network and all goodwill associated therewith (the subscriber base), first fixed charge all goodwill and uncalled capital intellectual property rights all book debts and other debts and first floating charge charge the remainder of the subscriber base. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Vodafone Limited
    Transaktionen
    • 24. Juli 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Dez. 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0