BRUNEL MOTOR COMPANY LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | BRUNEL MOTOR COMPANY LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02796252 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BRUNEL MOTOR COMPANY LIMITED?
- (5010) /
- (5020) /
- (5030) /
Wo befindet sich BRUNEL MOTOR COMPANY LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 12 Wilberforce Road CB3 0EQ Cambridge |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BRUNEL MOTOR COMPANY LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | |
Welche sind die letzten Einreichungen für BRUNEL MOTOR COMPANY LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Baker Tilly 6th Floor 25 Farringdon Street London EC4A 4AB zum 12 Wilberforce Road Cambridge CB3 0EQ am 02. Feb. 2017 | 2 Seiten | AD01 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 31. Aug. 2016 | 2 Seiten | 3.6 | ||
Mitteilung über die Beendigung der Tätigkeit als Receiver oder Manager | 8 Seiten | RM02 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 03. Juli 2015 | 2 Seiten | 3.6 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 04. Dez. 2015 | 1 Seiten | 3.6 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 04. Dez. 2015 | 1 Seiten | 3.6 | ||
Mitteilung über die Beendigung der Tätigkeit als Receiver oder Manager | 4 Seiten | RM02 | ||
Mitteilung über die Beendigung der Tätigkeit als Receiver oder Manager | 4 Seiten | RM02 | ||
Mitteilung über die Beendigung der Tätigkeit als Receiver oder Manager | 4 Seiten | RM02 | ||
Mitteilung über die Beendigung der Tätigkeit als Receiver oder Manager | 4 Seiten | RM02 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 02. Okt. 2015 | 3 Seiten | 3.6 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 13. Okt. 2015 | 1 Seiten | 3.6 | ||
Mitteilung über die Beendigung der Tätigkeit als Receiver oder Manager | 4 Seiten | RM02 | ||
Mitteilung über die Beendigung der Tätigkeit als Receiver oder Manager | 4 Seiten | RM02 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 03. Juli 2015 | 2 Seiten | 3.6 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 09. Apr. 2015 | 2 Seiten | 3.6 | ||
Mitteilung über die Beendigung der Tätigkeit als Receiver oder Manager | 4 Seiten | RM02 | ||
Mitteilung über die Beendigung der Tätigkeit als Receiver oder Manager | 4 Seiten | RM02 | ||
Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Receivers bis 13. Okt. 2014 | 1 Seiten | 3.6 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von BRUNEL MOTOR COMPANY LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRIGGS, John Philip | Sekretär | South Cottage Church Lane, Debden CB11 3LD Saffron Walden | British | 37238960003 | ||||||
| BRIGGS, John Philip | Geschäftsführer | South Cottage Church Lane, Debden CB11 3LD Saffron Walden | British | 37238960003 | ||||||
| PATEL, Amrat Ravlabhai | Geschäftsführer | 22 Tewkesbury Road Longford GL2 9DT Gloucester | England | British | 27005280002 | |||||
| PENNEY, Robert | Geschäftsführer | 12 The Hamlet Nailsea BS19 1BY Bristol Avon | British | 27005270001 | ||||||
| COLLETT, Brian | Sekretär | 10 Norwich Street EC4A 1BD London | British | 32267100001 | ||||||
| CORNISH, Garry | Sekretär | 36 Heron Gardens Portishead BS20 9DH Bristol Avon | British | 36668280001 | ||||||
| FRASER, Craig | Sekretär | 31 Watermill Road Feering CO5 9SR Colchester Essex | British | 8987400001 | ||||||
| HOLMES, Christopher John | Sekretär | Flat F Trinity Court Bradford Road BA14 9AL Trowbridge Wiltshire | British | 30751680001 | ||||||
| LETTING, Raymond | Sekretär | 17 Orchard Way Flitwick MK45 1LF Bedford | British | 65375530001 | ||||||
| PATEL, Amrat Ravlabhai | Sekretär | 85 Elmbridge Road Longlevens GL2 0PG Gloucester Gloucestershire | British | 27005280001 | ||||||
| BRIGGS, John Philip | Geschäftsführer | Hollybush The Street Bradwell Village CM7 8EL Braintree Essex | British | 37238960001 | ||||||
| CROSS, William Thomas | Geschäftsführer | 200 Stock Road CM12 0SH Billericay Essex | British | 37532620001 | ||||||
| FRASER, Craig | Geschäftsführer | 31 Watermill Road Feering CO5 9SR Colchester Essex | British | 8987400001 | ||||||
| PEARCE, Daniel John | Geschäftsführer | 32 Meadowbank Road PO15 5LD Fareham Hampshire | British | 15999810001 |
Hat BRUNEL MOTOR COMPANY LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 08. Sept. 2000 Geliefert am 19. Sept. 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 05. Jan. 1999 Geliefert am 12. Jan. 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Brunel ford 175-185 muller road bristol t/n BL51374 and AV56575. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 05. Jan. 1999 Geliefert am 13. Jan. 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Brunel ford ashley hill body shop bristol t/n AV206852 and AV59119 together with land to the north west of morris road ashley hill. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 24. Jan. 1997 Geliefert am 07. Feb. 1997 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 24. Jan. 1997 Geliefert am 07. Feb. 1997 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H land k/a as land and buildings lying to the north west of morris road ashley hill bristol avon t/no av 59119 and the proceeds of sale thereof and by way of A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 24. Jan. 1997 Geliefert am 07. Feb. 1997 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land & buildings k/a land & buildings lying to the west of morris road bristol avon t/no av 206852 and the proceeds of sale thereof and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 24. Jan. 1997 Geliefert am 07. Feb. 1997 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land at winterstoke road weston super mare woodspring avon t/no AV206496 and the proceeds of sale thereof and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 24. Jan. 1997 Geliefert am 07. Feb. 1997 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H k/a midway garage muller road horfield bristol t/no bl 51374 and the proceeds of sale thereof and by way of. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 08. Aug. 1996 Geliefert am 19. Aug. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land and buildings lying to the north west of morris road ashley hill bristol t/no. AV59119. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 11. Juli 1996 Geliefert am 23. Juli 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 07. Mai 1996 Geliefert am 23. Mai 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 175/185 (odd nos only) huller road bristol city of bristol. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 07. Mai 1996 Geliefert am 14. Mai 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land adjoining 175 - 185 (odd) muller road bristol avon t/n av 56575. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 07. Mai 1996 Geliefert am 14. Mai 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land and buildings lying to the west side of morris road bristol avon t/n av 206852. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A bulk deposit mortgage | Erstellt am 30. März 1993 Geliefert am 31. März 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All monies deposited by the company with ford credit PLC pursuant to the terms of a sale or return agreement dated 30.03.93. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. März 1993 Geliefert am 31. März 1993 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben And book debts. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| ||||
| Charge | Erstellt am 30. März 1993 Geliefert am 31. März 1993 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All new and used motor vehicles and all proceeds of sale. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat BRUNEL MOTOR COMPANY LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Administrativer Receiver bestellt |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
| Administrativer Receiver bestellt |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
| Receiver/Manager bestellt |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Administrativer Receiver bestellt |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0