VM TRANSFERS (NO 5) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameVM TRANSFERS (NO 5) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02798236
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von VM TRANSFERS (NO 5) LIMITED?

    • Tätigkeit anderer Holdinggesellschaften n.n.a. (64209) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

    Wo befindet sich VM TRANSFERS (NO 5) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Media House
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Hampshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von VM TRANSFERS (NO 5) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    GENERAL CABLE HOLDINGS LIMITED23. Aug. 199623. Aug. 1996
    STI (YORKSHIRE CABLE) LIMITED11. Aug. 199311. Aug. 1993
    ALNERY NO.1279 LIMITED10. März 199310. März 1993

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von VM TRANSFERS (NO 5) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2017

    Welche sind die letzten Einreichungen für VM TRANSFERS (NO 5) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 10. März 2019 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2017

    19 SeitenAA

    legacy

    82 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    1 SeitenAGREEMENT2

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE2

    Bestätigungserklärung erstellt am 10. März 2018 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Kapitalaufstellung am 14. Dez. 2017

    • Kapital: GBP 1.00
    3 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenSH20

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    17 SeitenAA

    legacy

    80 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    1 SeitenAGREEMENT2

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE2

    Bestätigungserklärung erstellt am 10. März 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2015

    16 SeitenAA

    legacy

    85 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    1 SeitenAGREEMENT2

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed general cable holdings LIMITED\certificate issued on 11/08/16
    3 SeitenCERTNM
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name11. Aug. 2016

    Namensänderung durch Beschluss

    NM01
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 10. Aug. 2016

    RES15

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE2

    Jahresrückblick erstellt bis 10. März 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital11. März 2016

    Kapitalaufstellung am 11. März 2016

    • Kapital: GBP 100
    • Kapital: USD 77,483,353
    SH01

    Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    16 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von VM TRANSFERS (NO 5) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    JAMES, Gillian Elizabeth
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    Sekretär
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    151202800001
    DUNN, Robert Dominic
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    EnglandBritish179134020002
    HIFZI, Mine Ozkan
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    EnglandBritish182167230001
    BURNS, Clive
    The Cottage
    Lamer Hill Gate Lower Gustard Wood
    AL4 8RX Wheathampstead
    Hertfordshire
    Sekretär
    The Cottage
    Lamer Hill Gate Lower Gustard Wood
    AL4 8RX Wheathampstead
    Hertfordshire
    British71073800001
    CHAN, Su Shan
    11 Peck Hay Road 12-00
    0922 Singapore
    Singaporean
    Sekretär
    11 Peck Hay Road 12-00
    0922 Singapore
    Singaporean
    British44813130001
    LAVER, John Michael
    Brook House Homestead Road
    TN8 6JD Edenbridge
    Kent
    Sekretär
    Brook House Homestead Road
    TN8 6JD Edenbridge
    Kent
    British8207040001
    LIM, Mei Yi
    15 Jalan Senandong
    1128 Swiss Club Park
    Singapore
    Sekretär
    15 Jalan Senandong
    1128 Swiss Club Park
    Singapore
    Singaporean35806800001
    ALNERY INCORPORATIONS NO 1 LIMITED
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    Bevollmächtigter Sekretär
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    900002920001
    VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Sekretär
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107380002
    BURDICK, Charles James
    9 Ormonde Place
    SW1W 8HX London
    Geschäftsführer
    9 Ormonde Place
    SW1W 8HX London
    British-American52311710004
    CHARNOCK, Christopher Gerard
    6 Coverdale Close
    Whittle Hall
    WA5 3DH Warrington
    Cheshire
    Geschäftsführer
    6 Coverdale Close
    Whittle Hall
    WA5 3DH Warrington
    Cheshire
    EnglandBritish50246180001
    CHIA, Choon Wei, Doctor
    32 Adis Road
    01-41 Sophia Court
    Singapore 0922
    Geschäftsführer
    32 Adis Road
    01-41 Sophia Court
    Singapore 0922
    Singaporean35806810001
    COOK, Stephen Sands
    24a Redcliffe Square
    SW10 9JY London
    Geschäftsführer
    24a Redcliffe Square
    SW10 9JY London
    British73000530008
    COSGROVE, Charles Henry
    52 Oxley Road
    Valley Mansion
    0923 Singapore
    Geschäftsführer
    52 Oxley Road
    Valley Mansion
    0923 Singapore
    American36156420001
    GALE, Robert Charles
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    EnglandBritish96956740001
    GALTEAU, Philippe Xavier
    10 Rue De La Cure
    75016 Paris
    France
    Geschäftsführer
    10 Rue De La Cure
    75016 Paris
    France
    French34577670001
    GRAY, Ian
    61 Bathurst Mews
    W2 2SB London
    Geschäftsführer
    61 Bathurst Mews
    W2 2SB London
    United KingdomBritish50246030004
    HO, Alan Boon Teck
    1 Moorlands
    Westwood Drive
    LS29 9QZ Ilkley
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    1 Moorlands
    Westwood Drive
    LS29 9QZ Ilkley
    West Yorkshire
    British38041190001
    HULL, Victoria Mary, Sol
    Flat 2
    53 Palace Gardens Terrace Kensington
    W8 4SB London
    Geschäftsführer
    Flat 2
    53 Palace Gardens Terrace Kensington
    W8 4SB London
    British77283810001
    ILLSLEY, Anthony Kim
    4 St Peters Road
    TW1 1QX Twickenham
    Middlesex
    Geschäftsführer
    4 St Peters Road
    TW1 1QX Twickenham
    Middlesex
    United KingdomBritish43836970001
    LEW, Allen Yoong Keong
    52 Nallur Road
    Singapore
    1545
    Geschäftsführer
    52 Nallur Road
    Singapore
    1545
    Singaporean44257660001
    LEW, Allen Yoong Keong
    52 Nallur Road
    Singapore
    1545
    Geschäftsführer
    52 Nallur Road
    Singapore
    1545
    Singaporean44257660001
    MACKENZIE, Robert Mario
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    United KingdomBritish47785600002
    MILLER, David John
    1 Asmara Road
    NW2 3SS London
    Geschäftsführer
    1 Asmara Road
    NW2 3SS London
    United KingdomBritish152304230002
    MOODY, David
    108a Regents Park Road
    NW1 8UG London
    Geschäftsführer
    108a Regents Park Road
    NW1 8UG London
    British47598900001
    NEARY, Christopher John
    4 Effingham Place
    KT24 5JT Effingham
    Surrey
    Geschäftsführer
    4 Effingham Place
    KT24 5JT Effingham
    Surrey
    British47022960003
    ROWSON, Richard James Christopher
    145 St Annes Hill
    SW18 2RX London
    Geschäftsführer
    145 St Annes Hill
    SW18 2RX London
    British58236390001
    SEXTON, Ian Tony
    Wellingtons Cottage 2 Ladds Lane
    Maxey
    PE6 9HD Peterborough
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    Wellingtons Cottage 2 Ladds Lane
    Maxey
    PE6 9HD Peterborough
    Cambridgeshire
    British74079950001
    SMITH, Neil Reynolds
    Brettwood
    Green Lane Churt
    GU10 2PA Farnham
    Surrey
    Geschäftsführer
    Brettwood
    Green Lane Churt
    GU10 2PA Farnham
    Surrey
    British79956240002
    STENHAM, Anthony William Paul
    4 The Grove
    Highgate
    N6 6JU London
    Geschäftsführer
    4 The Grove
    Highgate
    N6 6JU London
    British8281170001
    SUNG, Sio Ma
    17 Phillips Avenue
    FOREIGN Singapore 1954
    Singapore
    Geschäftsführer
    17 Phillips Avenue
    FOREIGN Singapore 1954
    Singapore
    Singaporean84957060001
    TILLBROOK, Joanne Christine
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United KingdomBritish164134250001
    TILLBROOK, Joanne Christine
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United KingdomBritish164134250001
    TILLBROOK, Joanne Christine
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United KingdomBritish164134250001
    VAN VALKENBURG, David Raynor
    Flat 6
    35/37 Grosvenor Square
    W1X 9AE London
    Geschäftsführer
    Flat 6
    35/37 Grosvenor Square
    W1X 9AE London
    American53941940001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei VM TRANSFERS (NO 5) LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandEngland And Wales
    RechtsgrundlageUnited Kingdom (England And Wales)
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer3291383
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat VM TRANSFERS (NO 5) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Composite debenture
    Erstellt am 29. Juni 2010
    Geliefert am 08. Juli 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee, all monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and all monies due or to become due from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 08. Juli 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 12. Okt. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Confirmation deed
    Erstellt am 15. Apr. 2010
    Geliefert am 29. Apr. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) on any account whatosover under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The chargor acknowledges and agrees to the new sfa and the transactions contemplated thereby and confirm all payment and performance obligations contingent or otherwise and undertakings arising under or in connection with its respective agreements, guarantees, pledges and grants of encumbrances under and subject to the terms of the group intercreditor agreement and each security document to which it is party. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 29. Apr. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 12. Okt. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    A composite debenture
    Erstellt am 19. Jan. 2010
    Geliefert am 22. Jan. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag London Branch (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 22. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 12. Okt. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Composite debenture
    Erstellt am 19. Jan. 2010
    Geliefert am 22. Jan. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag London Branch (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 22. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 28. Mai 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Composite debenture
    Erstellt am 03. März 2006
    Geliefert am 10. März 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee, from the obligors (or any one or more of them) to the finance parties (or any one or more of them) on any account whatsoever, from all or any of the obligors to the restructuring swap counterparties and/or the existing hedge counter parties and to the new hedge counterparties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch (As Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 10. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Mai 2010Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 24. Mai 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Composite debenture
    Erstellt am 21. Dez. 2004
    Geliefert am 23. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (As Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 23. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    New composite guarantee and debenture
    Erstellt am 14. Juli 2004
    Geliefert am 28. Juli 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    A first equitable charge over the stocks, shares and any other interests of the company in front row television LTD, any tcn entity or any joint venture. A first floating charge over all other present and future assets of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cibc World Markets PLC in Its Capacity as New Security Trustee for the New Beneficiaries
    Transaktionen
    • 28. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Aug. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    New composite guarantee and debenture
    Erstellt am 14. Juli 2004
    Geliefert am 22. Juli 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    A first equitable charge over the stocks, shares and any other interests of tcn in front row television LTD, any tcn entity or any joint venture. A first floating charge over all other present and future assets of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cibc World Markets PLC in Its Capacity as New Security Trustee for the New Beneficiaries
    Transaktionen
    • 22. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Aug. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Guarantee and debenture made between (1) telewest communications networks limited, (2) the original charging subsidiaries, (3) the original charging partnerships and (4) telewest finance corporation (the "us "borrower") 5). cibc world markets PLC in its capacity as security trustee issued by the company.
    Erstellt am 16. März 2001
    Geliefert am 23. März 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    A).all amounts payable to cibc world markets PLC as security trustee to the extent only of the amount payable to the security trustee (for its own account) pursuant to the agreement or any of the security trustee security documents in relation to the period up to and including its retirement as security trustee pursuant to the provisions of the intercreditor deed and all amounts payable to any other person who may be appointed as security trustee pursuant to the provisions of the intercreditor deed to the extent only of the amounts payable to the security trustee (for its own account) pursuant to the agreement or any of the security trustee security documents in relation to the period up to and including its retirement as security trustee pursuant to the provisions of the intercreditor deed; (b) all indebtedness covenanted to be paid or discharged by all or any of the chargors to all or any of the finance parties under the senior documents; (c) all indebtedness covenanted to be paid or discharged by all or any of the chargors to the hedge counterparties under the hedging arrangements; (d) all indebtedness of the lessees to the lessors (or any of them) under the lease documents; and (e) all financial obligations due to crosby under the crosby documents
    Kurze Angaben
    I). all the company's present and future rights, title, benefit and interest in and under the loan stock (as defined) from time to time ii). All rights title benefit and interest in and to amounts payable to the company arising under the bbc jv management services agreement, and the UK gold jv management services agreement iii). All rights title benefit and interest in and to amounts payable to the company under the bbc jv agreement, the UK gold jv agreement and any other subscription and shareholder agreement entered into in relation to a joint venture, including (but not limited to) all amounts payable under clauses 19 and 20 of the bbc jv agreement and clauses 19 and 20 of the UK gold jv agreement and iv). All the company's present and future rights title benefit and interest in and under the intercompany loan agreement together with first floating charge all the company's undertaking property and assets not charged by way of fixed charge .. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cibc World Markets PLC (In Its Capacity as Security Trustee)
    Transaktionen
    • 23. März 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Aug. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Guarantee and debenture made between (1) telewest communications networks limited, (2) the original charging subsidiaries, (3) the original charging partnerships and (4) cibc world markets PLC in its capacity as security trustee issued by the company
    Erstellt am 20. Mai 1999
    Geliefert am 03. Juni 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    (A) all amounts payable to cibc world markets PLC as security trustee to the extent only of the amount payable to the security trustee (for its own account) pursuant to the agreement or any of the security trustee security documents in relation to the period up to and including its retirement as security trustee pursuant to the provisions of the intercreditor deed and all amounts payable to any other person who may be appointed as security trustee pursuant to the provisions of the intercreditor deed to the extent only of the amounts payable to the security trustee (for its own account) pursuant to the agreement or any of the security trustee security documents in relation to the period up to and including its retirement as security trustee pursuant to the provisions of the intercreditor deed; (b) all indebtedness covenanted to be paid or discharged by all or any of the chargors to all or any of the finance parties under the senior documents; (c) all indebtedness covenanted to be paid or discharged by all or any of the chargors to the hedge counterparties under the hedging arrangements; (d) all indebtedness of the lessees to the lessors (or any of them) under the lease documents; and (e) all financial obligations due to crosby under the crosby documents
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge (I) without prejudice to clause 3.1(b) of the debenture all the company's right, title and interest in and to all claims to which the company is at the date of the debenture or may thereafter become entitled under and in relation to each of the lease documents to which it is a party.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cibc World Markets PLC (In Its Capacity as Security Trustee)
    Transaktionen
    • 03. Juni 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Dez. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 31. Dez. 1997
    Geliefert am 20. Jan. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Each and every liability which the company may on or after 31ST december 1997 have to the chargee (whether solely or jointly with one or more persons and whether as principal or as surety) under or pursuant to the operative documents (including the debenture) and pay to the chargee when due and payable every sum (of principal interest or otherwise) on or after 31ST december 1997 owing due or incurred by the company to the chargee in respect of any such liabilities (the secured obligations)
    Kurze Angaben
    By way of fixed charge the real property being all estates and other interests in freehold leasehold and other immovable property and all buildings trade and other fixtures, the tangible movable property being all headend equipment all switch equipment all wire cable computer software, all goodwill and rights by way of first floating charge the whole of the undertaking and assets (for full details please refer to form 395 and continuation sheets). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Robert Fleming Leasing (Number 4) Limited
    Transaktionen
    • 20. Jan. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Juni 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 31. Dez. 1997
    Geliefert am 20. Jan. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Each and every liability which the company may on or after 31ST december 1997 have to the chargee (whether solely or jointly with one or more persons and whether as principal or as surety) under or pursuant to the operative documents (including the debenture) and pay to the chargee when due and payable every sum (of principal interest or otherwise) on or after 31ST december 1997 owing due or incurred by the company to the chargee in respect of any such liabilities (the secured obligations)
    Kurze Angaben
    By way of fixed charge the real property being all estates and other interests in freehold leasehold and other immovable property and all buildings trade and other fixtures, the tangible movable property being all headend equipment all switch equipment all wire cable computer software, all goodwill and rights by way of first floating charge the whole of the undertaking and assets (for full details please refer to form 395 and continuation sheets). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lombard Commercial Limited
    Transaktionen
    • 20. Jan. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Juni 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 31. Dez. 1997
    Geliefert am 20. Jan. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Each and every liability which the company may on or after 31ST december 1997 have to the chargee (whether solely or jointly with one or more persons and whether as principal or as surety) under or pursuant to the operative documents (including the debenture) and pay to the chargee when due and payable every sum (of principal interest or otherwise) on or after 31ST december 1997 owing due or incurred by the company to the chargee in respect of any such liabilities (the secured obligations)
    Kurze Angaben
    By way of fixed charge the real property being all estates and other interests in freehold leasehold and other immovable property and all buildings trade and other fixtures, the tangible movable property being all headend equipment all switch equipment all wire cable computer software, all goodwill and rights by way of first floating charge the whole of the undertaking and assets (for full details please refer to form 395 and continuation sheets). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Natwest Specialist Finance Limited
    Transaktionen
    • 20. Jan. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Juni 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 31. Dez. 1997
    Geliefert am 20. Jan. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    Each and every liability which the company may on or after 31ST december 1997 have to the chargee (whether solely or jointly with one or more persons and whether as principal or as surety) under or pursuant to the operative documents (including the debenture) and pay to the chargee when due and payable every sum (of principal interest or otherwise) on or after 31ST december 1997 owing due or incurred by the company to the chargee in respect of any such liabilities (the secured obligations)
    Kurze Angaben
    By way of fixed charge the real property being all estates and other interests in freehold leasehold and other immovable property and all buildings trade and other fixtures, the tangible movable property being all headend equipment all switch equipment all wire cable computer software, all goodwill and rights by way of first floating charge the whole of the undertaking and assets (for full details please refer to form 395 and continuation sheets). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Natwest Specialist Finance Limited
    Transaktionen
    • 20. Jan. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Juni 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 31. Dez. 1997
    Geliefert am 15. Jan. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as security trustee for the beneficiaries) on any account whatsoever under or pursuant to the finance documents (including the debenture)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over all undertaking property and assets present and future including goodwill intellectual property benefit of licences all earnings all debts shares and uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Jan. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Juni 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge of shares
    Erstellt am 25. Juli 1997
    Geliefert am 12. Aug. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from the company and/or general cable PLC to the chargee under or pursuant to the option agreement and/or any security document (both as defined)
    Kurze Angaben
    Charges the shares to the chargee by way of fixed charge;and charges and agrees to the chargee by way of fixed charge all present and future rights,moneys,benefits and other property which may at any time accrue or be offered or arise by way of conversion,redemption,bonus,preference,option or otherwise in respect of any of the shares or in substitution or exchange for any of such shares. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Crosby Sterling Limited
    Transaktionen
    • 12. Aug. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Feb. 1998Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 01. Juni 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over shares in the yorkshire cable group limited between the company and national westminster bank PLC (the trustee)
    Erstellt am 25. Juli 1997
    Geliefert am 11. Aug. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All of the present and future actual and contingent obligations of the obligors (as defined) to the beneficiaries (as defined) under the facility documents (as defined)
    Kurze Angaben
    44,475,024 10P ordinary shares of the company in the yorkshire cable group limited and all present and future rights moneys benefits and other property which may at any time accrue. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Aug. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Jan. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0