BAXI UK LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBAXI UK LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02799058
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BAXI UK LIMITED?

    • Herstellung von Zentralheizungsradiatoren und -kesseln (25210) / Verarbeitendes Gewerbe

    Wo befindet sich BAXI UK LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Brooks House
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Warwickshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von BAXI UK LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    BAXI LIMITED30. Sept. 199930. Sept. 1999
    BAXI HEATING LIMITED17. März 199417. März 1994
    BAXI LIMITED27. Sept. 199327. Sept. 1993
    ALFER LIMITED08. März 199308. März 1993

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BAXI UK LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für BAXI UK LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    7 Seiten4.71

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 26. Sept. 2013

    6 Seiten4.68

    Erfüllung der Belastung 6 vollständig

    3 SeitenMR04

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    2 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 27. Sept. 2012

    LRESSP

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Zweite Einreichung von AR01, das zuvor beim Handelsregister eingereicht wurde, erstellt am 08. März 2012

    17 SeitenRP04

    Ernennung von Mr Jan-Feie Zwiers als Direktor am 31. Mai 2012

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Adrian Egerton Darling als Geschäftsführer am 31. Mai 2012

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von John Mcfaull als Geschäftsführer am 26. März 2012

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Robert Leslie Nash als Geschäftsführer am 26. März 2012

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Paul Thomas Moss als Direktor am 26. März 2012

    2 SeitenAP01

    Jahresrückblick erstellt bis 08. März 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital12. März 2012

    Kapitalaufstellung am 13. Aug. 2012

    • Kapital: GBP 45,000,002
    SH01
    Anmerkungen
    DatumAnmerkung
    13. Aug. 2012Clarification Second filed AR01 was registered on 13/08/2012.

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    1 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 08. März 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    8 SeitenMG01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    1 SeitenAA

    Änderung der Details des Sekretärs für Karen Roberts am 27. Sept. 2010

    2 SeitenCH03

    Änderung der Details des Direktors für John Mcfaull am 28. Sept. 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Robert Leslie Nash am 28. Sept. 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Adrian Egerton Darling am 28. Sept. 2010

    2 SeitenCH01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom , 16 Stanier Way, Wyvern Business Park, Derby, Derbyshire, DE21 6BF, England am 27. Sept. 2010

    1 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 08. März 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Wer sind die Geschäftsführer von BAXI UK LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ROBERTS, Karen Dawn
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    England
    Sekretär
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    England
    British126457090001
    MOSS, Paul Thomas
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    EnglandBritish167898270001
    ZWIERS, Jan-Feie
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    England
    Geschäftsführer
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    England
    NetherlandsDutch169623550001
    BOND, Sarah Caroline
    Hillside
    37 Rise End, Middleton
    DE4 4LS Wirksworth
    Derbyshire
    Sekretär
    Hillside
    37 Rise End, Middleton
    DE4 4LS Wirksworth
    Derbyshire
    British90181180006
    HARDMAN, Alan Philip
    156 Vicars Hall Lane
    Worsley
    M28 1HY Salford
    Manchester
    Sekretär
    156 Vicars Hall Lane
    Worsley
    M28 1HY Salford
    Manchester
    British54046590001
    KING, Laurence
    Conifers 6 Highgate Avenue
    Fulwood
    PR2 8LL Preston
    Lancashire
    Sekretär
    Conifers 6 Highgate Avenue
    Fulwood
    PR2 8LL Preston
    Lancashire
    British51624810001
    LOWE, Tracey
    149 Smalley Drive
    Oakwood
    DE21 2SQ Derby
    Derbyshire
    Sekretär
    149 Smalley Drive
    Oakwood
    DE21 2SQ Derby
    Derbyshire
    British86697030001
    PERKINS, Michael William
    38 Cubbington Road
    CV32 7AB Leamington Spa
    Warwickshire
    Sekretär
    38 Cubbington Road
    CV32 7AB Leamington Spa
    Warwickshire
    British30958650001
    ROTHWELL, Peter Jeffrey
    7 Riefield
    Harpers Lane
    BL1 6TA Bolton
    Lancashire
    Sekretär
    7 Riefield
    Harpers Lane
    BL1 6TA Bolton
    Lancashire
    British55070650001
    STRATTON, Malcolm
    Flat 40
    Manor Park Court, Uttoxeter New Road
    DE22 3NG Derby
    Derbyshire
    Sekretär
    Flat 40
    Manor Park Court, Uttoxeter New Road
    DE22 3NG Derby
    Derbyshire
    British30601260018
    A B & C SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Bevollmächtigter Sekretär
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    900006570001
    ACORNLEY, John Keith
    Rose Cottage
    Newton Road
    CV13 0QU Odstone
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Rose Cottage
    Newton Road
    CV13 0QU Odstone
    Warwickshire
    EnglandBritish151839430001
    BROOK, Nigel Charles
    Parkgate Leagram
    Chipping
    PR3 2GS Preston
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Parkgate Leagram
    Chipping
    PR3 2GS Preston
    Lancashire
    British69544700003
    CARTER, Simon Nicolas
    Bowland House Lancaster Road
    Out Rawcliffe
    PR3 6BL Preston
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Bowland House Lancaster Road
    Out Rawcliffe
    PR3 6BL Preston
    Lancashire
    British13368920001
    CARTER, Simon Nicolas
    Bowland House Lancaster Road
    Out Rawcliffe
    PR3 6BL Preston
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Bowland House Lancaster Road
    Out Rawcliffe
    PR3 6BL Preston
    Lancashire
    British13368920001
    DARLING, Adrian Egerton
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    England
    Geschäftsführer
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    England
    United KingdomBritish13813980005
    DAVIES, Michael Thomas
    Dadlington House Farm
    Shenton Lane
    CV13 6JD Dadlington
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Dadlington House Farm
    Shenton Lane
    CV13 6JD Dadlington
    Warwickshire
    British50770000002
    DRYDEN, Steven George
    8 Woodfall
    Astley Village
    PR7 1XD Chorley
    Lancashire
    Geschäftsführer
    8 Woodfall
    Astley Village
    PR7 1XD Chorley
    Lancashire
    British58338630001
    DUTFIELD, James
    48 Long Copse
    Astley Village
    PR7 1TH Chorley
    Lancs
    Geschäftsführer
    48 Long Copse
    Astley Village
    PR7 1TH Chorley
    Lancs
    British33255710001
    EDWARDS, Mark John
    The Glen
    35 Hazelwood Road
    DE56 4DP Duffield
    Derby
    Geschäftsführer
    The Glen
    35 Hazelwood Road
    DE56 4DP Duffield
    Derby
    United KingdomBritish56562210001
    GRAY, Bryan Mark
    The Firs 69 The Common
    Parbold
    WN8 7EA Wigan
    Lancashire
    Geschäftsführer
    The Firs 69 The Common
    Parbold
    WN8 7EA Wigan
    Lancashire
    United KingdomBritish34960210001
    GUERIN, John Michael
    64 Harlsey Road
    TS18 5DQ Stockton On Tees
    Cleveland
    Geschäftsführer
    64 Harlsey Road
    TS18 5DQ Stockton On Tees
    Cleveland
    British4978400001
    HANNAH, Alan Grant
    The Old Post Office 8 Newcastle Road
    South Brereton Green
    CW11 1RS Sandbach
    Cheshire
    Geschäftsführer
    The Old Post Office 8 Newcastle Road
    South Brereton Green
    CW11 1RS Sandbach
    Cheshire
    British72607060001
    JOHNSON, Peter Robert
    Field House
    Chelford Road
    SK11 9LF Siddington
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Field House
    Chelford Road
    SK11 9LF Siddington
    Cheshire
    British4025460002
    KING, Laurence
    Conifers 6 Highgate Avenue
    Fulwood
    PR2 8LL Preston
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Conifers 6 Highgate Avenue
    Fulwood
    PR2 8LL Preston
    Lancashire
    EnglandBritish51624810001
    LYON, James William
    94 Chapel Lane
    Longton
    PR4 5FB Preston
    Lancashire
    Geschäftsführer
    94 Chapel Lane
    Longton
    PR4 5FB Preston
    Lancashire
    United KingdomBritish116963940002
    MCFAULL, John
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    British83628430003
    MOSS, Paul Thomas
    Nook Farm House Humblescough Lane
    Nateby
    PR3 0LL Preston
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Nook Farm House Humblescough Lane
    Nateby
    PR3 0LL Preston
    Lancashire
    EnglandBritish167898270001
    NASH, Robert Leslie
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    United KingdomBritish83397580001
    SAXBY, George Arthur
    146 Banbury Road
    CV37 7HU Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    146 Banbury Road
    CV37 7HU Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    British30232680001
    STANTON, Edward
    21 Court Hey Avenue
    Ruby
    L36 4JB Liverpool
    Merseyside
    Geschäftsführer
    21 Court Hey Avenue
    Ruby
    L36 4JB Liverpool
    Merseyside
    United KingdomBritish115915420001
    STRATTON, Malcolm
    Flat 40
    Manor Park Court, Uttoxeter New Road
    DE22 3NG Derby
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Flat 40
    Manor Park Court, Uttoxeter New Road
    DE22 3NG Derby
    Derbyshire
    British30601260018
    A B & C SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    900006570001
    NEWMOND ADMINISTRATION LIMITED
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    57363930002
    NEWMOND MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    57363780002

    Hat BAXI UK LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    First fixed charge over the trade marks
    Erstellt am 27. Jan. 2011
    Geliefert am 02. Feb. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    First fixed charge all of the charged property see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent
    Transaktionen
    • 02. Feb. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 13. Apr. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A guarantee and debenture
    Erstellt am 12. März 2004
    Geliefert am 25. März 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each of the charging companies to any of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC, as Agent and Trustee (The Security Trustee) for the Securedparties
    Transaktionen
    • 25. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Feb. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Guarantee and debenture made between the company and the royal bank of scotland PLC as agent and trustee for the secured parties (as defined) pursuant to the intercreditor agreement (as defined)
    Erstellt am 28. Nov. 2000
    Geliefert am 12. Dez. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The actual contingent present and/or future obligations and liabilities of the company to any of the secured parties under or pursuant to all or any of the secured documents (as defined) including the guarantee and debenture
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 12. Dez. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. März 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Trade marks and patents charge made between the company and the royal bank of scotland PLC as agent and trustee for the secured parties (as defined)
    Erstellt am 28. Nov. 2000
    Geliefert am 12. Dez. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The actual contingent, present and/or future obligations and liabilities of the company to any of the secured parties under or pursuant to any of the secured documents (as defined) including the trade marks and patents charge
    Kurze Angaben
    A first fixed charge over the patents, the trade marks, the patent applications, the trade mark applications together with any goodwill of the company's business to which the patents, the trade marks, the patent applications and the trade mark applications. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 12. Dez. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. März 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 21. Jan. 2000
    Geliefert am 31. Jan. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The actual, contingent, present and/or future obligations and liabilities of the company or any group company to any of the secured parties under, or pursuant to, all or any of the financing documents
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Societe Generale, London Branch as Agent and Security Trustee for the Secured Parties
    Transaktionen
    • 31. Jan. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Juli 2000Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 23. Mai 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 03. Dez. 1999
    Geliefert am 21. Dez. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to any of the financing documents
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Societe Generale
    Transaktionen
    • 21. Dez. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Jan. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat BAXI UK LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    13. März 2014Aufgelöst am
    27. Sept. 2012Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Peter James Greaves
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praktiker
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Timothy Gerard Walsh
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Praktiker
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0