BAXI UK LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | BAXI UK LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02799058 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BAXI UK LIMITED?
- Herstellung von Zentralheizungsradiatoren und -kesseln (25210) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich BAXI UK LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Brooks House Coventry Road CV34 4LL Warwick Warwickshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von BAXI UK LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| BAXI LIMITED | 30. Sept. 1999 | 30. Sept. 1999 |
| BAXI HEATING LIMITED | 17. März 1994 | 17. März 1994 |
| BAXI LIMITED | 27. Sept. 1993 | 27. Sept. 1993 |
| ALFER LIMITED | 08. März 1993 | 08. März 1993 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BAXI UK LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für BAXI UK LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 7 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 26. Sept. 2013 | 6 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 3 Seiten | MR04 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 2 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Zweite Einreichung von AR01, das zuvor beim Handelsregister eingereicht wurde, erstellt am 08. März 2012 | 17 Seiten | RP04 | ||||||||||
Ernennung von Mr Jan-Feie Zwiers als Direktor am 31. Mai 2012 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Adrian Egerton Darling als Geschäftsführer am 31. Mai 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Mcfaull als Geschäftsführer am 26. März 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Robert Leslie Nash als Geschäftsführer am 26. März 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Paul Thomas Moss als Direktor am 26. März 2012 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. März 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. März 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 8 Seiten | MG01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Karen Roberts am 27. Sept. 2010 | 2 Seiten | CH03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für John Mcfaull am 28. Sept. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Robert Leslie Nash am 28. Sept. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Adrian Egerton Darling am 28. Sept. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom , 16 Stanier Way, Wyvern Business Park, Derby, Derbyshire, DE21 6BF, England am 27. Sept. 2010 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 08. März 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von BAXI UK LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBERTS, Karen Dawn | Sekretär | Coventry Road CV34 4LL Warwick Brooks House Warwickshire England | British | 126457090001 | ||||||
| MOSS, Paul Thomas | Geschäftsführer | Coventry Road CV34 4LL Warwick Brooks House Warwickshire | England | British | 167898270001 | |||||
| ZWIERS, Jan-Feie | Geschäftsführer | Coventry Road CV34 4LL Warwick Brooks House England | Netherlands | Dutch | 169623550001 | |||||
| BOND, Sarah Caroline | Sekretär | Hillside 37 Rise End, Middleton DE4 4LS Wirksworth Derbyshire | British | 90181180006 | ||||||
| HARDMAN, Alan Philip | Sekretär | 156 Vicars Hall Lane Worsley M28 1HY Salford Manchester | British | 54046590001 | ||||||
| KING, Laurence | Sekretär | Conifers 6 Highgate Avenue Fulwood PR2 8LL Preston Lancashire | British | 51624810001 | ||||||
| LOWE, Tracey | Sekretär | 149 Smalley Drive Oakwood DE21 2SQ Derby Derbyshire | British | 86697030001 | ||||||
| PERKINS, Michael William | Sekretär | 38 Cubbington Road CV32 7AB Leamington Spa Warwickshire | British | 30958650001 | ||||||
| ROTHWELL, Peter Jeffrey | Sekretär | 7 Riefield Harpers Lane BL1 6TA Bolton Lancashire | British | 55070650001 | ||||||
| STRATTON, Malcolm | Sekretär | Flat 40 Manor Park Court, Uttoxeter New Road DE22 3NG Derby Derbyshire | British | 30601260018 | ||||||
| A B & C SECRETARIAL LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 900006570001 | |||||||
| ACORNLEY, John Keith | Geschäftsführer | Rose Cottage Newton Road CV13 0QU Odstone Warwickshire | England | British | 151839430001 | |||||
| BROOK, Nigel Charles | Geschäftsführer | Parkgate Leagram Chipping PR3 2GS Preston Lancashire | British | 69544700003 | ||||||
| CARTER, Simon Nicolas | Geschäftsführer | Bowland House Lancaster Road Out Rawcliffe PR3 6BL Preston Lancashire | British | 13368920001 | ||||||
| CARTER, Simon Nicolas | Geschäftsführer | Bowland House Lancaster Road Out Rawcliffe PR3 6BL Preston Lancashire | British | 13368920001 | ||||||
| DARLING, Adrian Egerton | Geschäftsführer | Coventry Road CV34 4LL Warwick Brooks House Warwickshire England | United Kingdom | British | 13813980005 | |||||
| DAVIES, Michael Thomas | Geschäftsführer | Dadlington House Farm Shenton Lane CV13 6JD Dadlington Warwickshire | British | 50770000002 | ||||||
| DRYDEN, Steven George | Geschäftsführer | 8 Woodfall Astley Village PR7 1XD Chorley Lancashire | British | 58338630001 | ||||||
| DUTFIELD, James | Geschäftsführer | 48 Long Copse Astley Village PR7 1TH Chorley Lancs | British | 33255710001 | ||||||
| EDWARDS, Mark John | Geschäftsführer | The Glen 35 Hazelwood Road DE56 4DP Duffield Derby | United Kingdom | British | 56562210001 | |||||
| GRAY, Bryan Mark | Geschäftsführer | The Firs 69 The Common Parbold WN8 7EA Wigan Lancashire | United Kingdom | British | 34960210001 | |||||
| GUERIN, John Michael | Geschäftsführer | 64 Harlsey Road TS18 5DQ Stockton On Tees Cleveland | British | 4978400001 | ||||||
| HANNAH, Alan Grant | Geschäftsführer | The Old Post Office 8 Newcastle Road South Brereton Green CW11 1RS Sandbach Cheshire | British | 72607060001 | ||||||
| JOHNSON, Peter Robert | Geschäftsführer | Field House Chelford Road SK11 9LF Siddington Cheshire | British | 4025460002 | ||||||
| KING, Laurence | Geschäftsführer | Conifers 6 Highgate Avenue Fulwood PR2 8LL Preston Lancashire | England | British | 51624810001 | |||||
| LYON, James William | Geschäftsführer | 94 Chapel Lane Longton PR4 5FB Preston Lancashire | United Kingdom | British | 116963940002 | |||||
| MCFAULL, John | Geschäftsführer | Coventry Road CV34 4LL Warwick Brooks House Warwickshire | British | 83628430003 | ||||||
| MOSS, Paul Thomas | Geschäftsführer | Nook Farm House Humblescough Lane Nateby PR3 0LL Preston Lancashire | England | British | 167898270001 | |||||
| NASH, Robert Leslie | Geschäftsführer | Coventry Road CV34 4LL Warwick Brooks House Warwickshire | United Kingdom | British | 83397580001 | |||||
| SAXBY, George Arthur | Geschäftsführer | 146 Banbury Road CV37 7HU Stratford Upon Avon Warwickshire | British | 30232680001 | ||||||
| STANTON, Edward | Geschäftsführer | 21 Court Hey Avenue Ruby L36 4JB Liverpool Merseyside | United Kingdom | British | 115915420001 | |||||
| STRATTON, Malcolm | Geschäftsführer | Flat 40 Manor Park Court, Uttoxeter New Road DE22 3NG Derby Derbyshire | British | 30601260018 | ||||||
| A B & C SECRETARIAL LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 900006570001 | |||||||
| NEWMOND ADMINISTRATION LIMITED | Geschäftsführer | Pentagon House Sir Frank Whittle Road DE21 4XA Derby Derbyshire | 57363930002 | |||||||
| NEWMOND MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Geschäftsführer | Pentagon House Sir Frank Whittle Road DE21 4XA Derby Derbyshire | 57363780002 |
Hat BAXI UK LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| First fixed charge over the trade marks | Erstellt am 27. Jan. 2011 Geliefert am 02. Feb. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben First fixed charge all of the charged property see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A guarantee and debenture | Erstellt am 12. März 2004 Geliefert am 25. März 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each of the charging companies to any of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture made between the company and the royal bank of scotland PLC as agent and trustee for the secured parties (as defined) pursuant to the intercreditor agreement (as defined) | Erstellt am 28. Nov. 2000 Geliefert am 12. Dez. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The actual contingent present and/or future obligations and liabilities of the company to any of the secured parties under or pursuant to all or any of the secured documents (as defined) including the guarantee and debenture | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Trade marks and patents charge made between the company and the royal bank of scotland PLC as agent and trustee for the secured parties (as defined) | Erstellt am 28. Nov. 2000 Geliefert am 12. Dez. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The actual contingent, present and/or future obligations and liabilities of the company to any of the secured parties under or pursuant to any of the secured documents (as defined) including the trade marks and patents charge | |
Kurze Angaben A first fixed charge over the patents, the trade marks, the patent applications, the trade mark applications together with any goodwill of the company's business to which the patents, the trade marks, the patent applications and the trade mark applications. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 21. Jan. 2000 Geliefert am 31. Jan. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The actual, contingent, present and/or future obligations and liabilities of the company or any group company to any of the secured parties under, or pursuant to, all or any of the financing documents | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 03. Dez. 1999 Geliefert am 21. Dez. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to any of the financing documents | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat BAXI UK LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0