PYLLE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnamePYLLE LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02799224
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von PYLLE LIMITED?

    • Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich PYLLE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    3rd Floor Vintry Building
    Wine Street
    BS1 2BD Bristol
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von PYLLE LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    STUDYHOME (NO.165) LIMITED12. März 199312. März 1993

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PYLLE LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2019

    Welche sind die letzten Einreichungen für PYLLE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    13 SeitenLIQ13

    Geänderte Geschäftsanschrift vom The Lodge Park Road Shepton Mallet Somerset BA4 5BS zum 3rd Floor Vintry Building Wine Street Bristol BS1 2BD am 06. Feb. 2020

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 30. Jan. 2020

    LRESSP

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    5 SeitenLIQ01

    Cessation of Rachel Anne Jackson as a person with significant control on 12. Dez. 2019

    1 SeitenPSC07

    Erfüllung der Belastung 29 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 30 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 23 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 24 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 25 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 27 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 31 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 26 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 28 vollständig

    2 SeitenMR04

    Beschlüsse

    Resolutions
    14 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Änderung der Aktienrechte oder der Bezeichnung

    RES12
    incorporation

    Beschluss zur Annahme der Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Änderung der Bezeichnung der Aktienklasse

    2 SeitenSH08

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Juni 2019

    8 SeitenAA

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Juni 2018

    8 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 12. März 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 12. März 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Juni 2017

    9 SeitenAA

    Change of details for Mrs Rachel Anne Ingvaldson as a person with significant control on 23. Aug. 2017

    2 SeitenPSC04

    Bestätigungserklärung erstellt am 12. März 2017 mit Aktualisierungen

    6 SeitenCS01

    Wer sind die Geschäftsführer von PYLLE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    CLAYDON, Nicola
    Cranmore Close
    BA4 4EY Shepton Mallet
    2
    Somerset
    United Kingdom
    Sekretär
    Cranmore Close
    BA4 4EY Shepton Mallet
    2
    Somerset
    United Kingdom
    British79402600002
    JACKSON, John Haydon
    Ringwell House
    Ditcheat
    BA4 6RE Shepton Mallet
    Somerset
    Geschäftsführer
    Ringwell House
    Ditcheat
    BA4 6RE Shepton Mallet
    Somerset
    EnglandBritish38500620001
    VAUGHAN, Mervyn John
    11 Tallowood
    Lower Charlton
    BA4 5QN Shepton Mallet
    Somerset
    Sekretär
    11 Tallowood
    Lower Charlton
    BA4 5QN Shepton Mallet
    Somerset
    British66325100001
    OLD MILL COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    The Old Mill
    Park Road
    BA4 5BS Shepton Mallet
    Somerset
    Bevollmächtigter Sekretär
    The Old Mill
    Park Road
    BA4 5BS Shepton Mallet
    Somerset
    900007750001
    BOWE, Martin James
    22 St Marys Road
    Meare
    BA6 9SP Glastonbury
    The Laurels
    Somerset
    Geschäftsführer
    22 St Marys Road
    Meare
    BA6 9SP Glastonbury
    The Laurels
    Somerset
    EnglandBritish60364820001
    CLARKE, John Peter
    Furlong
    Poyntington
    DT9 4LF Sherborne
    Dorset
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Furlong
    Poyntington
    DT9 4LF Sherborne
    Dorset
    British900007740001
    JACKSON, John Haydon
    Ringwell House
    Ditcheat
    BA4 6RE Shepton Mallet
    Somerset
    Geschäftsführer
    Ringwell House
    Ditcheat
    BA4 6RE Shepton Mallet
    Somerset
    EnglandBritish38500620001
    JACKSON, Thomas Stuart
    Manor Farm
    Alhampton
    BA4 6PZ Shepton Mallet
    Somerset
    Geschäftsführer
    Manor Farm
    Alhampton
    BA4 6PZ Shepton Mallet
    Somerset
    United KingdomBritish11427040001
    LAWS, Peter John Daughton
    Old Ditch Farm
    Lynch Lane
    BA5 1HW Westbury Sub Mendip
    Somerset
    Geschäftsführer
    Old Ditch Farm
    Lynch Lane
    BA5 1HW Westbury Sub Mendip
    Somerset
    United KingdomBritish38965320001
    VAUGHAN, Mervyn John
    11 Tallowood
    Lower Charlton
    BA4 5QN Shepton Mallet
    Somerset
    Geschäftsführer
    11 Tallowood
    Lower Charlton
    BA4 5QN Shepton Mallet
    Somerset
    EnglandBritish66325100001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei PYLLE LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Mrs Rachel Anne Jackson
    Park Road
    BA4 5BS Shepton Mallet
    The Lodge
    Somerset
    06. Apr. 2016
    Park Road
    BA4 5BS Shepton Mallet
    The Lodge
    Somerset
    Ja
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: England
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder übt diese tatsächlich aus.
    Mr John Haydon Jackson
    Vintry Building
    Wine Street
    BS1 2BD Bristol
    3rd Floor
    06. Apr. 2016
    Vintry Building
    Wine Street
    BS1 2BD Bristol
    3rd Floor
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: England
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über die Aktivitäten eines Trusts auszuüben oder übt diese tatsächlich aus, und die Treuhänder dieses Trusts (in ihrer Eigenschaft als solche) halten, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat PYLLE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal mortgage
    Erstellt am 01. Apr. 2010
    Geliefert am 09. Apr. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    11 moorhill street easton bristol t/no BL24975 all plant and machinery owned by the borrower and its interest in any plant and machinery. All fixtures and fittings all other chattels and all benefits in respect of the insurances including claims and the refund of any premiums see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transaktionen
    • 09. Apr. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 03. Dez. 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 01. Apr. 2010
    Geliefert am 09. Apr. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    5 prudham street easton bristol t/no AV3306 all plant and machinery owned by the borrower and its interest in any plant and machinery. All fixtures and fittings all other chattels and all benefits in respect of the insurances including claims and the refund of any premiums see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transaktionen
    • 09. Apr. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 03. Dez. 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 01. Apr. 2010
    Geliefert am 09. Apr. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    43 tudor road easton bristol t/no AV149648 all plant and machinery owned by the borrower and its interest in any plant and machinery. All fixtures and fittings all other chattels and all benefits in respect of the insurances including claims and the refund of any premiums see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transaktionen
    • 09. Apr. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 03. Dez. 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 01. Apr. 2010
    Geliefert am 09. Apr. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    20 vicarage road whitehall bristol t/no BL51884 all plant and machinery owned by the borrower and its interest in any plant and machinery. All fixtures and fittings all other chattels and all benefits in respect of the insurances including claims and the refund of any premiums see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transaktionen
    • 09. Apr. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 03. Dez. 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 01. Apr. 2010
    Geliefert am 09. Apr. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    9 westminster road whitehall bristol t/no BL8610 all plant and machinery owned by the borrower and its interest in any plant and machinery. All fixtures and fittings all other chattels and all benefits in respect of the insurances including claims and the refund of any premiums see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transaktionen
    • 09. Apr. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 03. Dez. 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 01. Apr. 2010
    Geliefert am 09. Apr. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    115 colston road easton bristol t/no AV62606 all plant and machinery owned by the borrower and its interest in any plant and machinery. All fixtures and fittings all other chattels and all benefits in respect of the insurances including claims and the refund of any premiums see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transaktionen
    • 09. Apr. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 03. Dez. 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 01. Apr. 2010
    Geliefert am 09. Apr. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    14 lynton place redfield bristol t/no AV102970 all plant and machinery owned by the borrower and its interest in any plant and machinery. All fixtures and fittings all other chattels and all benefits in respect of the insurances including claims and the refund of any premiums see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transaktionen
    • 09. Apr. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 03. Dez. 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 01. Apr. 2010
    Geliefert am 09. Apr. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    1 westbourne road easton bristol t/no AV246599 all plant and machinery owned by the borrower and its interest in any plant and machinery. All fixtures and fittings all other chattels and all benefits in respect of the insurances including claims and the refund of any premiums see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transaktionen
    • 09. Apr. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 03. Dez. 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Deed of legal mortgage
    Erstellt am 30. März 2007
    Geliefert am 04. Apr. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Flat 9 north corner bedminster bristol,flat 16 north corner bedminster bristol with the benefit of all existing and future leases,underleases,tenacies,agreements for lease,rights,covenants,undertakings. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Svenska Handelsbanken Ab (Publ)
    Transaktionen
    • 04. Apr. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Dez. 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 14. Juli 2004
    Geliefert am 27. Juli 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    14 lynton place redfield bristol. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 27. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Feb. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 25. Feb. 2004
    Geliefert am 11. März 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    20 vicarage road easton bristol BS5 9AG. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Feb. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 25. Feb. 2004
    Geliefert am 11. März 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    43 tudor road easton bristol BS5 6BN. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Feb. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 25. Feb. 2004
    Geliefert am 11. März 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    5 purdham street easton bristol BS5 6ER. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Feb. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 25. Feb. 2004
    Geliefert am 11. März 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    1 westbourne road easton bristol BS5 0RT. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Feb. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 25. Feb. 2004
    Geliefert am 11. März 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    115 colston road easton bristol BS5 6AB. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Feb. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 25. Feb. 2004
    Geliefert am 11. März 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    11 moorhill street easton bristol BS5 oje. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Feb. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 25. Feb. 2004
    Geliefert am 11. März 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    9 westminster road easton bristol BS5 9AN. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Feb. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 27. Juni 2001
    Geliefert am 04. Juli 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a 11 moorhill street easton gloucester - BL24975. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 04. Juli 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Feb. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 27. Juni 2001
    Geliefert am 04. Juli 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a 20 vicarage road whitehall bristol gloucester - BL51884. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 04. Juli 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Feb. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 27. Juni 2001
    Geliefert am 04. Juli 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a 43 tudor road easton gloucester - AV149648. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 04. Juli 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Feb. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 27. Juni 2001
    Geliefert am 04. Juli 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a 5 prudham street easton gloucester - AV3306. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 04. Juli 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Feb. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 27. Juni 2001
    Geliefert am 04. Juli 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a 9 westminster road whitehall gloucester - BL8610. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 04. Juli 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Feb. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 27. Juni 2001
    Geliefert am 04. Juli 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a 115 colston road easton gloucester - AV62606. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 04. Juli 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Feb. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 27. Juni 2001
    Geliefert am 04. Juli 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a 1 westbourne road easton gloucester - AV246599. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 04. Juli 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Feb. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 24. Juli 2000
    Geliefert am 12. Aug. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £50,000 loan and £70,000 overdraft from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Property k/a 115 colston road easton bristol BS5 6AB - AV62606.
    Berechtigte Personen
    • Arbuthnot Latham & Co Limited
    Transaktionen
    • 12. Aug. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Aug. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat PYLLE LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    28. Dez. 2020Aufgelöst am
    30. Jan. 2020Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Graham David Randall
    The Old Town Hall 71 Christchurch Road
    BH24 1DH Ringwood
    Hampshire
    Praktiker
    The Old Town Hall 71 Christchurch Road
    BH24 1DH Ringwood
    Hampshire
    Mark Peter George Roach
    3rd Floor Vintry Building
    Wine Street
    BS1 2BD Bristol
    Praktiker
    3rd Floor Vintry Building
    Wine Street
    BS1 2BD Bristol

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0