GETRONICS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | GETRONICS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02801721 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von GETRONICS LIMITED?
- Beratung im Bereich Informationstechnologie (62020) / Information und Kommunikation
- Sonstige Informationsdienstleistungen im Bereich Informationstechnologie (62090) / Information und Kommunikation
- Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene Aktivitäten (63110) / Information und Kommunikation
- Reparatur von Computern und Peripheriegeräten (95110) / Sonstige Dienstleistungsbereiche
Wo befindet sich GETRONICS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 200 Brook Drive Green Park RG2 7UB Reading Berkshire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von GETRONICS LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
PINKROCCADE UK GROUP LIMITED | 03. Sept. 2002 | 03. Sept. 2002 |
PINKROCCADE (COMPUTERAID) LIMITED | 05. März 2002 | 05. März 2002 |
COMPUTERAID SERVICES LIMITED | 01. Apr. 1995 | 01. Apr. 1995 |
COMPUTERAID SERVICES GROUP LIMITED | 04. Jan. 1995 | 04. Jan. 1995 |
COMPUTERAID SERVICES 1993 LIMITED | 06. Dez. 1993 | 06. Dez. 1993 |
STEVTON (NO. 48) LIMITED | 19. März 1993 | 19. März 1993 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GETRONICS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2015 |
Welche sind die letzten Einreichungen für GETRONICS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 15 Seiten | AA | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 06. Dez. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Widerruf des Antrags auf Löschung der Gesellschaft | 1 Seiten | DS02 | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 3 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 4 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 13 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 06. Dez. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 30. Okt. 2014
| 4 Seiten | SH01 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 03. Nov. 2014
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 12 Seiten | AA | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Alfonso Delfos als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Theo Wolter Eysink als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 13 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 06. Dez. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Alfonso Delfos am 10. Jan. 2014 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von GETRONICS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYSINK, Theo Wolter | Geschäftsführer | Maanplein 55 PO BOX 30000 The Hague Tp5/7 Netherlands | Netherlands | Dutch | Business Executive | 188409910001 | ||||
ROIJMANS, Arnoud | Geschäftsführer | PO BOX 30000 2500 Ga The Hague Tp5/6 Netherlands | Netherlands | Dutch | Senior Legal Counsel | 170803260001 | ||||
BROWN, Graham Christopher | Sekretär | Cygnus House 1 The Southwood Crescent GU14 0NL Apollo Rise Farnborough Hampshire | British | Company Solicitor | 106493880001 | |||||
COOPER, Colin George | Sekretär | Chase House 6 Heathrow Copse RG26 5JG Baughurst Hampshire | British | Director | 157064500001 | |||||
SYMMONDS, Andrew Bryant | Sekretär | 21 Harrow Way Sindlesham RG41 5GJ Berkshire | British | Accountant | 94035050001 | |||||
WOOD, Christopher John | Sekretär | Rue De La Madeleine 13 1000 Bruxelles Belguim | British | 44524800003 | ||||||
APPLETON, Stuart Neil | Geschäftsführer | 11 Hill Brow BN3 6QG Brighton | England | British | Business Executive | 123453780001 | ||||
BALDWIN, David Hamilton | Geschäftsführer | Cygnus House 1 The Southwood Crescent GU14 0NL Apollo Rise Farnborough Hampshire | United Kingdom | British | Managing Director | 136371820001 | ||||
BOSMA, Hendrik | Geschäftsführer | Julianestraat 8 Rijswijh 2282rm Netherlands | Dutch | Director | 83189550001 | |||||
BRADY, Tara Christopher | Geschäftsführer | 14 Ellesmere Close E11 1PT London | United Kingdom | British | Managing Director | 145701300001 | ||||
BROENINK, Arnold Johannes Gerardus | Geschäftsführer | Rosewood 8 GU22 7LE Woking Surrey | Dutch | Finance Director | 101988170001 | |||||
BURGESS, Mark Geoffrey William | Geschäftsführer | 5 Glenmore House Richmond Hill TW10 6BQ Richmond Surrey | British | Director | 28476620004 | |||||
CLARKE, Jonathan George Gough | Geschäftsführer | Westland Farm Ockley Road GU6 7SL Ewhurst Surrey | British | Venture Capitalist | 72712910001 | |||||
COOK, Mark | Geschäftsführer | Cygnus House 1 The Southwood Crescent GU14 0NL Apollo Rise Farnborough Hampshire | England | British | Managing Director | 154617450001 | ||||
COOPER, Colin George | Geschäftsführer | Chase House 6 Heathrow Copse RG26 5JG Baughurst Hampshire | England | British | Director | 157064500001 | ||||
DELFOS, Alfonso | Geschäftsführer | PO BOX 30000 2500 Ga The Hague Tp5/9 Netherlands | Netherlands | Dutch | Tax Consultant | 170807080001 | ||||
FAULKNER, Stephen | Geschäftsführer | Cygnus House 1 The Southwood Crescent GU14 0NL Apollo Rise Farnborough Hampshire | United Kingdom | British | Finance Director | 137488750001 | ||||
HAWKER, John David | Geschäftsführer | 2 Fydlers Close Kiln Lane Windsor Forest SL4 2DY Windsor Berkshire | Uk | British | Business Executive | 54836450001 | ||||
HYLAND, Clive | Geschäftsführer | Beechwood Eastbourne Road BN8 6PS Halland East Sussex | British | Managing Director | 79767610001 | |||||
KENEALY, Mark | Geschäftsführer | Fernhill Kidmore Lane RG4 9SH Sonning Common South Oxfordshire | British | Business Executive | 107625200001 | |||||
MIDDELBURG, Willem Maarten | Geschäftsführer | Prins Albertlaan 22 Voorburg Zuid Holland 2271 El The Netherlands | Netherlander | Cfo | 80156050001 | |||||
MOORE, Gordon James | Geschäftsführer | 30 Arlington Avenue N1 7AY London | British | Centure Capitalist | 64281120001 | |||||
MUNTON, Richard James | Geschäftsführer | The Forge Hamptons TN11 9RE Tonbridge Kent | British | Director | 11882410003 | |||||
O'BRIEN, Maurice Douglas | Geschäftsführer | 4 Dinorben Avenue GU13 9SG Fleet Hampshire | British | Company Director | 27700320001 | |||||
PIGHILLS, Michael John | Geschäftsführer | Northcourt Lodge 106 Oxford Road OX14 2AG Abingdon Oxfordshire | British | Director | 35129350002 | |||||
WHITCHURCH, Michael | Geschäftsführer | Cygnus House 1 The Southwood Crescent GU14 0NL Apollo Rise Farnborough Hampshire | England | British | Director | 130732580001 | ||||
WILSON, Kenneth Robert | Geschäftsführer | 3 Lynwood Chase RG12 2JT Bracknell Berkshire | British | Director | 22986560001 | |||||
WOOD, Christopher John | Geschäftsführer | Rue De La Madeleine 13 1000 Bruxelles Belguim | British | Company Director | 44524800003 |
Hat GETRONICS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Rent deposit deed | Erstellt am 09. Dez. 2005 Geliefert am 14. Dez. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The deposit sum of £35,216.88. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 14. Mai 2003 Geliefert am 20. Mai 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Right title and interest from time to time and to the real property, the tangible moveable property, the accounts, the intellectual property, the goodwill, the uncalled capital, the investments and all monetary claims and all related rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Rent deposit deed | Erstellt am 09. Jan. 2003 Geliefert am 14. Jan. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The sum of £35,216.88 paid into an interest bearing account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental legal mortgage | Erstellt am 15. Jan. 1996 Geliefert am 17. Jan. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due from the company and/or computeraid services limited (now known as computeraid training limited) to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Unit 2 boston court kansas avenue salford t/no GM486578. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 07. Dez. 1994 Geliefert am 13. Dez. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or computeraid services limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0