AXIS HEALTH & FITNESS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | AXIS HEALTH & FITNESS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02802122 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von AXIS HEALTH & FITNESS LIMITED?
- Fitnessstudios (93130) / Kunst, Unterhaltung und Erholung
Wo befindet sich AXIS HEALTH & FITNESS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 15 Canada Square E14 5GL London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von AXIS HEALTH & FITNESS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für AXIS HEALTH & FITNESS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 6 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Pure Gym Limited Town Centre House Leeds LS2 8LY United Kingdom zum 15 Canada Square London E14 5GL am 28. Feb. 2018 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Peter William Denby Roberts als Geschäftsführer am 30. Nov. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jacques De Bruin als Geschäftsführer am 30. Nov. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Notification of L a Fitness Limited as a person with significant control on 01. Aug. 2017 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Cessation of Crown Sports Limited as a person with significant control on 01. Aug. 2017 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. März 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 22. März 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Okt. 2015 bis 31. Dez. 2015 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O La Fitness Limited Sandall Stones Road Kirk Sandall Doncaster South Yorkshire DN3 1QR zum C/O Pure Gym Limited Town Centre House Leeds LS2 8LY am 06. Nov. 2015 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 13 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 9 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 12 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 028021220014 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Peter William Denby Roberts am 08. Okt. 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Okt. 2014 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Adam John Gordon Bellamy als Sekretär am 28. Mai 2015 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ross Steven Chester als Geschäftsführer am 28. Mai 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Martin Long als Geschäftsführer am 28. Mai 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von AXIS HEALTH & FITNESS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELLAMY, Adam John Gordon | Sekretär | Canada Square E14 5GL London 15 | 198433720001 | |||||||
| BELLAMY, Adam John Gordon | Geschäftsführer | Canada Square E14 5GL London 15 | England | British | 172693720002 | |||||
| COBBOLD, Humphrey Michael | Geschäftsführer | Canada Square E14 5GL London 15 | United Kingdom | British | 100141010001 | |||||
| DAVIES, Raymond Alan | Sekretär | 1 Woburn Close GU16 8NU Frimley Surrey | British | 4878250001 | ||||||
| GOSLING, Steven Paul | Sekretär | 5 Little Heath Lane Dunham Massey WA14 4TS Altrincham Cheshire | British | 124301460001 | ||||||
| JARVIS, Diane | Sekretär | Tudor Cottage Ranks Green CM3 2BG Fairstead Essex | British | 79818790001 | ||||||
| STEELE, Ronald Frank | Sekretär | Middle Halings Halings Lane Denham UB9 5DQ Uxbridge Middlesex | British | 42597630001 | ||||||
| STORR, Christopher James | Sekretär | The Grange Hollingdon DE6 3GB Ashbourne Derbyshire | British | 114849640001 | ||||||
| STORR, Christopher James | Sekretär | The Grange Hollingdon DE6 3GB Ashbourne Derbyshire | British | 114849640001 | ||||||
| TAYLOR, Graham | Sekretär | 14 Roupell Street SE1 8SP London | British | 82374420004 | ||||||
| TAYLOR, Richard | Sekretär | 33 Green Lane HA8 7PS Edgware Middlesex | British | 71126560002 | ||||||
| ELK COMPANY SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Corporate House 419-421 High Road HA3 6EL Harrow Middlesex | 900007410001 | |||||||
| ARGYLE, Coralie | Geschäftsführer | 80 Dene Road HA6 2DF Northwood Middlesex | British | 49868490002 | ||||||
| BROSTER, Stuart Paul | Geschäftsführer | Greystones Bromley Road Cockleford Heath Ardleigh CO7 7SE Colchester Essex | United Kingdom | British | 114847350001 | |||||
| BRUIN, Jacques De | Geschäftsführer | Town Centre House LS2 8LY Leeds C/O Pure Gym Limited United Kingdom | United Kingdom | South African | 198346420001 | |||||
| CHESTER, Ross Steven | Geschäftsführer | C/O La Fitness Limited Sandall Stones Road Kirk Sandall DN3 1QR Doncaster South Yorkshire | British | 137527310001 | ||||||
| COSTARD, David James | Geschäftsführer | 8 West Court West Drive RG4 6GL Sonning On Thames Berkshire | Uk | English | 93663310001 | |||||
| DAVIES, Raymond Alan | Geschäftsführer | 1 Woburn Close GU16 8NU Frimley Surrey | British | 4878250001 | ||||||
| FLAHIVE, Brendan Joseph | Geschäftsführer | 11 Eastbury Avenue HA6 3LB Northwood Middlesex | Uk | British | 24222010001 | |||||
| GAMBLE, John William | Geschäftsführer | 22 St Judes Road TW20 0BY Egham Surrey | British | 40919790001 | ||||||
| GOSLING, Steven Paul | Geschäftsführer | 5 Little Heath Lane Dunham Massey WA14 4TS Altrincham Cheshire | United Kingdom | British | 124301460001 | |||||
| GREALEY, Martyn | Geschäftsführer | Rowington House Pound Close Off Poolhead Lane B94 5ET Earlswood Warwickshire | United Kingdom | British | 125401590001 | |||||
| JARVIS, Diane | Geschäftsführer | Tudor Cottage Ranks Green CM3 2BG Fairstead Essex | England | British | 79818790001 | |||||
| LEWIS, Stephen Clifton | Geschäftsführer | 2 Pinewood Close SL9 7DS Gerrards Cross Buckinghamshire | United Kingdom | British | 34392890004 | |||||
| LISTER, James Ashton | Geschäftsführer | 11 Norham Road OX2 6SF Oxford Oxfordshire | British | 2798240004 | ||||||
| LONG, Martin | Geschäftsführer | C/O La Fitness Limited Sandall Stones Road Kirk Sandall DN3 1QR Doncaster South Yorkshire | England | British | 125885350001 | |||||
| MCCOLL, Arthur | Geschäftsführer | C/O La Fitness Limited Sandall Stones Road Kirk Sandall DN3 1QR Doncaster South Yorkshire | Australia | British | 139099550001 | |||||
| PENNINGTON, Jonathan Michael | Geschäftsführer | 24 Tavistock Terrace N19 4DB London | England | British | 26455990002 | |||||
| PHILPOTT, Stephen John Randall | Geschäftsführer | St John's Cottage Cherry Tree Lane SL3 6JE Fulmer Berkshire | United Kingdom | British | 45243130001 | |||||
| PINSENT, Stephen | Geschäftsführer | Two Gables Winchmore Hill HP7 0PN Amersham Buckinghamshire | England | British | 56439840001 | |||||
| PURSLOW, Christian Mark Cecil | Geschäftsführer | The Grove Warren Park Coombe Hill KT2 7HX Kingston Upon Thames | United Kingdom | British | 83244210001 | |||||
| ROBERTS, Peter William Denby | Geschäftsführer | Hutts Lane, Grewelthorpe HG4 3DA Ripon The Hutts United Kingdom | England | British | 106538510001 | |||||
| STEELE, Ronald Frank | Geschäftsführer | Middle Halings Halings Lane Denham UB9 5DQ Uxbridge Middlesex | United Kingdom | British | 42597630001 | |||||
| STORR, Christopher James | Geschäftsführer | The Grange Hollingdon DE6 3GB Ashbourne Derbyshire | United Kingdom | British | 114849640001 | |||||
| STORR, Christopher James | Geschäftsführer | The Grange Hollingdon DE6 3GB Ashbourne Derbyshire | United Kingdom | British | 114849640001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei AXIS HEALTH & FITNESS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L A Fitness Limited | 01. Aug. 2017 | Town Centre House Merrion Centre LS2 8LY Leeds C/O Pure Gym Limited United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Crown Sports Limited | 06. Apr. 2016 | Town Centre House Merrion Centre LS2 8LY Leeds C/O Pure Gym Limited United Kingdom | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat AXIS HEALTH & FITNESS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 05. Juni 2014 Geliefert am 10. Juni 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A supplemental security and confirmation deed | Erstellt am 30. Aug. 2011 Geliefert am 13. Sept. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the finance parties and all monies due or to become due from the chargors to all or any of the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Its relevant assets as more specifically referred to in the relevant security documents upon the terms contained in the relevant security documents. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Amendment deed | Erstellt am 21. Juli 2009 Geliefert am 31. Juli 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The remaining assets, see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental debenture | Erstellt am 21. Juni 2006 Geliefert am 03. Juli 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben L/H burnham squash club 821A yeovil road trading estate slough t/no BK315801 and northwood squash centre chestnut avenue northwood middlesex t/no AGL37538. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 23. März 2006 Geliefert am 03. Apr. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the crunch finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Its interest in the land referred to opposite its name in schedule 1 meaning, burnham squash club, 821A yeovil road trading estate, slough t/no BK315801. Northwood squash centre, chestnut avenue, northwood, middlesex. For details o f further land charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 23. März 2006 Geliefert am 03. Apr. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite debenture | Erstellt am 26. Apr. 2002 Geliefert am 09. Mai 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies,liabilities and obligations whatsoever due or to become due by any group company to the security beneficiaries on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Including (I) the f/hold property known as northwood squash club,chestnut ave,northwood,midd'x; AGL37538; (ii) f/hold property known as broke hill golf club,sevenoaks road,halstead sevenoaks; K588424 and K685755; (iii) l/hold property known as broke hill golf club,sevenoaks rd,halstead,sevenoaks; K725693; see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 15. Okt. 2001 Geliefert am 19. Okt. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H 821A yeovil road trading estate slough berkshire t/n-BK315801. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 15. Okt. 2001 Geliefert am 19. Okt. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H chestnut avenue northwood middlesex t/n-AGL37538. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 15. Okt. 2001 Geliefert am 17. Okt. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 10. Juni 1996 Geliefert am 27. Juni 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a or being northwood squash centre chestnut avenue northwood middlesex together with all buildings fixtures and fittings thereon. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Single debenture | Erstellt am 10. Juni 1996 Geliefert am 19. Juni 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 21. Sept. 1993 Geliefert am 23. Sept. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H 821A yeovil road trading estate slough berkshire with all buildings and fixtures thereon and by way of A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 14. Juni 1993 Geliefert am 22. Juni 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a burnham squash club building 812A yeovil road trading estate slough bucks and the proceeds of sale thereof assigns the goodwill of the business full benefit of all licences and by way of A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat AXIS HEALTH & FITNESS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0