CA 2010 PLC
Überblick
| Unternehmensname | CA 2010 PLC |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Aktiengesellschaft |
| Unternehmensnummer | 02808331 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CA 2010 PLC?
- (7415) /
Wo befindet sich CA 2010 PLC?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | The Valley Floyd Road SE7 8BL London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CA 2010 PLC?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| CHARLTON ATHLETIC PLC | 06. Jan. 1994 | 06. Jan. 1994 |
| YPCS 25 P.L.C. | 13. Apr. 1993 | 13. Apr. 1993 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CA 2010 PLC?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CA 2010 PLC?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Hatter als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von David White als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed charlton athletic PLC\certificate issued on 10/09/10 | 2 Seiten | CERTNM | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Hinweis auf Namensänderung | 2 Seiten | CONNOT | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Derek Chappell als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Hughes als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Robert Whitehand als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Sumners als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||||||
Ernennung von Stephen Kavanagh als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 05. Aug. 2010
| 8 Seiten | SH01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Apr. 2010 mit umfangreicher Liste der Aktionäre | 26 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Richard Alan Murray Obodynski am 15. Jan. 2010 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
legacy | Seiten | ANNOTATION | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CA 2010 PLC?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERTEX LAW (CO SECRETARIAL) LIMITED | Sekretär | Kings Hill Avenue Kings Hill ME19 4UD West Malling 23 Kent | 102565320003 | |||||||
| BUTLER-GALLIE, Stuart | Geschäftsführer | Bethersden TN26 3EW Ashford Baylisden House Kent | England | British | 96783000001 | |||||
| KAVANAGH, Stephen Andrew | Geschäftsführer | Floyd Road SE7 8BL London The Valley | England | British | 153739440001 | |||||
| MURRAY OBODYNSKI, Richard Alan | Geschäftsführer | 66-70 Coombe Road KT3 4QW New Maldon Nunn Hayward Surrey | England | British | 46792500008 | |||||
| FULLER, Jonathan Tom Telford | Sekretär | Rose Cottage Twitton Lane TN14 5JS Otford Kent | British | 52304380001 | ||||||
| ROBINSON, Keith Marshall | Sekretär | 15 Green Lane Oxhey WD19 4NL Watford | British | 8282250001 | ||||||
| BRACHERS LIMITED | Sekretär | Somerfield House, 59 London Road ME16 8JH Maidstone Kent | 80957680001 | |||||||
| DAVIES LAVERY COMPANY SECRETARIAL LIMITED | Sekretär | Victoria Court 17-21 Ashford Road ME14 5FA Maidstone Kent | 87634940001 | |||||||
| YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 12 York Place LS1 2DS Leeds West Yorkshire | 900000880001 | |||||||
| ALWEN, Roger Norman | Geschäftsführer | 11 Bywater Street Chelsea SW3 4XD London | British | 14306470002 | ||||||
| BONE, Gregory Peter | Geschäftsführer | 17 Brassey Hill Limpsfield RH8 0ES Oxted Surrey | British | 26854940002 | ||||||
| CHAPPELL, Derek Guy | Geschäftsführer | 13 Walton Place SW3 1RJ London | England | British | 32697520004 | |||||
| CLARKE, Stephen Thomas | Geschäftsführer | 20 Porcupine Close Mottingham SE9 3AE London | United Kingdom | British | 33772930001 | |||||
| COLLINS, Richard Denis | Geschäftsführer | 33b Garden Road BR1 3LU Bromley Kent | British | 1811300001 | ||||||
| FRANKLIN, Gideon Benjamin Cecil | Geschäftsführer | 22 Ringmore Rise SE23 3DE London | United Kingdom | British | 69257060003 | |||||
| GRADE, Michael Ian | Geschäftsführer | 6 Westover Road SW18 2RG London | England | British | 71289920004 | |||||
| HALLETT, Brian James | Geschäftsführer | 39 Old Garden Close Locks Heath SO31 6RN Southampton Hampshire | United Kingdom | British | 9715270001 | |||||
| HATTER, Maurice, Sir | Geschäftsführer | 38 Queens Grove NW8 6HH London | England | British | 36506710001 | |||||
| HATTER, Richard Mark | Geschäftsführer | Hamilton Terrace St John's Wood NW8 9UJ London 54 | England | English | 67030840002 | |||||
| HUGHES, David John | Geschäftsführer | Sterling Street SW7 1HN London 8 | England | British | 49400910005 | |||||
| HUGHES, David John | Geschäftsführer | Vitol Sa Bowater House 68 Knightsbridge SW1X 7LT London | British | 49400910001 | ||||||
| NORRIS, Craig Victor | Geschäftsführer | 156 Humber Road Blackheath SE3 7EF London | British | 43819750002 | ||||||
| ROBINSON, Keith Marshall | Geschäftsführer | 15 Green Lane Oxhey WD19 4NL Watford | United Kingdom | British | 8282250001 | |||||
| SIMONS, Martin Alan | Geschäftsführer | 48 Shooters Hill Road Blackheath SE3 7BG London | British | 15777410001 | ||||||
| STEVENS, Michael Clifford | Geschäftsführer | Northside 36 Southborough Road Bickley BR1 2EB Bromley Kent | British | 25614630001 | ||||||
| SUMNERS, David Colin, Dr | Geschäftsführer | The Old Vicarage 2 Mountfort Crescent N1 1JW London | United Kingdom | British | 47150540002 | |||||
| UFTON, Derek Gilbert | Geschäftsführer | 88 Madeira Avenue BR1 4AS Bromley Kent | British | 15366180001 | ||||||
| WHITE, David | Geschäftsführer | Watts Lane BR7 5PJ Chislehurst The Briars Kent | United Kingdom | British | 138647910001 | |||||
| WHITEHAND, Robert Charles | Geschäftsführer | Dunstall Priory Shoreham Road Shoreham TN14 7UE Sevenoaks Kent | England | British | 54419430001 | |||||
| YORK PLACE COMPANY NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 12 York Place LS1 2DS Leeds West Yorkshire | 900000870001 | |||||||
| YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 12 York Place LS1 2DS Leeds West Yorkshire | 900000880001 |
Hat CA 2010 PLC Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 25. Sept. 2009 Geliefert am 29. Sept. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 25. Sept. 2009 Geliefert am 29. Sept. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 25. Sept. 2009 Geliefert am 29. Sept. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 19. Juni 2009 Geliefert am 26. Juni 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 04. März 2009 Geliefert am 20. März 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 04. März 2009 Geliefert am 14. März 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 04. März 2009 Geliefert am 14. März 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 19. März 2008 Geliefert am 08. Apr. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the to the bondholders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 31. Dez. 2007 Geliefert am 10. Jan. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 08. Mai 2007 Geliefert am 09. Mai 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 08. Mai 2007 Geliefert am 09. Mai 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 08. Mai 2007 Geliefert am 09. Mai 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 08. Mai 2007 Geliefert am 09. Mai 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 08. Mai 2007 Geliefert am 09. Mai 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 25. Mai 1999 Geliefert am 03. Juni 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 29. März 1999 Geliefert am 13. Apr. 1999 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Legal mortgage over the property; fixed charge over f/h & l/h property both present and future together with all fixtures and its goodwill; a floating charge over the undertaking and all its (other) property and assets whatsoever.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0