CA 2010 PLC

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCA 2010 PLC
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformAktiengesellschaft
    Unternehmensnummer 02808331
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CA 2010 PLC?

    • (7415) /

    Wo befindet sich CA 2010 PLC?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    The Valley
    Floyd Road
    SE7 8BL London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CA 2010 PLC?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CHARLTON ATHLETIC PLC06. Jan. 199406. Jan. 1994
    YPCS 25 P.L.C.13. Apr. 199313. Apr. 1993

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CA 2010 PLC?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2009

    Welche sind die letzten Einreichungen für CA 2010 PLC?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Beendigung der Bestellung von Richard Hatter als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von David White als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Sale of entire iss share cap/sec 190(1) 23/08/2010
    RES13
    capital

    Beschluss zur Zuteilung von Wertpapieren

    RES10

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed charlton athletic PLC\certificate issued on 10/09/10
    2 SeitenCERTNM
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 23. Aug. 2010

    RES15

    Hinweis auf Namensänderung

    2 SeitenCONNOT

    Beendigung der Bestellung von Derek Chappell als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von David Hughes als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Robert Whitehand als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von David Sumners als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    Ernennung von Stephen Kavanagh als Direktor

    3 SeitenAP01

    Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 05. Aug. 2010

    • Kapital: GBP 31,947,961.5
    8 SeitenSH01

    Jahresrückblick erstellt bis 13. Apr. 2010 mit umfangreicher Liste der Aktionäre

    26 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Richard Alan Murray Obodynski am 15. Jan. 2010

    3 SeitenCH01

    legacy

    SeitenANNOTATION

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Zuteilung von Wertpapieren

    RES10
    capital

    Beschlüsse

    Re section 560 ca 2006 30/12/2009
    RES13

    Wer sind die Geschäftsführer von CA 2010 PLC?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    VERTEX LAW (CO SECRETARIAL) LIMITED
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4UD West Malling
    23
    Kent
    Sekretär
    Kings Hill Avenue
    Kings Hill
    ME19 4UD West Malling
    23
    Kent
    102565320003
    BUTLER-GALLIE, Stuart
    Bethersden
    TN26 3EW Ashford
    Baylisden House
    Kent
    Geschäftsführer
    Bethersden
    TN26 3EW Ashford
    Baylisden House
    Kent
    EnglandBritish96783000001
    KAVANAGH, Stephen Andrew
    Floyd Road
    SE7 8BL London
    The Valley
    Geschäftsführer
    Floyd Road
    SE7 8BL London
    The Valley
    EnglandBritish153739440001
    MURRAY OBODYNSKI, Richard Alan
    66-70 Coombe Road
    KT3 4QW New Maldon
    Nunn Hayward
    Surrey
    Geschäftsführer
    66-70 Coombe Road
    KT3 4QW New Maldon
    Nunn Hayward
    Surrey
    EnglandBritish46792500008
    FULLER, Jonathan Tom Telford
    Rose Cottage
    Twitton Lane
    TN14 5JS Otford
    Kent
    Sekretär
    Rose Cottage
    Twitton Lane
    TN14 5JS Otford
    Kent
    British52304380001
    ROBINSON, Keith Marshall
    15 Green Lane
    Oxhey
    WD19 4NL Watford
    Sekretär
    15 Green Lane
    Oxhey
    WD19 4NL Watford
    British8282250001
    BRACHERS LIMITED
    Somerfield House, 59 London Road
    ME16 8JH Maidstone
    Kent
    Sekretär
    Somerfield House, 59 London Road
    ME16 8JH Maidstone
    Kent
    80957680001
    DAVIES LAVERY COMPANY SECRETARIAL LIMITED
    Victoria Court
    17-21 Ashford Road
    ME14 5FA Maidstone
    Kent
    Sekretär
    Victoria Court
    17-21 Ashford Road
    ME14 5FA Maidstone
    Kent
    87634940001
    YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Bevollmächtigter Sekretär
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000880001
    ALWEN, Roger Norman
    11 Bywater Street
    Chelsea
    SW3 4XD London
    Geschäftsführer
    11 Bywater Street
    Chelsea
    SW3 4XD London
    British14306470002
    BONE, Gregory Peter
    17 Brassey Hill
    Limpsfield
    RH8 0ES Oxted
    Surrey
    Geschäftsführer
    17 Brassey Hill
    Limpsfield
    RH8 0ES Oxted
    Surrey
    British26854940002
    CHAPPELL, Derek Guy
    13 Walton Place
    SW3 1RJ London
    Geschäftsführer
    13 Walton Place
    SW3 1RJ London
    EnglandBritish32697520004
    CLARKE, Stephen Thomas
    20 Porcupine Close
    Mottingham
    SE9 3AE London
    Geschäftsführer
    20 Porcupine Close
    Mottingham
    SE9 3AE London
    United KingdomBritish33772930001
    COLLINS, Richard Denis
    33b Garden Road
    BR1 3LU Bromley
    Kent
    Geschäftsführer
    33b Garden Road
    BR1 3LU Bromley
    Kent
    British1811300001
    FRANKLIN, Gideon Benjamin Cecil
    22 Ringmore Rise
    SE23 3DE London
    Geschäftsführer
    22 Ringmore Rise
    SE23 3DE London
    United KingdomBritish69257060003
    GRADE, Michael Ian
    6 Westover Road
    SW18 2RG London
    Geschäftsführer
    6 Westover Road
    SW18 2RG London
    EnglandBritish71289920004
    HALLETT, Brian James
    39 Old Garden Close
    Locks Heath
    SO31 6RN Southampton
    Hampshire
    Geschäftsführer
    39 Old Garden Close
    Locks Heath
    SO31 6RN Southampton
    Hampshire
    United KingdomBritish9715270001
    HATTER, Maurice, Sir
    38 Queens Grove
    NW8 6HH London
    Geschäftsführer
    38 Queens Grove
    NW8 6HH London
    EnglandBritish36506710001
    HATTER, Richard Mark
    Hamilton Terrace
    St John's Wood
    NW8 9UJ London
    54
    Geschäftsführer
    Hamilton Terrace
    St John's Wood
    NW8 9UJ London
    54
    EnglandEnglish67030840002
    HUGHES, David John
    Sterling Street
    SW7 1HN London
    8
    Geschäftsführer
    Sterling Street
    SW7 1HN London
    8
    EnglandBritish49400910005
    HUGHES, David John
    Vitol Sa
    Bowater House 68 Knightsbridge
    SW1X 7LT London
    Geschäftsführer
    Vitol Sa
    Bowater House 68 Knightsbridge
    SW1X 7LT London
    British49400910001
    NORRIS, Craig Victor
    156 Humber Road
    Blackheath
    SE3 7EF London
    Geschäftsführer
    156 Humber Road
    Blackheath
    SE3 7EF London
    British43819750002
    ROBINSON, Keith Marshall
    15 Green Lane
    Oxhey
    WD19 4NL Watford
    Geschäftsführer
    15 Green Lane
    Oxhey
    WD19 4NL Watford
    United KingdomBritish8282250001
    SIMONS, Martin Alan
    48 Shooters Hill Road
    Blackheath
    SE3 7BG London
    Geschäftsführer
    48 Shooters Hill Road
    Blackheath
    SE3 7BG London
    British15777410001
    STEVENS, Michael Clifford
    Northside 36 Southborough Road
    Bickley
    BR1 2EB Bromley
    Kent
    Geschäftsführer
    Northside 36 Southborough Road
    Bickley
    BR1 2EB Bromley
    Kent
    British25614630001
    SUMNERS, David Colin, Dr
    The Old Vicarage
    2 Mountfort Crescent
    N1 1JW London
    Geschäftsführer
    The Old Vicarage
    2 Mountfort Crescent
    N1 1JW London
    United KingdomBritish47150540002
    UFTON, Derek Gilbert
    88 Madeira Avenue
    BR1 4AS Bromley
    Kent
    Geschäftsführer
    88 Madeira Avenue
    BR1 4AS Bromley
    Kent
    British15366180001
    WHITE, David
    Watts Lane
    BR7 5PJ Chislehurst
    The Briars
    Kent
    Geschäftsführer
    Watts Lane
    BR7 5PJ Chislehurst
    The Briars
    Kent
    United KingdomBritish138647910001
    WHITEHAND, Robert Charles
    Dunstall Priory Shoreham Road
    Shoreham
    TN14 7UE Sevenoaks
    Kent
    Geschäftsführer
    Dunstall Priory Shoreham Road
    Shoreham
    TN14 7UE Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritish54419430001
    YORK PLACE COMPANY NOMINEES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000870001
    YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000880001

    Hat CA 2010 PLC Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 25. Sept. 2009
    Geliefert am 29. Sept. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • David Hughes
    Transaktionen
    • 29. Sept. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Aug. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 25. Sept. 2009
    Geliefert am 29. Sept. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • David Sumners
    Transaktionen
    • 29. Sept. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Sept. 2009
    Debenture
    Erstellt am 25. Sept. 2009
    Geliefert am 29. Sept. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • David White
    Transaktionen
    • 29. Sept. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Sept. 2009
    • 25. Aug. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 19. Juni 2009
    Geliefert am 26. Juni 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Sir Maurice Hatter
    Transaktionen
    • 26. Juni 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Aug. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 04. März 2009
    Geliefert am 20. März 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Richard Alan Murray
    Transaktionen
    • 20. März 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Aug. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 04. März 2009
    Geliefert am 14. März 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Derek Chappell
    Transaktionen
    • 14. März 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Aug. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 04. März 2009
    Geliefert am 14. März 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • 56 Developments LLP
    Transaktionen
    • 14. März 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Aug. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 19. März 2008
    Geliefert am 08. Apr. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the to the bondholders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Richard Alan Murray and Derek Chappell
    Transaktionen
    • 08. Apr. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Aug. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 31. Dez. 2007
    Geliefert am 10. Jan. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Richard Alan Murray
    Transaktionen
    • 10. Jan. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Mai 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 08. Mai 2007
    Geliefert am 09. Mai 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bolistrom Limited
    Transaktionen
    • 09. Mai 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Mai 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 08. Mai 2007
    Geliefert am 09. Mai 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Sir Maurice Hatter
    Transaktionen
    • 09. Mai 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Mai 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 08. Mai 2007
    Geliefert am 09. Mai 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • David Colin Sumners
    Transaktionen
    • 09. Mai 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Mai 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 08. Mai 2007
    Geliefert am 09. Mai 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Robert Charles Whitehand
    Transaktionen
    • 09. Mai 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Mai 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 08. Mai 2007
    Geliefert am 09. Mai 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Derek Chappell
    Transaktionen
    • 09. Mai 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Mai 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 25. Mai 1999
    Geliefert am 03. Juni 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Juni 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 29. März 1999
    Geliefert am 13. Apr. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Legal mortgage over the property; fixed charge over f/h & l/h property both present and future together with all fixtures and its goodwill; a floating charge over the undertaking and all its (other) property and assets whatsoever.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lombard North Central PLC
    Transaktionen
    • 13. Apr. 1999Registrierung einer Belastung (395)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0