TENENS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | TENENS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02813651 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von TENENS LIMITED?
- Güterkraftverkehr (49410) / Verkehr und Lagerei
- Betrieb von Lager- und Umschlagsanlagen für den Landverkehr (52103) / Verkehr und Lagerei
- Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen
- Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich TENENS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Tenens House Kingfisher Business Park GL5 2BY London Road Thrupp Stroud |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von TENENS LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
RBCO 146 LIMITED | 28. Apr. 1993 | 28. Apr. 1993 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TENENS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2015 |
Welche sind die letzten Einreichungen für TENENS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. Apr. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 028136510012, erstellt am 01. Sept. 2016 | 55 Seiten | MR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2015 | 21 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Apr. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Robert Conquer Arbuckle Brown als Geschäftsführer am 02. Feb. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Robert Conquer Arbuckle Brown als Sekretär am 02. Feb. 2016 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Apr. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2014 | 24 Seiten | AA | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||
| ||||||||||||
Eintragung der Belastung 028136510011, erstellt am 25. Sept. 2014 | 54 Seiten | MR01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 8 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Apr. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2013 | 22 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Benjamin John Morris als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Daniel Peter Morris als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 028136510010 | 6 Seiten | MR01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Apr. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Robert Conquer Arbuckle Brown als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2012 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Apr. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2011 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von TENENS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEECHAM, Julian Mark | Geschäftsführer | Tenens House Kingfisher Business Park GL5 2BY London Road Thrupp Stroud | England | British | Accountant | 9786430003 | ||||
MORRIS, Benjamin John | Geschäftsführer | Tenens House Kingfisher Business Park GL5 2BY London Road Thrupp Stroud | England | British | Operations Director | 114608270001 | ||||
MORRIS, Daniel Peter | Geschäftsführer | Tenens House Kingfisher Business Park GL5 2BY London Road Thrupp Stroud | England | British | Property Director | 109971160006 | ||||
MORRIS, Peter Ewan | Geschäftsführer | Tenens House Kingfisher Business Park GL5 2BY London Road Thrupp Stroud | England | British | Managing Director | 1480430004 | ||||
BROWN, Robert Conquer Arbuckle | Sekretär | Tenens House Kingfisher Business Park GL5 2BY London Road Thrupp Stroud | British | 41959370002 | ||||||
RB SECRETARIAT LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Beaufort House Tenth Floor 15 St Botolph Street EC3A 7EE London | 900006270001 | |||||||
BROWN, Robert Conquer Arbuckle | Geschäftsführer | Tenens House Kingfisher Business Park GL5 2BY London Road Thrupp Stroud | United Kingdom | British | Company Secretary | 41959370002 | ||||
SMITH, Christopher Winston | Geschäftsführer | 7 The Avenue Sneyd Park BS9 1PD Bristol | United Kingdom | British | Consultant | 37052960001 | ||||
RB DIRECTORS ONE LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Beaufort House Tenth Floor 15 St Botolph Street EC3A 7EE London | 900006260001 | |||||||
RB DIRECTORS TWO LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Beaufort House Tenth Floor 15 St Botolph Street EC3A 7EE London | 900006250001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei TENENS LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
---|---|---|---|
Mr Peter Ewan Morris | 06. Apr. 2016 | Tenens House Kingfisher Business Park GL5 2BY London Road Thrupp Stroud | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
|
Hat TENENS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 01. Sept. 2016 Geliefert am 12. Sept. 2016 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung F/H land comprising europa industrial park radway road swindon (t/no' WT89913, WT134153, WT25597 and WT211927). Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 25. Sept. 2014 Geliefert am 30. Sept. 2014 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung T/No WT89913, WT134153, WT25597 and WT211927. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 07. Nov. 2013 Geliefert am 13. Nov. 2013 | Ausstehend | ||
Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 15. Sept. 2008 Geliefert am 24. Sept. 2008 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property at europa industrial park radway road sutton st margaret swindon t/nos. WT134153 WT25597 WT211927 WT89913. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage deed | Erstellt am 28. Apr. 2004 Geliefert am 29. Apr. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a or being land at europia industrial park stratton st margaret swindon t/n WT211927. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & debenture | Erstellt am 10. März 2004 Geliefert am 18. März 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & debenture | Erstellt am 01. Juli 2003 Geliefert am 08. Juli 2003 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 28. Jan. 2002 Geliefert am 01. Feb. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land at europa industrial park stratton st margaret swindon t/no.WT89913. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Keyman insurance assignment | Erstellt am 10. Okt. 1997 Geliefert am 11. Okt. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All right title benefit and interest in and to the policy and all monies (including profits and bonuses) which shall become payable thereunder. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Keyman insurance assignment | Erstellt am 30. Juni 1997 Geliefert am 10. Juli 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Assigns all right title benefit interest of the company in and to the policy being the allied dunbar assurance PLC policy of insurance dated 26/6/97 policy number 29255-102-das and all monies (including profits and bonuses) payable thereunder. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 30. Juni 1997 Geliefert am 10. Juli 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land and buildings erected thereon being land at europa industrial park stratton st margaret swindon wiltshire t/n WT89913. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed and floating charge | Erstellt am 17. Feb. 1994 Geliefert am 05. März 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 10TH february 1994 or any security document (as defined) | |
Kurze Angaben Land at europa industrial park, stratton st margaret, swindon, wiltshire t/no: wt 89913. undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0