TECH123 LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTECH123 LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02814155
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von TECH123 LIMITED?

    • (7220) /
    • (7310) /
    • (7420) /

    Wo befindet sich TECH123 LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o KROLL LIMITED
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von TECH123 LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    NALLATECH LIMITED30. Apr. 199330. Apr. 1993

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TECH123 LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Apr. 2006

    Welche sind die letzten Einreichungen für TECH123 LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    3 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Okt. 2010

    6 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 28. Apr. 2010

    5 Seiten4.68

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    14 Seiten2.34B

    Ergebnis der Gläubigerversammlung

    19 Seiten2.23B

    Vorschlag des Verwalters

    18 Seiten2.17B

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    3 Seiten403a

    legacy

    3 Seiten403a

    legacy

    3 Seiten403a

    legacy

    3 Seiten403a

    legacy

    3 Seiten403a

    legacy

    3 Seiten403a

    legacy

    3 Seiten403a

    legacy

    3 Seiten403a

    legacy

    3 Seiten403a

    legacy

    3 Seiten403a

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    Wer sind die Geschäftsführer von TECH123 LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GILCHRIST, John
    The Chimes
    7 Birkdale Wood, Westerwood
    G68 0GY Cumbernauld
    Geschäftsführer
    The Chimes
    7 Birkdale Wood, Westerwood
    G68 0GY Cumbernauld
    Gb-SctScottish100819670001
    CANTLE, Sarah Caroline
    17 Gullane Crescent Westerwood
    Cumbernauld
    G68 0HR Glasgow
    Sekretär
    17 Gullane Crescent Westerwood
    Cumbernauld
    G68 0HR Glasgow
    British43723390001
    FREELAND, George Keith
    37 Ravelrig Gait
    EH14 7NH Balerno
    Midlothian
    Sekretär
    37 Ravelrig Gait
    EH14 7NH Balerno
    Midlothian
    British809960009
    GILCHRIST, John
    The Chimes
    7 Birkdale Wood, Westerwood
    G68 0GY Cumbernauld
    Sekretär
    The Chimes
    7 Birkdale Wood, Westerwood
    G68 0GY Cumbernauld
    Scottish100819670001
    NICHOLSON, Andrew Graham
    54 Claremont Gardens
    BS21 5BH Clevedon
    Avon
    Sekretär
    54 Claremont Gardens
    BS21 5BH Clevedon
    Avon
    British34197110002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ANDERSON, Craig Brian
    6 Clarendon Crescent
    EH4 1PT Edinburgh
    Midlothian
    Geschäftsführer
    6 Clarendon Crescent
    EH4 1PT Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish110947160001
    CANTLE, Allan
    Flat 1 14 Percival Road
    Clifton
    BS8 3LN Bristol
    Geschäftsführer
    Flat 1 14 Percival Road
    Clifton
    BS8 3LN Bristol
    British84570170002
    CANTLE, Sarah Caroline
    17 Gullane Crescent Westerwood
    Cumbernauld
    G68 0HR Glasgow
    Geschäftsführer
    17 Gullane Crescent Westerwood
    Cumbernauld
    G68 0HR Glasgow
    British43723390001
    DEVLIN, Malachy, Dr
    32 Overtoun Drive
    Rutherglen
    G73 2QD Glasgow
    Lanarkshire
    Geschäftsführer
    32 Overtoun Drive
    Rutherglen
    G73 2QD Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish52556120001
    FREELAND, George Keith
    37 Ravelrig Gait
    EH14 7NH Balerno
    Midlothian
    Geschäftsführer
    37 Ravelrig Gait
    EH14 7NH Balerno
    Midlothian
    United KingdomBritish809960009
    HUNT, Ian Spinks
    Oliver Villa
    Mayville Park
    EH42 1AH Dunbar
    East Lothian
    Geschäftsführer
    Oliver Villa
    Mayville Park
    EH42 1AH Dunbar
    East Lothian
    ScotlandBritish82263970001
    LEWANDOWSKI, Kenneth Macdonald Arthur
    5 Allanwater Gardens
    Bridge Of Allan
    FK9 4DW Stirling
    Stirlingshire
    Geschäftsführer
    5 Allanwater Gardens
    Bridge Of Allan
    FK9 4DW Stirling
    Stirlingshire
    ScotlandBritish14010460001
    NICHOLSON, John Mcallister
    Hopton Farm House
    Hopton, Hodnet
    TF9 3LE Market Drayton
    Shropshire
    Geschäftsführer
    Hopton Farm House
    Hopton, Hodnet
    TF9 3LE Market Drayton
    Shropshire
    British91072610002
    ROBERTSON, Iain Malcolm
    Merry Hills Cottage
    Merry Hills Lane
    RH14 0RB Loxwood
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Merry Hills Cottage
    Merry Hills Lane
    RH14 0RB Loxwood
    West Sussex
    United KingdomBritish30965630001
    RUTHERFORD, Colin
    4 Henderland Road
    EH12 6BB Edinburgh
    Midlothian
    Geschäftsführer
    4 Henderland Road
    EH12 6BB Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish39515100002

    Hat TECH123 LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 17. Apr. 2008
    Geliefert am 25. Apr. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • 3I Group PLC
    Transaktionen
    • 25. Apr. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Mai 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 17. Apr. 2008
    Geliefert am 25. Apr. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Sep Iib
    Transaktionen
    • 25. Apr. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Mai 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge debenture
    Erstellt am 17. Apr. 2008
    Geliefert am 25. Apr. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Sep Ii
    Transaktionen
    • 25. Apr. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Mai 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 12. Dez. 2007
    Geliefert am 19. Dez. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Sep Iib
    Transaktionen
    • 19. Dez. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Mai 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 12. Dez. 2007
    Geliefert am 19. Dez. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • 3I Group PLC
    Transaktionen
    • 19. Dez. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Mai 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 12. Dez. 2007
    Geliefert am 19. Dez. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Sep Ii
    Transaktionen
    • 19. Dez. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Mai 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge of deposit
    Erstellt am 25. März 2007
    Geliefert am 07. Apr. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The deposit initially of £15,000 credited to account designation 00104774 with the bank and any addition to that deposit and any deposit from time to time of any other currency description or designation which derives in whole or in part from or out of such initial deposit or account.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 07. Apr. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 24. Feb. 2006
    Geliefert am 10. März 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bridge Bank, National Association
    Transaktionen
    • 10. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juni 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Intellectual property security agreement
    Erstellt am 22. Feb. 2006
    Geliefert am 01. März 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right title and interest in to and under its intellectual property collateral including copyrights patents and trademarks being programmable power supply system patent no 6,897,677 method of providing power to field programmable gate array modules p/no 6,809,548 programmable power supply for field programmable gate array modules p/no 6,710,621 and techniques of using a high level programming language in defining functionality for programmable logic. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Etv Capital S.A.
    Transaktionen
    • 01. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 22. Feb. 2006
    Geliefert am 25. Feb. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Etv Capital S.A
    Transaktionen
    • 25. Feb. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Mai 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 11. Juni 2004
    Geliefert am 19. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • 3I Group PLC
    Transaktionen
    • 19. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Mai 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 11. Juni 2004
    Geliefert am 19. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Sep Ii
    Transaktionen
    • 19. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Mai 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 11. Juni 2004
    Geliefert am 19. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Sep Ii B
    Transaktionen
    • 19. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Mai 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 06. Okt. 2003
    Geliefert am 24. Okt. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transaktionen
    • 24. Okt. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 02 october 2001 and
    Erstellt am 20. Sept. 2001
    Geliefert am 05. Okt. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    All and whole the subjects known as and forming 1 napier park cumbernauld glasgow G67 title number DMB55463.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 05. Okt. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Juli 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 20. Sept. 2001
    Geliefert am 27. Sept. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 27. Sept. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat TECH123 LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    29. Apr. 2009Ende der Verwaltung
    07. Mai 2008Beginn der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Fraser James Gray
    Alhambra House
    45 Waterloo Street
    G2 6HS Glasgow
    Praktiker
    Alhambra House
    45 Waterloo Street
    G2 6HS Glasgow
    Alastair Paul Beveridge
    Zolfo Cooper
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praktiker
    Zolfo Cooper
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    2
    DatumTyp
    17. Feb. 2011Aufgelöst am
    29. Apr. 2009Beginn der Liquidation
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Fraser James Gray
    Alhambra House
    45 Waterloo Street
    G2 6HS Glasgow
    Praktiker
    Alhambra House
    45 Waterloo Street
    G2 6HS Glasgow
    Alastair Paul Beveridge
    Zolfo Cooper
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praktiker
    Zolfo Cooper
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0