POPLARS INVESTMENTS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnamePOPLARS INVESTMENTS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02816950
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von POPLARS INVESTMENTS LIMITED?

    • Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen

    Wo befindet sich POPLARS INVESTMENTS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    79 Caroline Street
    B3 1UP Birmingham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von POPLARS INVESTMENTS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    SPEEDEASY TRADING LIMITED11. Mai 199311. Mai 1993

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von POPLARS INVESTMENTS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Mai 2015

    Welche sind die letzten Einreichungen für POPLARS INVESTMENTS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    10 SeitenLIQ13

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Rutland House 148 Edmund Street Birmingham West Midlands B3 2FD zum 79 Caroline Street Birmingham B3 1UP am 05. Dez. 2016

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 21. Nov. 2016

    LRESSP

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Erfüllung der Belastung 028169500005 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 028169500004 vollständig

    1 SeitenMR04

    Jahresrückblick erstellt bis 11. Mai 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital22. Juni 2016

    Kapitalaufstellung am 22. Juni 2016

    • Kapital: GBP 1,500
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Mai 2015

    5 SeitenAA

    Eintragung der Belastung 028169500005, erstellt am 13. Jan. 2016

    7 SeitenMR01

    Eintragung der Belastung 028169500004, erstellt am 13. Jan. 2016

    12 SeitenMR01

    Erfüllung der Belastung 1 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 3 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 2 vollständig

    2 SeitenMR04

    Jahresrückblick erstellt bis 11. Mai 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital19. Juni 2015

    Kapitalaufstellung am 19. Juni 2015

    • Kapital: GBP 1,500
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Mai 2014

    7 SeitenAA

    Ernennung von Katherine Mary Southan als Direktor am 01. Juni 2014

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mrs Catherine Annison Averill als Direktor am 01. Juni 2014

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Carol Cooper als Geschäftsführer am 01. Juni 2014

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Howard William Lukeman als Sekretär am 01. Juni 2014

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Howard William Lukeman als Geschäftsführer am 01. Juni 2014

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 11. Mai 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital21. Mai 2014

    Kapitalaufstellung am 21. Mai 2014

    • Kapital: GBP 1,500
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Mai 2013

    9 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 11. Mai 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01

    Wer sind die Geschäftsführer von POPLARS INVESTMENTS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    AVERILL, Catherine Annison
    Christchurch Road
    SW14 7AF East Sheen
    56
    London
    England
    Geschäftsführer
    Christchurch Road
    SW14 7AF East Sheen
    56
    London
    England
    EnglandBritishDirector195358210001
    LUKEMAN, Matthew William
    Stockings Lane
    Upper Longdon
    WS15 1QF Rugeley
    Hillside
    Staffordshire
    England
    Geschäftsführer
    Stockings Lane
    Upper Longdon
    WS15 1QF Rugeley
    Hillside
    Staffordshire
    England
    EnglandBritishDirector71999250001
    SOUTHAN, Katherine Mary
    OX17 1DR Cropredy
    Cropredy Hill Farm
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    OX17 1DR Cropredy
    Cropredy Hill Farm
    Oxfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector195358360001
    LUKEMAN, Howard William
    Gorse Lane,
    WS14 9HQ Lichfield
    The Uplands, 12
    Staffordshire
    Sekretär
    Gorse Lane,
    WS14 9HQ Lichfield
    The Uplands, 12
    Staffordshire
    BritishCompany Director3806050003
    SKIDMORE, Colin James
    50 Overhill Road
    Chasetown
    WS7 8SU Burntwood
    Staffordshire
    Sekretär
    50 Overhill Road
    Chasetown
    WS7 8SU Burntwood
    Staffordshire
    British3856300001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    COOPER, Carol
    Knowle Lodge
    Knowle Lane
    WS14 9RB Lichfield
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Knowle Lodge
    Knowle Lane
    WS14 9RB Lichfield
    Staffordshire
    United KingdomBritishDirector45889660001
    COOPER, Michael John
    Knowle Lodge Knowle Lane
    WS14 9RB Lichfield
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Knowle Lodge Knowle Lane
    WS14 9RB Lichfield
    Staffordshire
    BritishCompany Director3806040001
    LUKEMAN, Howard William
    Gorse Lane,
    WS14 9HQ Lichfield
    The Uplands, 12
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Gorse Lane,
    WS14 9HQ Lichfield
    The Uplands, 12
    Staffordshire
    BritishCompany Director3806050003
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001

    Hat POPLARS INVESTMENTS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 13. Jan. 2016
    Geliefert am 27. Jan. 2016
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    The mortgagor with full title guarantee charges the property known as land at hermitage lane, mansfield, nottingham, NG18 5HE by way of legal mortgage.. For more details, please refer to the instrument.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Lancashire Mortgage Corporation Limited
    Transaktionen
    • 27. Jan. 2016Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 11. Nov. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 13. Jan. 2016
    Geliefert am 27. Jan. 2016
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    By way of legal mortgage, all freehold and leasehold property of the company now vested in it whether or not the title to it is registered at h m land registry including that which is described in the schedule to the debenture together with all buildings and fixtures (including trade and tenant's fixtures) now and subsequently on such property and all plant and machinery now and subsequently annexed to such property for whatever purpose.. By way of fixed charge all freehold and leasehold property subsequently belonging to the company together with all buildings and fixtures (including trade and tenant's fixtures) on such property and all plant and machinery annexed to such property for whatever purpose.. By way of fixed charge all interests not effectively charged by the preceding clauses of the debenture now or subsequently belonging to the company in or over the land or the proceeds of sale of land and all licences now or subsequently held by the company to enter upon or use land and the benefit of all other agreements relating to land to which the company is or may become party or otherwise entitled to all trade and tenant's fixtures plant and machinery now and subsequently annexed for whatever purpose to all freehold and leasehold property an interest in which stands charged under the debenture.. By way of fixed charge all patent, trade marks, patent applications, brand names, copyrights, rights in the nature of copyright, registered design and other intellectual property rights and agreements relating to the use by the company of patents and trade marks to which the company is now or may subsequently become entitled and all agreements under which the company is now or may become entitled to the payment of any royalty fee or similar income.. For more details please refer to the instrument.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Lancashire Mortgage Corporation Limited
    Transaktionen
    • 27. Jan. 2016Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 11. Nov. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Nov. 2002
    Geliefert am 15. Nov. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Premises on the west side of hermitage lane mansfield nottinghamshire t/no: NT173486. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 15. Nov. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Dez. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 27. Juli 1999
    Geliefert am 14. Aug. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a 74 high street, stourbridge. T/no WM573486.. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 14. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Dez. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 16. Juli 1999
    Geliefert am 21. Juli 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 21. Juli 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Dez. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)

    Hat POPLARS INVESTMENTS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    21. Nov. 2016Beginn der Liquidation
    23. Apr. 2018Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Roderick Graham Butcher
    79 Caroline Street
    B3 1UP Birmingham
    Praktiker
    79 Caroline Street
    B3 1UP Birmingham

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0