ANDREAS UGLAND & SONS (UK) LIMITED

ANDREAS UGLAND & SONS (UK) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameANDREAS UGLAND & SONS (UK) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02823248
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ANDREAS UGLAND & SONS (UK) LIMITED?

    • (9999) /

    Wo befindet sich ANDREAS UGLAND & SONS (UK) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    C/O Peachey & Co
    95 Aldwych
    WC2B 4JF London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von ANDREAS UGLAND & SONS (UK) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    UGLAND CAPITAL INVESTMENTS LIMITED20. Dez. 199520. Dez. 1995
    UGLAND CAPITAL LIMITED24. Sept. 199324. Sept. 1993
    INTERCEDE 1035 LIMITED02. Juni 199302. Juni 1993

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ANDREAS UGLAND & SONS (UK) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2008

    Welche sind die letzten Einreichungen für ANDREAS UGLAND & SONS (UK) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital05. Mai 2010

    Kapitalaufstellung am 05. Mai 2010

    • Kapital: GBP 1,147,002
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für John Dennis Hunter am 01. Mai 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Aldlex Limited am 01. Mai 2010

    2 SeitenCH04

    Änderung der Details des Direktors für Jane Elizabeth Fleming am 01. Mai 2010

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    6 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288c

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    7 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006

    7 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten363a

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005

    16 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    2 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    1 Seiten288b

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2004

    16 SeitenAA

    legacy

    7 Seiten363s

    legacy

    1 Seiten288c

    Wer sind die Geschäftsführer von ANDREAS UGLAND & SONS (UK) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ALDLEX LIMITED
    C/O Peachey & Co Llp
    95 Aldwych
    WC2B 4JF London
    95
    United Kingdom
    Sekretär
    C/O Peachey & Co Llp
    95 Aldwych
    WC2B 4JF London
    95
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer06889508
    90638820001
    FLEMING, Jane Elizabeth
    127 Whirlwind Drive
    George Town
    Grand Cayman Ky1-1202
    Cayman Islands
    Geschäftsführer
    127 Whirlwind Drive
    George Town
    Grand Cayman Ky1-1202
    Cayman Islands
    Cayman IslandsBritish117937270001
    HUNTER, John Dennis
    Antoinette Avenue
    Walkers Road
    George Town
    51
    Grand Cayman
    Cayman Islands
    Geschäftsführer
    Antoinette Avenue
    Walkers Road
    George Town
    51
    Grand Cayman
    Cayman Islands
    Cayman IslandsBritish1841920003
    BALFOUR, Michael Alan
    Penryn
    High Street, Flimwell
    TN5 7PB Wadhurst
    East Sussex
    Sekretär
    Penryn
    High Street, Flimwell
    TN5 7PB Wadhurst
    East Sussex
    British74717560001
    BLACK, Lawrence David
    4 Birch Grove
    AB31 5RG Banchory
    Kincardineshire
    Sekretär
    4 Birch Grove
    AB31 5RG Banchory
    Kincardineshire
    British80483100001
    PETTERSON, Lisbeth
    18 South Square
    Hampstead Garden Suburb
    NW11 7AL London
    Sekretär
    18 South Square
    Hampstead Garden Suburb
    NW11 7AL London
    Norwegian57444440003
    THOMAS, Marc Jeremy
    PO BOX 30130 Smb
    FOREIGN Grand Cayman
    Cayman Islands
    British West Indies
    Sekretär
    PO BOX 30130 Smb
    FOREIGN Grand Cayman
    Cayman Islands
    British West Indies
    British59586880001
    WATCHAM, Adrian Frank
    11 Old Wardsdown
    Flimwell
    TN5 7NN Wadhurst
    East Sussex
    Sekretär
    11 Old Wardsdown
    Flimwell
    TN5 7NN Wadhurst
    East Sussex
    British56804970001
    WATCHAM, Adrian Frank
    11 Old Wardsdown
    Flimwell
    TN5 7NN Wadhurst
    East Sussex
    Sekretär
    11 Old Wardsdown
    Flimwell
    TN5 7NN Wadhurst
    East Sussex
    British56804970001
    WOODHEAD, John Bertram
    12 Bavant Road
    Preston
    BN1 6RD Brighton
    East Sussex
    Sekretär
    12 Bavant Road
    Preston
    BN1 6RD Brighton
    East Sussex
    British1332840001
    MITRE SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Bevollmächtigter Sekretär
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    900004680001
    GILBERT, Stephen Bruce
    32 New Concordia Wharf
    Mill Street
    SE1 2BB London
    Geschäftsführer
    32 New Concordia Wharf
    Mill Street
    SE1 2BB London
    British44002970002
    GRIFFIN, Kenneth James
    214 Cyncoed Road
    Cyncoed
    CF2 6RS Cardiff
    Geschäftsführer
    214 Cyncoed Road
    Cyncoed
    CF2 6RS Cardiff
    British36597480001
    LOVE, John Patrick, Mr.
    The Walled Garden
    Church Path
    TQ12 5RZ Ipplepen
    Devon
    Geschäftsführer
    The Walled Garden
    Church Path
    TQ12 5RZ Ipplepen
    Devon
    United KingdomEnglish36599700003
    MARTIN, Miles Douglas Holland
    14 Somerset Road
    TW8 8BX Brentford
    Middlesex
    Geschäftsführer
    14 Somerset Road
    TW8 8BX Brentford
    Middlesex
    British44002940001
    PALMER, Jonathan David D`Urban
    PO BOX 31884 Smb
    Grand Cayman
    FOREIGN Cayman Islands
    British West Indies
    Geschäftsführer
    PO BOX 31884 Smb
    Grand Cayman
    FOREIGN Cayman Islands
    British West Indies
    South African60170800001
    PUGSLEY, Bruce John Middleton
    The Corner House Clarendon Gardens
    TN2 5LA Tunbridge Wells
    Kent
    Geschäftsführer
    The Corner House Clarendon Gardens
    TN2 5LA Tunbridge Wells
    Kent
    United KingdomBritish45877230001
    REEVES, Barbara
    Flat 2
    24 Bracknell Gardens
    NW3 7ED London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Flat 2
    24 Bracknell Gardens
    NW3 7ED London
    British900004670001
    THOMAS, Marc Jeremy
    PO BOX 30130 Smb
    FOREIGN Grand Cayman
    Cayman Islands
    British West Indies
    Geschäftsführer
    PO BOX 30130 Smb
    FOREIGN Grand Cayman
    Cayman Islands
    British West Indies
    British59586880001
    UGLAND, Andreas Ove
    Heathfield Park
    TN21 8RL Heathfield
    East Sussex
    Geschäftsführer
    Heathfield Park
    TN21 8RL Heathfield
    East Sussex
    Norwegian67325860002
    WATCHAM, Adrian Frank
    11 Old Wardsdown
    Flimwell
    TN5 7NN Wadhurst
    East Sussex
    Geschäftsführer
    11 Old Wardsdown
    Flimwell
    TN5 7NN Wadhurst
    East Sussex
    EnglandBritish56804970001
    WINDMILL, Robert John
    3 Gunter Grove
    SW10 0UN London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    3 Gunter Grove
    SW10 0UN London
    British900004660001

    Hat ANDREAS UGLAND & SONS (UK) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Novation and amendment agreement
    Erstellt am 01. Dez. 2003
    Geliefert am 17. Dez. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All of the right title and interest of the company in to and under the secondary put agreement and the secondary put and call option. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Leif Hoeg & Co. Shipping As
    Transaktionen
    • 17. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Novation and amendment agreement relating to a deed of assignment dated 20 march 2000
    Erstellt am 01. Dez. 2003
    Geliefert am 17. Dez. 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All of the right, title and interest, present and future, of the company in, to and under the secondary put agreement and the secondary put call option and all claims, rights and remedies of the company arising therefrom. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Leif Hoegh & Co. Shipping As
    Transaktionen
    • 17. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of assignment
    Erstellt am 20. März 2000
    Geliefert am 27. März 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to a tertiary put agreement dated 20 march 2000 (as defined)
    Kurze Angaben
    All right title and interest present and future all claims rights and remedies.
    Berechtigte Personen
    • Leif Hoegh & Co. Asa
    Transaktionen
    • 27. März 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of assignment
    Erstellt am 20. März 2000
    Geliefert am 27. März 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to a tertiary put agreement dated 20 march 2000 (as defined)
    Kurze Angaben
    All the right title and interest present and future all claims rights and remedies.
    Berechtigte Personen
    • Leif Hoegh & Co. Asa
    Transaktionen
    • 27. März 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of covenant
    Erstellt am 16. Nov. 1993
    Geliefert am 27. Nov. 1993
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due from the company to the chargee on an account current under the terms of the acqusition agreement dated 21/10/93
    Kurze Angaben
    All the companys interest in and to all the insurances in respect of the bahamian flag vessel hual rolita.
    Berechtigte Personen
    • Andreas Ugland Autoliners As
    Transaktionen
    • 27. Nov. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    First statutory mortgage
    Erstellt am 16. Nov. 1993
    Geliefert am 27. Nov. 1993
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due from the company to the chargee on an account current under the terms of the purchase agreement dated 21/10/93
    Kurze Angaben
    All the companys 64/64TH of the shares in the bahamian flag vessel hual rolita.
    Berechtigte Personen
    • Andreas Ugland Autoliners As
    Transaktionen
    • 27. Nov. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of covenant
    Erstellt am 16. Nov. 1993
    Geliefert am 27. Nov. 1993
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due from the company to the chargee on an account current under the terms of a loan agreement dated 21/10/93
    Kurze Angaben
    All the companys interest in the insurances and all benefits in respect of bahamian flag vessel hual rolita.
    Berechtigte Personen
    • Andreas Ugland & Sons a/S
    Transaktionen
    • 27. Nov. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    Second statutory mortgage
    Erstellt am 16. Nov. 1993
    Geliefert am 27. Nov. 1993
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due from the company to the chargee on an account current under a loan agreement dated 21/10/93
    Kurze Angaben
    All the companys 64/64TH of shares in the bahamian flag vessel hual rolita.
    Berechtigte Personen
    • Andreas Ugland & Sons a/S
    Transaktionen
    • 27. Nov. 1993Registrierung einer Belastung (395)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0