ANGLO FINANCE NO.2 LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ANGLO FINANCE NO.2 LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02825291 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ANGLO FINANCE NO.2 LIMITED?
- Finanzintermediation sonst. n.n.a. (64999) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Wo befindet sich ANGLO FINANCE NO.2 LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Meridian Trinity Square 23-59 Staines Road TW3 3HF Hounslow Middlesex |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ANGLO FINANCE NO.2 LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ANGLO FINANCE NO.2 LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 24. Sept. 2012
| 3 Seiten | SH01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Alicia Essex als Sekretär am 07. Sept. 2012 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Alicia Essex als Geschäftsführer am 07. Sept. 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Ann French am 01. Aug. 2012 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Juli 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Ernennung von Magdalena Koncikova als Direktor am 20. Sept. 2011 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Alicia Essex als Direktor am 20. Sept. 2011 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von William Hall Mcgibbon als Geschäftsführer am 20. Sept. 2011 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Darren Mark Millard als Geschäftsführer am 20. Sept. 2011 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Michael Jenkins als Geschäftsführer am 20. Sept. 2011 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Hugh Alan Taylor Fitzpatrick als Geschäftsführer am 20. Sept. 2011 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Juli 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 8 Seiten | AR01 | ||||||||||
Ernennung von Ann French als Sekretär | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Toby Ford als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Alicia Essex am 01. Jan. 2010 | 2 Seiten | CH03 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Alicia Essex am 20. Juli 2009 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Juli 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 9 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für John Michael Jenkins am 01. Jan. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ANGLO FINANCE NO.2 LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRENCH, Ann | Sekretär | Meridian Trinity Square 23-59 Staines Road TW3 3HF Hounslow Middlesex | 161409120001 | |||||||
| KONCIKOVA, Magdalena | Geschäftsführer | 23/59 Staines Road TW3 3HF Hounslow Meridian Trinity Square Middlesex United Kingdom | United Kingdom | Slovakian | 163324190001 | |||||
| ESSEX, Alicia | Sekretär | Trinity Square 23/59 Staines Road TW3 3HF Hounslow Meridian Middlesex | British | 55569560002 | ||||||
| GREGORY, Janet Ailsa | Sekretär | Eastwood Lodge Whitfield GL12 8EA Wotton Under Edge Gloucestershire | British | 54836580002 | ||||||
| LAWRENCE, William Sackville Gwynne | Sekretär | 7 Byam Street SW6 2RB London | British | 32571030001 | ||||||
| RYAN, Gerard Jude | Sekretär | 47 Kingsmead Road Tulse Hill SW2 3HY London | Irish | 32962580001 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| BABER, Jeremy David | Geschäftsführer | 94 Candwr Park Ponthir NP18 1HN Newport Gwent | British | 109606970001 | ||||||
| BARRATT, Simon James Knevett | Geschäftsführer | 33 Stadium Street SW10 0PU London | British | 25864760002 | ||||||
| BRAMHALL, John Robert | Geschäftsführer | 11 Stoke Hill Stoke Bishop BS9 1JL Bristol | British | 1020270002 | ||||||
| DHALIWAL, Harminder | Geschäftsführer | 5 Watson Close RG40 4YF Wokingham Berkshire | British | 80423030001 | ||||||
| ELLIS, Christopher | Geschäftsführer | 12 Lattimer Place Chiswick W4 2UA London | British | 52013970001 | ||||||
| ESSEX, Alicia | Geschäftsführer | 23-59 Staines Road TW3 3HF Hounslow Meridian Trinity Square Middlesex United Kingdom | United Kingdom | British | 155696080001 | |||||
| FIELDEN, David Shaw | Geschäftsführer | Kingsfield Old Midford Road BA2 7DH Bath | England | British | 8502310001 | |||||
| FITZPATRICK, Hugh Alan Taylor | Geschäftsführer | Trinity Square 23/59 Staines Road TW3 3HF Hounslow Meridian Middlesex England | United Kingdom | British | 139406230001 | |||||
| FORD, Toby Duncan | Geschäftsführer | Trinity Square 23/59 Staines Road TW3 3HF Hounslow Meridian Middlesex England | United Kingdom | British | 148654320001 | |||||
| GANE, Peter Anthony | Geschäftsführer | Herb Cottage 5 Red Pitt Dilton Marsh BA13 4BJ Westbury Wiltshire | British | 81248280001 | ||||||
| GIRARD, Sylvain Andre | Geschäftsführer | 9 Redcliffe Gardens 66 Grove Park Road W4 London | England | Canadian | 85777970002 | |||||
| GREEN, Richard William | Geschäftsführer | Richborough House Sandy Lane Sunningdale SL5 0ND Ascot Berkshire | British | 121346530001 | ||||||
| GREEN, Robert | Geschäftsführer | Tavistock Christ Church Road GU25 4PT Virginia Water Surrey | American | 79378980001 | ||||||
| GREGORY, Janet Ailsa | Geschäftsführer | Eastwood Lodge Whitfield GL12 8EA Wotton Under Edge Gloucestershire | British | 54836580002 | ||||||
| HUNTER GORDON, Christopher Neil | Geschäftsführer | 31 Alexander Street W2 5NV London | British | 1802880001 | ||||||
| HURST, Martin Peter | Geschäftsführer | 18 The Lawns Gotherington GL52 9QT Cheltenham Gloucestershire | British | 116377130001 | ||||||
| HURST, Tiffany | Geschäftsführer | Flat 6 24 Collingham Gardens SW5 0HN London | American | 94387970002 | ||||||
| IVERSEN, Arnold | Geschäftsführer | Hamilton House Blackwell Hall L Ane Leyhill HP5 1UN Chesham Buckinghamshire | British | 90729600001 | ||||||
| JENKINS, John Michael | Geschäftsführer | Trinity Square 23/59 Staines Road TW3 3HF Hounslow Meridian Middlesex England | England | British | 115008010001 | |||||
| JURRIES, Donald Lewis | Geschäftsführer | 12 Russell Close Regency Quay Chiswick W4 2NU London | American | 71266350001 | ||||||
| LAWRENCE, William Sackville Gwynne | Geschäftsführer | 7 Byam Street SW6 2RB London | United Kingdom | British | 32571030001 | |||||
| LEESMITH, Alan Eustace | Geschäftsführer | Bavelaw Copyhold Lane Cuckfield RH17 5EB Haywards Heath West Sussex | England | British | 5265930001 | |||||
| LOMAS, Paul John | Geschäftsführer | 12 Burwardsley Way Kingsmead CW9 8WN Northwich Cheshire | United Kingdom | British | 127596100001 | |||||
| MCCLELLAND, Lynn Fiona | Geschäftsführer | 85 St George Place Deanery Road BS1 5QH Bristol | British | 108053630001 | ||||||
| MCGIBBON, William Hall | Geschäftsführer | Trinity Square 23/59 Staines Road TW3 3HF Hounslow Meridian Middlesex England | United Kingdom | British | 131612680004 | |||||
| MCNAMARA, Mary Jane | Geschäftsführer | 96 Lake Rise RM1 4EE Gidea Park Essex | British | 69295880001 | ||||||
| MILLARD, Darren Mark | Geschäftsführer | Trinity Square 23/59 Staines Road TW3 3HF Hounslow Meridian Middlesex | United Kingdom | British | 148916890001 | |||||
| MORRIS, Gavin Peter | Geschäftsführer | 93 Reedley Road Westbury On Trym BS9 3TB Bristol | United Kingdom | British | 209898490001 |
Hat ANGLO FINANCE NO.2 LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Supplemental deed dated 31ST march 1995 | Erstellt am 31. März 1995 Geliefert am 07. Apr. 1995 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and the secured creditors ( as defined in the deed suplemental to the terms of the deed dated 15TH february 1994 and/or this deed | |
Kurze Angaben All the company's beneficial right title and interest present and future in ,to and under the receivables trust deed , andthe receivables trust in and to the receivables trust property and in and to all moneys ,right powers , and property whatsoever which may from time to time be distributed or derived from , or accrue on or relate to the receivables trust, .please see doc for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental deed | Erstellt am 30. Dez. 1994 Geliefert am 11. Jan. 1995 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a deed of charge dated 16TH september 1993 | |
Kurze Angaben All right, title, interest and benefit in the receivables trust deed and the receivables trust. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental deed | Erstellt am 30. Sept. 1994 Geliefert am 08. Okt. 1994 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a deed of charge dated 15TH february 1994 | |
Kurze Angaben All its beneficial right, title interest and benefit present and future in, to and under the receivables trust deed and the receivables trust. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental deed | Erstellt am 30. Juni 1994 Geliefert am 01. Juli 1994 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a deed of charge dated 15 february 1994 | |
Kurze Angaben All right title interest and benefit under the receivables trust deed and receivables trust and the maintenance trust and head lease agreements. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental deed | Erstellt am 31. März 1994 Geliefert am 15. Apr. 1994 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a deed of charge dated 15 february 1994 | |
Kurze Angaben All right title and interest and benefit under the receivables trust deed and receivables trust, the maintenance trust deed and the maintenance trust and the head lease agreements. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental deed | Erstellt am 16. Feb. 1994 Geliefert am 02. März 1994 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under and pursuant to the trust deed, the other transaction documents, the conditions, the notes, the coupons and the deed of charge | |
Kurze Angaben All right title and interest in the receivables trust deed the maintenance trust deed and head lease agreements. Floating charge over all undertaking property and assets including uncalled capital.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge | Erstellt am 15. Feb. 1994 Geliefert am 02. März 1994 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under and pursuant to the trust deed, the other transaction documents, the conditions, the notes, the coupons and the deed of charge | |
Kurze Angaben All right title and interest in the receivables trust deed the maintenance trust deed and the head lease agreements. Floating charge over all undertaking property and assets including uncalled capital.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0