NELLBUSH LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameNELLBUSH LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02828174
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von NELLBUSH LIMITED?

    • Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen

    Wo befindet sich NELLBUSH LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    2nd Floor 20 Thayer Street
    W1U 2DD London
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NELLBUSH LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Apr. 2020

    Welche sind die letzten Einreichungen für NELLBUSH LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2020

    9 SeitenAA

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    1 SeitenDS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 17. Juni 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Apr. 2019

    8 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 17. Juni 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Apr. 2018

    7 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 17. Juni 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Ungeprüfter Jahresabschluss, gekürzt, bis 30. Apr. 2017

    8 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 17. Juni 2017 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Apr. 2016

    3 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 17. Juni 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital19. Juli 2016

    Kapitalaufstellung am 19. Juli 2016

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Epsilon Real Estate Partners Ltd 5th Floor 95 Wigmore Street London W1U 1DL zum 2nd Floor 20 Thayer Street London W1U 2DD am 14. Juli 2016

    1 SeitenAD01

    Beendigung der Bestellung von Peter Salim David Khalastchi als Geschäftsführer am 29. Apr. 2016

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Paul Derek Couchman als Sekretär am 22. Apr. 2016

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Ephraim Menashi Frank Khalastchi als Geschäftsführer am 22. Apr. 2016

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Anthony Menashi Khalastchi als Geschäftsführer am 22. Apr. 2016

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Ashok Kumar Tanna als Sekretär am 22. Apr. 2016

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Peter Salim David Khalastchi als Sekretär am 22. Apr. 2016

    1 SeitenTM02

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Apr. 2015

    3 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 17. Juni 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    8 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital01. Juli 2015

    Kapitalaufstellung am 01. Juli 2015

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Apr. 2014

    3 SeitenAA

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Kendal House Conduit Street London W1S 2XA zum C/O Epsilon Real Estate Partners Ltd 5Th Floor 95 Wigmore Street London W1U 1DL am 17. Apr. 2015

    1 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 17. Juni 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    8 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital05. Aug. 2014

    Kapitalaufstellung am 05. Aug. 2014

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Wer sind die Geschäftsführer von NELLBUSH LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    COUCHMAN, Paul Derek
    20 Thayer Street
    W1U 2DD London
    2nd Floor
    England
    Sekretär
    20 Thayer Street
    W1U 2DD London
    2nd Floor
    England
    207450850001
    HATTER, Richard Mark
    Hamilton Terrace
    NW8 9UJ London
    54
    Geschäftsführer
    Hamilton Terrace
    NW8 9UJ London
    54
    United KingdomBritishChartered Surveyor67030840002
    CAMPBELL, Jennifer
    155 Victoria Street
    ME7 1EJ Gillingham
    Kent
    Sekretär
    155 Victoria Street
    ME7 1EJ Gillingham
    Kent
    British35444350001
    KHALASTCHI, Peter Salim David
    Flat 2 Oakley House
    103 Sloane Street
    SW1X 9PP London
    Sekretär
    Flat 2 Oakley House
    103 Sloane Street
    SW1X 9PP London
    BritishCompany Director105027750001
    KOOPS, Frederica Anne
    6 Upper Grosvenor Street
    W1X 9PA London
    Sekretär
    6 Upper Grosvenor Street
    W1X 9PA London
    British33585580001
    TANNA, Ashok Kumar
    Grove Farm Park
    HA6 2BQ Northwood
    12
    Middlesex
    Sekretär
    Grove Farm Park
    HA6 2BQ Northwood
    12
    Middlesex
    BritishAccountant98980620002
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Bevollmächtigter Sekretär
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    HOLY, Julian Robert
    33 Spencer Road
    W4 3SS Chiswick
    Greater London
    Geschäftsführer
    33 Spencer Road
    W4 3SS Chiswick
    Greater London
    United KingdomBritishSolicitor91517950001
    KHALASTCHI, Anthony Menashi
    Avenue Road
    NW8 6HR London
    59
    Geschäftsführer
    Avenue Road
    NW8 6HR London
    59
    United KingdomBritishCompany Director54709980002
    KHALASTCHI, Ephraim Menashi Frank
    Flat 65 Waterside Point
    2 Anhalt Road
    SW11 4PD London
    Geschäftsführer
    Flat 65 Waterside Point
    2 Anhalt Road
    SW11 4PD London
    EnglandBritishCompany Director56359120001
    KHALASTCHI, Peter Salim David
    Flat 2 Oakley House
    103 Sloane Street
    SW1X 9PP London
    Geschäftsführer
    Flat 2 Oakley House
    103 Sloane Street
    SW1X 9PP London
    United KingdomBritishCompany Director105027750001
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei NELLBUSH LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Mr Richard Mark Hatter
    20 Thayer Street
    W1U 2DD London
    2nd Floor
    England
    06. Apr. 2016
    20 Thayer Street
    W1U 2DD London
    2nd Floor
    England
    Nein
    Nationalität: British
    Staatsangehörigkeit: United Kingdom
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über die Aktivitäten einer Firma auszuüben oder übt diese tatsächlich aus, die nach dem Recht, das sie regelt, keine juristische Person ist; und die Mitglieder dieser Firma (in ihrer Eigenschaft als solche) haben das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder üben diese tatsächlich aus.

    Hat NELLBUSH LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal mortgage
    Erstellt am 06. Juli 2007
    Geliefert am 21. Juli 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H 131/132 upper street islington. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Juli 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 20. Juli 2005
    Geliefert am 21. Juli 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 7/8 the square & 1 princes street richmond surrey. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 22. Juni 2004
    Geliefert am 25. Juni 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a 199-205 richmond road, london fields, london. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 26. Jan. 2004
    Geliefert am 27. Jan. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The leasehold property known as 182-186 st john street clerkenwell london. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Jan. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Floating charge
    Erstellt am 28. Juni 2001
    Geliefert am 30. Juni 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Floating security over. Undertaking and all property and assets.
    Berechtigte Personen
    • The Co-Operative Bank P.L.C.
    Transaktionen
    • 30. Juni 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Assignment of rental income
    Erstellt am 28. Juni 2001
    Geliefert am 30. Juni 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the facility agreement,the charge (both terms as defined) and/or the assignment
    Kurze Angaben
    Land/blds known as 327-329 harrow rd,maida vale,london; t/no 337939;all rent guarantee right title and interest thereon and all sums received from any deposit and any profits,damages,etc. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Co-Operative Bank P.L.C.
    Transaktionen
    • 30. Juni 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of legal charge
    Erstellt am 28. Juni 2001
    Geliefert am 30. Juni 2001
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Freehold land and buildings being 327-329 harrow road maida vale london W9 t/n 337939. all fixtures and fittings and all fixed plant and machinery (not being chattels within the meaning of the bills of sale acts). A floating charge over all unfixed plant and machinery and other chattels and equipment and assigns the goodwill of the business carried on at or from the property and the benefit of the licence or certificate the right to recover and receive any compensation payable in respect of the licence or certificate.
    Berechtigte Personen
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Juni 2001Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 27. Apr. 2001
    Geliefert am 04. Mai 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    17-21 wyfold road london SW6 (f/h). With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Mai 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. Juli 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 18. Okt. 2000
    Geliefert am 21. Okt. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 500,500A,500B & 500C brixton road brixton london. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Okt. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Nov. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 06. Aug. 1999
    Geliefert am 07. Aug. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The junction 244 coldharbour lane and 2 belinda road brixton london f/H. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. Juli 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Floating charge
    Erstellt am 31. Juli 1998
    Geliefert am 12. Aug. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Floating security undertaking property assets and rights.
    Berechtigte Personen
    • Woolwich PLC
    Transaktionen
    • 12. Aug. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Juli 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Principal charge of rents
    Erstellt am 31. Juli 1998
    Geliefert am 12. Aug. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All rents in respect of 22 to 28 woodfield road and 327 329 harrow road london W9 first fixed charge all monies standing to the credit of the rent account.
    Berechtigte Personen
    • Woolwich PLC
    Transaktionen
    • 12. Aug. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Juli 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage deed
    Erstellt am 31. Juli 1998
    Geliefert am 12. Aug. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the mortgage or any offer of loan or on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    22 to 28 woodfield road and 327 329 harrow road london t/n 337939 benefit of all rental income. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • Woolwich PLC
    Transaktionen
    • 12. Aug. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Juli 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of rental assignment
    Erstellt am 19. Juni 1998
    Geliefert am 26. Juni 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All right title benefit and interest of the company in and to all rent, licence fees or other sums received by the company from any tenant or licensee of the property k/a 144 camden high street london-NGL468728.
    Berechtigte Personen
    • Bristol & West PLC
    Transaktionen
    • 26. Juni 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Juli 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Commercial mortgage
    Erstellt am 19. Juni 1998
    Geliefert am 24. Juni 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    144 camden high street london-NGL468728 together with all buildings and fixtures and fixed plant and machinery. The benefit of all guarantees indemnities rent deposits. By way of floating charge the undertaking and all other property assets and rights. Assigns the goodwill of the business and all monies due in relation to contracts or policies of insurance.
    Berechtigte Personen
    • Bristol & West PLC
    Transaktionen
    • 24. Juni 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Juli 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Commercial mortgage
    Erstellt am 19. Feb. 1998
    Geliefert am 20. Feb. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a 27 throgmorton street and 29 austin friars london t/no: NGL348895 together with all buildings and fixtures and fixed plant and machinery. The benefit of all guarantees indemnities rent deposits. By way of floating charge the undertaking and all other property assets and rights. Assigns the goodwill of the business and all monies due in relation to contracts or policies of insurance.
    Berechtigte Personen
    • Bristol & West PLC
    Transaktionen
    • 20. Feb. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Sept. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment by way of charge
    Erstellt am 28. Feb. 1997
    Geliefert am 19. März 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or any company from time to time which is a holding company or subsidiary of the company and any subsidiary undertaking or associate of any such company (group member) to the chargee as trustee for itself and the other lenders on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the rights titles benefits and interest and whether present or future of the company to all monies from time to time due owing or incurred to the company under the occupational lease/s in respect of hanover house hanover court matford business park exeter. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transaktionen
    • 19. März 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Sept. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of legal charge
    Erstellt am 28. Feb. 1997
    Geliefert am 19. März 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or any company from time to time which is a holding company or subsidiary of the company and any subsidiary undertaking or associate of any such company (group member) to the chargee as trustee for itself and the other lenders on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that l/h property k/a site f matford business park lying to the north of mutton lane marsh barton exeter devon t/no.DN259632 together with all buildings erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants' fixtures) and fitting thereon. All monies deposited with the trustee. By way of floating charge the whole of the company's property assets rights and revenues present and future including uncalled share capital (if any). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transaktionen
    • 19. März 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Sept. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage deed
    Erstellt am 11. Aug. 1994
    Geliefert am 12. Aug. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buildings on the south and east side of bellots road twerton bath and 33 high street sheffield south yorkshire with all buildings structures and fixtures fixed plant and machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • Bristol & West Building Society
    Transaktionen
    • 12. Aug. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Sept. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Aug. 1993
    Geliefert am 24. Aug. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H-33 high street sheffield south yorkshire t/n-SYK240715, together with all fixtures and fittings and the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties (for full details see form 395).
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Aug. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Feb. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0