CHRISTIE BROCKBANK SHIPTON LIMITED

CHRISTIE BROCKBANK SHIPTON LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCHRISTIE BROCKBANK SHIPTON LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02829315
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CHRISTIE BROCKBANK SHIPTON LIMITED?

    • (6603) /

    Wo befindet sich CHRISTIE BROCKBANK SHIPTON LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Unit C25 Jacks Place
    6 Corbet Place
    E1 6NN London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CHRISTIE BROCKBANK SHIPTON LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    HARILD LIMITED22. Juni 199322. Juni 1993

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CHRISTIE BROCKBANK SHIPTON LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2008

    Welche sind die letzten Einreichungen für CHRISTIE BROCKBANK SHIPTON LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Kapitalaufstellung am 12. Feb. 2010

    • Kapital: GBP 1
    4 SeitenSH19

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Re dividend 09/12/2009
    RES13

    legacy

    1 SeitenSH20

    legacy

    2 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    4 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06
    capital

    Beschlüsse

    Share prem a/c cancelled 09/12/2009
    RES13

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    8 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    8 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288c

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006

    9 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005

    9 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    2 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2004

    9 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten363s

    Wer sind die Geschäftsführer von CHRISTIE BROCKBANK SHIPTON LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    FOX, Andrew Staley
    4 Dukes Road
    RH16 2JH Haywards Heath
    West Sussex
    Sekretär
    4 Dukes Road
    RH16 2JH Haywards Heath
    West Sussex
    British43073160004
    HARBORD-HAMOND, Charles Anthony Assheton
    45 Alderbrook Road
    SW12 8AD London
    Geschäftsführer
    45 Alderbrook Road
    SW12 8AD London
    United KingdomBritish56874210004
    CRAWFORD SMITH, Neil Leslie
    11 Manor Rise
    ME14 4DB Bearsted
    Kent
    Sekretär
    11 Manor Rise
    ME14 4DB Bearsted
    Kent
    British97197960001
    MCMULLEN, Gerald Phipps
    Little Broomhall Warnham
    RH12 3PA Horsham
    West Sussex
    Sekretär
    Little Broomhall Warnham
    RH12 3PA Horsham
    West Sussex
    British19668600001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Bevollmächtigter Sekretär
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    ADAMS, Nicholas Henry Harvey
    Hollies Farm Postland
    Crowland
    PE6 0LS Peterborough
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    Hollies Farm Postland
    Crowland
    PE6 0LS Peterborough
    Cambridgeshire
    EnglandBritish20992130001
    BENNETT, Fiona Marie Therese
    29 Little Adelphi
    10 John Adam Street
    WC2N 6HA London
    Geschäftsführer
    29 Little Adelphi
    10 John Adam Street
    WC2N 6HA London
    British39511970004
    BOLES, Timothy Coleridge
    Glen Wyllin Lodge
    IM6 1AN Kirk Michael
    Isle Of Man
    Geschäftsführer
    Glen Wyllin Lodge
    IM6 1AN Kirk Michael
    Isle Of Man
    British79557230001
    BROWNE, Jeremy Charles
    The Dower House
    Higher Houghton
    DT11 0PG Blandford
    Dorset
    Geschäftsführer
    The Dower House
    Higher Houghton
    DT11 0PG Blandford
    Dorset
    British41584900001
    BUNTING, Gerald Nigel
    22 Endlesham Road
    SW12 8JU London
    Geschäftsführer
    22 Endlesham Road
    SW12 8JU London
    British60546830002
    BURLEY, Yvonne Mary
    8 Anchor Brewhouse
    Shad Thames
    SE1 2LY London
    Geschäftsführer
    8 Anchor Brewhouse
    Shad Thames
    SE1 2LY London
    British41660180001
    CASTELL, Andrew Sean
    13 Chantry Street
    N1 8NR London
    Geschäftsführer
    13 Chantry Street
    N1 8NR London
    British85990150001
    DAMBRUMENIL, Nicholas John
    3 West Halkin Street
    Belgrave Square
    SW1 8JJ London
    Geschäftsführer
    3 West Halkin Street
    Belgrave Square
    SW1 8JJ London
    British52075430001
    DUNCAN, James Douglas Denoon
    52 Foxbourne Road
    SW17 8EW London
    Geschäftsführer
    52 Foxbourne Road
    SW17 8EW London
    British36290520002
    EWART, David John
    Courthill House
    Potterne
    SN10 5PN Devizes
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    Courthill House
    Potterne
    SN10 5PN Devizes
    Wiltshire
    United KingdomBritish23635320001
    HARBORD-HAMOND, Emma Louise
    4 Lysias Road
    SW12 8BP London
    Geschäftsführer
    4 Lysias Road
    SW12 8BP London
    British30320080004
    HOLBECH, Timothy Hugh
    64 Geraldine Road
    SW18 2NL London
    Geschäftsführer
    64 Geraldine Road
    SW18 2NL London
    British19390190001
    HOLLAND, Michael Reid
    Hornbeam Wood
    Broad Oak
    TN21 8TU Heathfield
    East Sussex
    Geschäftsführer
    Hornbeam Wood
    Broad Oak
    TN21 8TU Heathfield
    East Sussex
    British4241660001
    LEE, Michael Alan
    4 Wilona Avenue
    North Sydney
    FOREIGN Nsw
    2060
    Australia
    Geschäftsführer
    4 Wilona Avenue
    North Sydney
    FOREIGN Nsw
    2060
    Australia
    Australian92794500001
    MARTIN, Ian Paul
    152 Elborough Street
    SW18 5DL London
    Geschäftsführer
    152 Elborough Street
    SW18 5DL London
    British31010770001
    PYM, Francis Leslie, The Rt Hon Lord
    Everton Park
    SG19 2DE Sandy
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    Everton Park
    SG19 2DE Sandy
    Bedfordshire
    British2443220001
    RITSON, William Alexander
    The Well House
    Easton Maudit
    NN29 7NR Wellingborough
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    The Well House
    Easton Maudit
    NN29 7NR Wellingborough
    Northamptonshire
    UkBritish55793260001
    SHIPTON, John Keith
    Little Beadles
    Kings Avenue, Sandwich Bay
    CT13 9PG Sandwich
    Kent
    Geschäftsführer
    Little Beadles
    Kings Avenue, Sandwich Bay
    CT13 9PG Sandwich
    Kent
    EnglandBritish65780490001
    SPARROW, Andrew James
    Eye Kettleby Hall
    LE14 2TS Melton Mowbray
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Eye Kettleby Hall
    LE14 2TS Melton Mowbray
    Leicestershire
    EnglandBritish19390170004
    STEAD, Jacqueline Anne
    Aspen Copse
    BR1 2NZ Bromley
    10
    Kent
    Geschäftsführer
    Aspen Copse
    BR1 2NZ Bromley
    10
    Kent
    British24630990002
    STEVENS, George Edward
    Millers Green Hall
    Millers Green
    CM5 0PZ Ongar
    Essex
    Geschäftsführer
    Millers Green Hall
    Millers Green
    CM5 0PZ Ongar
    Essex
    United KingdomBritish1508480001
    WATSON, Michael John Bannatyne
    3 Edenhurst Avenue
    SW6 3PD London
    Geschäftsführer
    3 Edenhurst Avenue
    SW6 3PD London
    British64292610002
    WHITE, Graham John
    Toad Hall Glebe House
    38 High Street Melbourn
    SG8 6DZ Royston
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Toad Hall Glebe House
    38 High Street Melbourn
    SG8 6DZ Royston
    Hertfordshire
    EnglandBritish116735630001
    WOOD, Alistair Thomas
    2 Chesterfield Grove
    East Dulwich
    SE22 8RW London
    Geschäftsführer
    2 Chesterfield Grove
    East Dulwich
    SE22 8RW London
    British56593860001
    COMBINED NOMINEES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    900000090001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001

    Hat CHRISTIE BROCKBANK SHIPTON LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of assignment by way of legal charge
    Erstellt am 21. Aug. 1997
    Geliefert am 23. Aug. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The sum representing (I) the amount by which the payment of preferential dividend in respect of the 1996 underwriting year of account shall fall short of the amount resulting from the operation of the calculation of preferential dividend set out in artcle 10 of the articles of association in respect of that underwriting year of account plus (ii) such additional amount as shall be required to be added to the amount in (I) so that the net amount received by the seller after the deduction of corporation tax at the rate in force on that date payable by the seller will be equal to the amount (I) above
    Kurze Angaben
    All right title and interest in and to the profit commission payable to cbs in respect of the 1996 underwriting year of account under the members agents agreement and all rights interest claims and causes of action in respect thereof.
    Berechtigte Personen
    • Mah PLC
    Transaktionen
    • 23. Aug. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Juni 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assignment by way of legal charge
    Erstellt am 21. Aug. 1997
    Geliefert am 23. Aug. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The sum representing (I) the amount by which the payment of preferential dividend in respect of the 1994 underwriting year of account shall fall short of the amount resulting from the operation of the calculation of preferential dividend set out in artcle 10 of the articles of association in respect of that underwriting year of account plus (ii) such additional amount as shall be required to be added to the amount in (I) so that the net amount received by the seller after the deduction of corporation tax at the rate in force on that date payable by the seller will be equal to the amount (I) above
    Kurze Angaben
    All right title and interest in and to the profit commission payable to cbs in respect of the 1994 underwriting year of account under the members agents agreement and all rights interest claims and causes of action in respect thereof.
    Berechtigte Personen
    • Mah PLC
    Transaktionen
    • 23. Aug. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Juni 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assignment by way of legal charge
    Erstellt am 21. Aug. 1997
    Geliefert am 23. Aug. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The sum representing (I) the amount by which the payment of preferential dividend in respect of the 1995 underwriting year of account shall fall short of the amount resulting from the operation of the calculation of preferential dividend set out in artcle 10 of the articles of association in respect of that underwriting year of account plus (ii) such additional amount as shall be required to be added to the amount in (I) so that the net amount received by the seller after the deduction of corporation tax at the rate in force on that date payable by the seller will be equal to the amount (I) above
    Kurze Angaben
    All right title and interest in and to the profit commission payable to cbs in respect of the 1995 underwriting year of account under the members agents agreement and all rights interest claims and causes of action in respect thereof.
    Berechtigte Personen
    • Mah PLC
    Transaktionen
    • 23. Aug. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Juni 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of undertaking
    Erstellt am 18. Sept. 1996
    Geliefert am 08. Okt. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The balance from time to time remaining unpaid of the company's applicable proportion of the aggregate members' agents' proportion, together with any interest thereon, payable pursuant to a direction given on 17 july 1996 (as amended on 25 july 1996) by the council of lloyd's
    Kurze Angaben
    All right title benefit and interest of the company in and to all profit commission whether in existence at the date of execution of the deed of undertaking or coming into existence after the date thereof.
    Berechtigte Personen
    • The Society of Lloyd's
    Transaktionen
    • 08. Okt. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Apr. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0