CHRISTIE BROCKBANK SHIPTON LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CHRISTIE BROCKBANK SHIPTON LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02829315 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CHRISTIE BROCKBANK SHIPTON LIMITED?
- (6603) /
Wo befindet sich CHRISTIE BROCKBANK SHIPTON LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Unit C25 Jacks Place 6 Corbet Place E1 6NN London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CHRISTIE BROCKBANK SHIPTON LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| HARILD LIMITED | 22. Juni 1993 | 22. Juni 1993 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CHRISTIE BROCKBANK SHIPTON LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2008 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CHRISTIE BROCKBANK SHIPTON LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 12. Feb. 2010
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 4 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 8 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 8 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 9 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005 | 9 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2004 | 9 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363s | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CHRISTIE BROCKBANK SHIPTON LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOX, Andrew Staley | Sekretär | 4 Dukes Road RH16 2JH Haywards Heath West Sussex | British | 43073160004 | ||||||
| HARBORD-HAMOND, Charles Anthony Assheton | Geschäftsführer | 45 Alderbrook Road SW12 8AD London | United Kingdom | British | 56874210004 | |||||
| CRAWFORD SMITH, Neil Leslie | Sekretär | 11 Manor Rise ME14 4DB Bearsted Kent | British | 97197960001 | ||||||
| MCMULLEN, Gerald Phipps | Sekretär | Little Broomhall Warnham RH12 3PA Horsham West Sussex | British | 19668600001 | ||||||
| COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 900000080001 | |||||||
| ADAMS, Nicholas Henry Harvey | Geschäftsführer | Hollies Farm Postland Crowland PE6 0LS Peterborough Cambridgeshire | England | British | 20992130001 | |||||
| BENNETT, Fiona Marie Therese | Geschäftsführer | 29 Little Adelphi 10 John Adam Street WC2N 6HA London | British | 39511970004 | ||||||
| BOLES, Timothy Coleridge | Geschäftsführer | Glen Wyllin Lodge IM6 1AN Kirk Michael Isle Of Man | British | 79557230001 | ||||||
| BROWNE, Jeremy Charles | Geschäftsführer | The Dower House Higher Houghton DT11 0PG Blandford Dorset | British | 41584900001 | ||||||
| BUNTING, Gerald Nigel | Geschäftsführer | 22 Endlesham Road SW12 8JU London | British | 60546830002 | ||||||
| BURLEY, Yvonne Mary | Geschäftsführer | 8 Anchor Brewhouse Shad Thames SE1 2LY London | British | 41660180001 | ||||||
| CASTELL, Andrew Sean | Geschäftsführer | 13 Chantry Street N1 8NR London | British | 85990150001 | ||||||
| DAMBRUMENIL, Nicholas John | Geschäftsführer | 3 West Halkin Street Belgrave Square SW1 8JJ London | British | 52075430001 | ||||||
| DUNCAN, James Douglas Denoon | Geschäftsführer | 52 Foxbourne Road SW17 8EW London | British | 36290520002 | ||||||
| EWART, David John | Geschäftsführer | Courthill House Potterne SN10 5PN Devizes Wiltshire | United Kingdom | British | 23635320001 | |||||
| HARBORD-HAMOND, Emma Louise | Geschäftsführer | 4 Lysias Road SW12 8BP London | British | 30320080004 | ||||||
| HOLBECH, Timothy Hugh | Geschäftsführer | 64 Geraldine Road SW18 2NL London | British | 19390190001 | ||||||
| HOLLAND, Michael Reid | Geschäftsführer | Hornbeam Wood Broad Oak TN21 8TU Heathfield East Sussex | British | 4241660001 | ||||||
| LEE, Michael Alan | Geschäftsführer | 4 Wilona Avenue North Sydney FOREIGN Nsw 2060 Australia | Australian | 92794500001 | ||||||
| MARTIN, Ian Paul | Geschäftsführer | 152 Elborough Street SW18 5DL London | British | 31010770001 | ||||||
| PYM, Francis Leslie, The Rt Hon Lord | Geschäftsführer | Everton Park SG19 2DE Sandy Bedfordshire | British | 2443220001 | ||||||
| RITSON, William Alexander | Geschäftsführer | The Well House Easton Maudit NN29 7NR Wellingborough Northamptonshire | Uk | British | 55793260001 | |||||
| SHIPTON, John Keith | Geschäftsführer | Little Beadles Kings Avenue, Sandwich Bay CT13 9PG Sandwich Kent | England | British | 65780490001 | |||||
| SPARROW, Andrew James | Geschäftsführer | Eye Kettleby Hall LE14 2TS Melton Mowbray Leicestershire | England | British | 19390170004 | |||||
| STEAD, Jacqueline Anne | Geschäftsführer | Aspen Copse BR1 2NZ Bromley 10 Kent | British | 24630990002 | ||||||
| STEVENS, George Edward | Geschäftsführer | Millers Green Hall Millers Green CM5 0PZ Ongar Essex | United Kingdom | British | 1508480001 | |||||
| WATSON, Michael John Bannatyne | Geschäftsführer | 3 Edenhurst Avenue SW6 3PD London | British | 64292610002 | ||||||
| WHITE, Graham John | Geschäftsführer | Toad Hall Glebe House 38 High Street Melbourn SG8 6DZ Royston Hertfordshire | England | British | 116735630001 | |||||
| WOOD, Alistair Thomas | Geschäftsführer | 2 Chesterfield Grove East Dulwich SE22 8RW London | British | 56593860001 | ||||||
| COMBINED NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NA London | 900000090001 | |||||||
| COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 900000080001 |
Hat CHRISTIE BROCKBANK SHIPTON LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of assignment by way of legal charge | Erstellt am 21. Aug. 1997 Geliefert am 23. Aug. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The sum representing (I) the amount by which the payment of preferential dividend in respect of the 1996 underwriting year of account shall fall short of the amount resulting from the operation of the calculation of preferential dividend set out in artcle 10 of the articles of association in respect of that underwriting year of account plus (ii) such additional amount as shall be required to be added to the amount in (I) so that the net amount received by the seller after the deduction of corporation tax at the rate in force on that date payable by the seller will be equal to the amount (I) above | |
Kurze Angaben All right title and interest in and to the profit commission payable to cbs in respect of the 1996 underwriting year of account under the members agents agreement and all rights interest claims and causes of action in respect thereof. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of assignment by way of legal charge | Erstellt am 21. Aug. 1997 Geliefert am 23. Aug. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The sum representing (I) the amount by which the payment of preferential dividend in respect of the 1994 underwriting year of account shall fall short of the amount resulting from the operation of the calculation of preferential dividend set out in artcle 10 of the articles of association in respect of that underwriting year of account plus (ii) such additional amount as shall be required to be added to the amount in (I) so that the net amount received by the seller after the deduction of corporation tax at the rate in force on that date payable by the seller will be equal to the amount (I) above | |
Kurze Angaben All right title and interest in and to the profit commission payable to cbs in respect of the 1994 underwriting year of account under the members agents agreement and all rights interest claims and causes of action in respect thereof. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of assignment by way of legal charge | Erstellt am 21. Aug. 1997 Geliefert am 23. Aug. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The sum representing (I) the amount by which the payment of preferential dividend in respect of the 1995 underwriting year of account shall fall short of the amount resulting from the operation of the calculation of preferential dividend set out in artcle 10 of the articles of association in respect of that underwriting year of account plus (ii) such additional amount as shall be required to be added to the amount in (I) so that the net amount received by the seller after the deduction of corporation tax at the rate in force on that date payable by the seller will be equal to the amount (I) above | |
Kurze Angaben All right title and interest in and to the profit commission payable to cbs in respect of the 1995 underwriting year of account under the members agents agreement and all rights interest claims and causes of action in respect thereof. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of undertaking | Erstellt am 18. Sept. 1996 Geliefert am 08. Okt. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The balance from time to time remaining unpaid of the company's applicable proportion of the aggregate members' agents' proportion, together with any interest thereon, payable pursuant to a direction given on 17 july 1996 (as amended on 25 july 1996) by the council of lloyd's | |
Kurze Angaben All right title benefit and interest of the company in and to all profit commission whether in existence at the date of execution of the deed of undertaking or coming into existence after the date thereof. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0