INSTOX LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | INSTOX LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02831837 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von INSTOX LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich INSTOX LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O MAZARS LLP 1st Floor Two Chamberlain Square B3 3AX Birmingham |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von INSTOX LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für INSTOX LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 13 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Mazars Llp 45 Church Street Birmingham B3 2RT zum 1st Floor Two Chamberlain Square Birmingham B3 3AX am 22. Apr. 2021 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Lodge Way House Lodge Way Harlestone Road Northampton NN5 7UG zum C/O Mazars Llp 45 Church Street Birmingham B3 2RT am 23. Sept. 2020 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde auf Lodge Way House Lodge Way Harlestone Road Northampton NN5 7UG geändert | 2 Seiten | AD02 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Sept. 2020 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 8 Seiten | MA | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Kapitalaufstellung am 10. Dez. 2019
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Sept. 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jed Kenrick als Geschäftsführer am 24. Okt. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Sept. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Deborah Grimason als Geschäftsführer am 06. März 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Sept. 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Miss Deborah Grimason als Direktor am 18. Juli 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Alan Richard Williams als Direktor am 11. Juli 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von INSTOX LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPG MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Sekretär | Lodge Way Lodge Farm Industrial Estate NN5 7UG Northampton Lodge Way House England |
| 186000060001 | ||||||||||
| WILLIAMS, Alan Richard | Geschäftsführer | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom | United Kingdom | British | 137582690004 | |||||||||
| TP DIRECTORS LTD | Geschäftsführer | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom |
| 191205550001 | ||||||||||
| PAUL, Gordon James | Sekretär | 54 Ashlawn Crescent B91 1PS Solihull West Midlands | British | 5543700001 | ||||||||||
| WILKERSON, Gary Carl | Sekretär | Stargate Business Park Cuckoo Road B7 5SE Nechells Birmingham | American | 39529790002 | ||||||||||
| JORDAN COMPANY SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 21 St Thomas Street BS1 6JS Bristol Avon | 900008790001 | |||||||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
| BARRATT, Paul Richard | Geschäftsführer | Withy Close 52 Lovelace Avenue B91 3JR Solihull Birmingham | British | 39005280006 | ||||||||||
| BLACKMAN, Kevin James | Geschäftsführer | 21 Cowan Drive ST16 3FA Stafford | England | British | 8258440002 | |||||||||
| DARLEY, Denis | Geschäftsführer | 11 Coatham Vale Eaglescliffe TS16 0RA Stockton On Tees Cleveland | British | 35029220001 | ||||||||||
| DONOVAN, Patrick Wallace | Geschäftsführer | Long Acre College Street LE17 5BU Ullusthorpe Leicestershire | England | British | 89392800001 | |||||||||
| FIFER, Mike | Geschäftsführer | 3254 Pointe Hill Cove Memphis, Tn Shelby 38125 Usa | American | 107426090001 | ||||||||||
| GAJEWSKI, Tadeusz Stanislaw | Geschäftsführer | 20 Carham Road BB1 8NX Blackburn Lancashire | British | 31852300001 | ||||||||||
| GRIMASON, Deborah | Gesch äftsführer | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House | England | British | 185755960002 | |||||||||
| HAMBLETON, Lee Geoffrey | Geschäftsführer | Corndean Meadow Newdale TF3 5ET Telford 16 Shropshire Great Britain | United Kingdom | British | 136533060001 | |||||||||
| KENRICK, Jed | Geschäftsführer | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House England | United Kingdom | Nigerian | 192894990001 | |||||||||
| MARTIN, Jeffrey Andrew | Geschäftsführer | Stargate Business Park Cuckoo Road B7 5SE Nechells Birmingham | America | American | 173695510001 | |||||||||
| MCKEE, Kent Allan | Geschäftsführer | 2530 Guilford Court Germantown Tennessee Tn 38139 Usa | Usa | American | 51678590001 | |||||||||
| MILLERCHIP, Mark | Geschäftsführer | Stargate Business Park Cuckoo Road B7 5SE Nechells Birmingham | England | British | 78027140003 | |||||||||
| PAUL, Gordon James | Geschäftsführer | 54 Ashlawn Crescent B91 1PS Solihull West Midlands | England | British | 5543700001 | |||||||||
| PEARSON MYATT, April Louise | Geschäftsführer | The Garden House Sion Hill Court DY10 2YY Wolverley Worcs | United Kingdom | British | 80282950002 | |||||||||
| TALLENTIRE, Paul John | Geschäftsführer | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom | England | British | 134335900002 | |||||||||
| WALTERS, Colin Anthony | Geschäftsführer | Trevithick Close WS7 9LB Burntwood 11 Staffordshire | British | 53435770002 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei INSTOX LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brassware Sales Limited | 06. Apr. 2016 | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat INSTOX LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Legal mortgage | Erstellt am 16. Apr. 2004 Geliefert am 20. Apr. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Unit 2 capital point capital business park wentloog avenue cardiff. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Floating charge | Erstellt am 29. Juli 2002 Geliefert am 15. Aug. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of floating charge all the undertaking of the company and all assets whatsoever and wheresoever including stock in trade and uncalled capital but excluding any debts and associated rights relating thereto. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 29. Juli 2002 Geliefert am 03. Aug. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 27. März 1994 Geliefert am 15. Apr. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a unit 15 wokingham metro centre wokingham berkshire t/no BK263297 & the proceeds of sale with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 25. März 1994 Geliefert am 08. Apr. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat INSTOX LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0