CASTLEGATE 792 LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CASTLEGATE 792 LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Liquidation |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02832192 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CASTLEGATE 792 LIMITED?
- Andere Dienstleistungen n.a. (96090) / Sonstige Dienstleistungsbereiche
Wo befindet sich CASTLEGATE 792 LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 4th Floor 24 Old Bond Street Mayfair W1S 4AW London United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CASTLEGATE 792 LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| INDEPENDENT INSPECTIONS LIMITED | 01. Juli 1993 | 01. Juli 1993 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CASTLEGATE 792 LIMITED?
| Überfällig | Ja |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 30. Apr. 2021 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Apr. 2022 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Apr. 2020 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für CASTLEGATE 792 LIMITED?
| Überfällig | Ja |
|---|---|
| Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 01. Juli 2023 |
| Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 15. Juli 2023 |
| Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
| Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 01. Juli 2022 |
| Überfällig | Ja |
Welche sind die letzten Einreichungen für CASTLEGATE 792 LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 12. Dez. 2024 | 20 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Gold Round Limited als Geschäftsführer am 26. Sept. 2024 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 12. Dez. 2023 | 21 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stuart Pace als Geschäftsführer am 14. Dez. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Change of details for Castlegate 795 Limited as a person with significant control on 06. Jan. 2023 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 4th Floor Abbey House 32 Booth St Manchester M2 4AB zum 4th Floor 24 Old Bond Street Mayfair London W1S 4AW am 06. Jan. 2023 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Ground Floor, Egerton House 68 Baker Street Weybridge Surrey KT13 8AL United Kingdom zum 4th Floor Abbey House 32 Booth St Manchester M2 4AB am 22. Dez. 2022 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Vermögensübersicht | 8 Seiten | LIQ02 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
**Ein Teil des Eigentums oder Unternehmens wurde aus der Belastung entlassen ** 5 | 5 Seiten | MR05 | ||||||||||
**Ein Teil des Eigentums oder Unternehmens wurde aus der Belastung entlassen ** 028321920010 | 5 Seiten | MR05 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 028321920009 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 028321920011, erstellt am 31. Okt. 2022 | 27 Seiten | MR01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Juli 2022 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Change of details for Gold Round Limited as a person with significant control on 25. Juli 2022 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Change of details for Independent Inspections Holdings Limited as a person with significant control on 19. Apr. 2022 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed independent inspections LIMITED\certificate issued on 22/04/22 | 3 Seiten | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Stuart Pace am 21. Juli 2021 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Juli 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Apr. 2020 | 26 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Alan Albert Horton als Geschäftsführer am 30. Juni 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Juli 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Gold Round Limited am 09. Aug. 2019 | 1 Seiten | CH02 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Stuart Pace am 29. Juni 2020 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CASTLEGATE 792 LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJP SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 68 Baker Street KT13 8AL Weybridge Ground Floor, Egerton House Surrey United Kingdom |
| 61999120002 | ||||||||||
| DICKINSON, Louise | Sekretär | 6 Fulwood Park Caxton Road Fulwood PR2 9NZ Preston Lancashire | British | 139480580001 | ||||||||||
| POLLARD, Niall Mackinlay | Sekretär | 57 Royton Drive Whittle Le Woods PR6 7HJ Preston Lancashire | British | 176786520001 | ||||||||||
| WILLS, Debbie | Sekretär | 10 Whitecrest Avenue Pheasants Wood FY5 2AQ Thornton Cleveleys Lancashire | British | 35049700001 | ||||||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
| BARRETT, John | Geschäftsführer | 3 Rockfield Close TQ14 8TS Teignmouth Devon | United Kingdom | British | 118475070001 | |||||||||
| DICKINSON, Louise | Geschäftsführer | 6 Fulwood Park Caxton Road Fulwood PR2 9NZ Preston Lancashire | England | British | 139480580001 | |||||||||
| HORTON, Alan Albert | Geschäftsführer | 68 Baker Street KT13 8AL Weybridge Ground Floor, Egerton House Surrey United Kingdom | England | British | 182208240001 | |||||||||
| KNOWLES, Mark Andrew | Geschäftsführer | 79 Park Road PR7 1QZ Chorley Lancashire | British | 110093240002 | ||||||||||
| LEE, Peter Francis | Geschäftsführer | 6 Fulwood Park Caxton Road Fulwood PR2 9NZ Preston Lancashire | England | British | 207608120001 | |||||||||
| LEES, Stuart | Geschäftsführer | High Street KT7 0SR Thames Ditton 2 A C Court Surrey England | England | British | 70032700001 | |||||||||
| LLOYD JONES, Andrew Mark | Geschäftsführer | 6 Fulwood Park Caxton Road Fulwood PR2 9NZ Preston Lancashire | England | British | 180809810001 | |||||||||
| MAHONEY, Kevin David | Geschäftsführer | 6 Ferrymans Quay William Morris Way SW6 2UT London | United Kingdom | British | 63238350002 | |||||||||
| MAUDE, Simon David | Geschäftsführer | The Main Hall Rufford Park Lane Rufford L40 1XE Ormskirk 1 Lancashire | United Kingdom | British | 89719660003 | |||||||||
| MCINNES, Timothy Ian | Geschäftsführer | 34 Cumberland Drive Bowdon WA14 3QP Altrincham Cheshire | United Kingdom | British | 108973030002 | |||||||||
| NEWTON, Gordon | Geschäftsführer | 54 Teil Green Fulwood PR2 9PD Preston Lancashire | British | 110093300002 | ||||||||||
| PACE, Stuart | Geschäftsführer | 24 Old Bond Street Mayfair W1S 4AW London 4th Floor United Kingdom | England | British | 207506130003 | |||||||||
| POLLARD, Niall Mackinlay | Geschäftsführer | 6 Fulwood Park Caxton Road Fulwood PR2 9NZ Preston Lancashire | England | British | 176786520001 | |||||||||
| RAINES, Steven John | Geschäftsführer | 2 Castle Walk Penwortham PR1 0BP Preston Lancashire | British | 13506670002 | ||||||||||
| SMITH, Andrew John | Geschäftsführer | High Street KT7 0SR Thames Ditton 2 A C Court Surrey England | United Kingdom | British | 207506140001 | |||||||||
| THOMPSON, Peter David | Geschäftsführer | 21 Fleetwood Road FY6 7NU Poulton Le Fylde Lancashire | British | 15863610002 | ||||||||||
| VINCENT, Michael | Geschäftsführer | 23 Saint Aubyns's Avenue SW19 7BL London | England | British | 99258270001 | |||||||||
| WATKINS, Steven James | Geschäftsführer | Park Crescent TR11 2DL Falmouth 1 Cornwall United Kingdom | United Kingdom | British | 127928260002 | |||||||||
| WILLIS, Kathleen Jean | Geschäftsführer | 5 The Orchard Little Eccleston PR3 0YX Preston Lancashire | British | 61097710001 | ||||||||||
| WILLS, Stephen Robert | Geschäftsführer | Whitelodge 141 Hardhorn Road FY6 8ES Poulton Le Fylde Lancashire | United Kingdom | British | 35049690004 | |||||||||
| WITHEY, John Alfred | Geschäftsführer | 68 Honiley Drive B73 6RW Sutton Coldfield | British | 35049680001 | ||||||||||
| GOLD ROUND LIMITED | Geschäftsführer | 68 Baker Street KT13 8AL Weybridge Ground Floor, Egerton House Surrey England |
| 149588400001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CASTLEGATE 792 LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold Round Limited | 18. Apr. 2016 | 24 Old Bond Street Mayfair W1S 4AW London 4th Floor United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Castlegate 795 Limited | 06. Apr. 2016 | 24 Old Bond Street Mayfair W1S 4AW London 4th Floor United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat CASTLEGATE 792 LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 31. Okt. 2022 Geliefert am 07. Nov. 2022 | Ausstehend | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 01. Sept. 2016 Geliefert am 13. Sept. 2016 | Ausstehend | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 03. Juni 2016 Geliefert am 16. Juni 2016 | Vollständig erfüllt | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 18. Apr. 2016 Geliefert am 22. Apr. 2016 | Ausstehend | ||
Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A composite guarantee and debenture | Erstellt am 31. Jan. 2011 Geliefert am 08. Feb. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 26. Juni 2009 Geliefert am 02. Juli 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 26. Juni 2009 Geliefert am 30. Juni 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Accession deed | Erstellt am 18. Juli 2006 Geliefert am 20. Juli 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become from any chargor to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 07. Sept. 2004 Geliefert am 21. Sept. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Block 6 fulwood park (G2) caxton road north preston employment area preston lancashire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 18. Dez. 2002 Geliefert am 02. Jan. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 11. Nov. 1998 Geliefert am 24. Nov. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H 38, 44 & 46 avenham street preston lancashire-LA620828 & LA183448. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat CASTLEGATE 792 LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0