MBG EUROPE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMBG EUROPE LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02832871
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MBG EUROPE LIMITED?

    • Finanzintermediation sonst. n.n.a. (64999) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

    Wo befindet sich MBG EUROPE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    ALIXPARTNERS
    The Zenith Building 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von MBG EUROPE LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    TRIO EQUITY DERIVATIVES LTD.29. Dez. 199529. Dez. 1995
    MARTIN BIERBAUM EQUITY DERIVATIVES LIMITED15. Sept. 199315. Sept. 1993
    MARTIN BIERBAUM SECURITY DERIVATIVES LIMITED03. Aug. 199303. Aug. 1993
    LAWGRA (NO. 210) LIMITED05. Juli 199305. Juli 1993

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MBG EUROPE LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Sept. 2013

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für MBG EUROPE LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für MBG EUROPE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    17 Seiten4.72

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Cannon Bridge 25 Dowgate Hill London EC4R 2BB zum The Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester M2 1AB am 13. Apr. 2015

    2 SeitenAD01

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    6 Seiten4.20

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren am 20. März 2015

    LRESEX

    Beendigung der Bestellung von Eamonn William Bradley als Geschäftsführer am 03. Dez. 2014

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Eamonn William Bradley als Sekretär am 03. Dez. 2014

    1 SeitenTM02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2013

    14 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 22. Mai 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital23. Juni 2014

    Kapitalaufstellung am 23. Juni 2014

    • Kapital: GBP 875,000
    SH01

    Eintragung der Belastung 028328710006

    20 SeitenMR01

    Eintragung der Belastung 028328710007

    29 SeitenMR01

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed trio equity derivatives LTD.\certificate issued on 20/11/13
    3 SeitenCERTNM
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name20. Nov. 2013

    Beschluss zur Änderung der Firma am 20. Nov. 2013

    RES15
    change-of-name20. Nov. 2013

    Namensänderung durch Beschluss

    NM01

    Beendigung der Bestellung von Alan Farnan als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von David Caplin als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Stephen Welch als Direktor

    2 SeitenAP01

    Jahresrückblick erstellt bis 22. Mai 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2012

    12 SeitenAA

    Ernennung von Mr Eamonn William Bradley als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Eamonn William Bradley als Sekretär

    1 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Jeremy Kraft als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Jeremy Kraft als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Jahresrückblick erstellt bis 22. Mai 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2011

    12 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 22. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Wer sind die Geschäftsführer von MBG EUROPE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    WELCH, Stephen
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    The Zenith Building
    Geschäftsführer
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    The Zenith Building
    EnglandAustralian179384770001
    BRADLEY, Eamonn William
    Cannon Bridge
    25 Dowgate Hill
    EC4R 2BB London
    Sekretär
    Cannon Bridge
    25 Dowgate Hill
    EC4R 2BB London
    177013200001
    CLARKE, Matthew James Stanhope
    22 Hazlitt Road
    W14 0JY London
    Sekretär
    22 Hazlitt Road
    W14 0JY London
    British52586600001
    HERRTAGE, Andrew Mark
    20 Hamboro Gardens
    SS9 2NR Leigh On Sea
    Essex
    Sekretär
    20 Hamboro Gardens
    SS9 2NR Leigh On Sea
    Essex
    British70496290001
    KRAFT, Jeremy David
    27 Avenue Gardens
    TW11 0BH Teddington
    Middlesex
    Sekretär
    27 Avenue Gardens
    TW11 0BH Teddington
    Middlesex
    British71360190003
    THOMSON, John Stewart
    9 Upper Lattimore Road
    AL1 3UD St Albans
    Hertfordshire
    Sekretär
    9 Upper Lattimore Road
    AL1 3UD St Albans
    Hertfordshire
    British1644180002
    THOMSON, John Stewart
    37 Lemsford Road
    AL1 3PP St Albans
    Hertfordshire
    Sekretär
    37 Lemsford Road
    AL1 3PP St Albans
    Hertfordshire
    British1644180001
    LAWGRAM SECRETARIES LIMITED
    More London Riverside
    SE1 2AU London
    4
    Bevollmächtigter Sekretär
    More London Riverside
    SE1 2AU London
    4
    900004760001
    BRADLEY, Eamonn William
    Cannon Bridge
    25 Dowgate Hill
    EC4R 2BB London
    Geschäftsführer
    Cannon Bridge
    25 Dowgate Hill
    EC4R 2BB London
    United KingdomBritish177008470001
    CAPLIN, David Simon Montfort
    519 Ben Johnson House
    Barbican
    EC2Q 8DL London
    Geschäftsführer
    519 Ben Johnson House
    Barbican
    EC2Q 8DL London
    EnglandBritish104626850001
    CLARKE, Matthew James Stanhope
    22 Hazlitt Road
    W14 0JY London
    Geschäftsführer
    22 Hazlitt Road
    W14 0JY London
    EnglandBritish52586600001
    FARNAN, Alan Martin
    14 Roganstown Golf And Country Club
    Roganstown
    IRISH Swords
    County Dublin
    Geschäftsführer
    14 Roganstown Golf And Country Club
    Roganstown
    IRISH Swords
    County Dublin
    IrelandIrish88410720002
    HAGAN, David Lloyd
    Eastwoods
    Pitmore Lane
    SO41 6BW Sway
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Eastwoods
    Pitmore Lane
    SO41 6BW Sway
    Hampshire
    United KingdomBritish50541510001
    HERRTAGE, Andrew Mark
    20 Hamboro Gardens
    SS9 2NR Leigh On Sea
    Essex
    Geschäftsführer
    20 Hamboro Gardens
    SS9 2NR Leigh On Sea
    Essex
    United KingdomBritish70496290001
    KRAFT, Jeremy David
    27 Avenue Gardens
    TW11 0BH Teddington
    Middlesex
    Geschäftsführer
    27 Avenue Gardens
    TW11 0BH Teddington
    Middlesex
    United KingdomBritish71360190003
    LEVENE, Nicholas David Andrew
    The Briars
    Barnet Road
    EN5 3JZ Arkley
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    The Briars
    Barnet Road
    EN5 3JZ Arkley
    Hertfordshire
    British58316700003
    LEVENE, Nicholas David Andrew
    37 Alendale Avenue
    Finchley
    N3 8PY London
    Geschäftsführer
    37 Alendale Avenue
    Finchley
    N3 8PY London
    British58316700002
    REMME, Klaus
    Flat 105
    20 Abbey Road
    NW8 9BW London
    Geschäftsführer
    Flat 105
    20 Abbey Road
    NW8 9BW London
    Norwegian75540660001
    STEINBERG, Jonathan Charles
    25 Westholm
    NW11 6LH London
    Geschäftsführer
    25 Westholm
    NW11 6LH London
    British75540710001
    THOMSON, John Stewart
    37 Lemsford Road
    AL1 3PP St Albans
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    37 Lemsford Road
    AL1 3PP St Albans
    Hertfordshire
    British1644180001
    WHITTLE, David
    18 Osten Mews
    SW7 4HW South Kensington
    London
    Geschäftsführer
    18 Osten Mews
    SW7 4HW South Kensington
    London
    British84673020001
    WRIGHT, Simon Andrew
    23 Chancellor House
    Hyde Park Gate
    SW7 5DQ London
    Geschäftsführer
    23 Chancellor House
    Hyde Park Gate
    SW7 5DQ London
    British18573620001

    Hat MBG EUROPE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 29. Apr. 2014
    Geliefert am 06. Mai 2014
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    1. all registered or unregistered estates and interests in freehold and leasehold properties now or in the future owned by the obligors (as defined in the charge document) or in which the obligors have an interest from time to time; and. 2. any present or future interests (whether legal or equitable, and including the benefit of all licences) relating to any registered or unregistered trade marks, patents, copyrights, design rights, domain names, business names, confidential information, know-how and other intellectual property rights together with the rights to use any of the foregoing.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Sns Portfolio Limited
    Transaktionen
    • 06. Mai 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 29. Apr. 2014
    Geliefert am 06. Mai 2014
    Ausstehend
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Sns Portfolio Limited
    Transaktionen
    • 06. Mai 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    Composite guarantee and debentures
    Erstellt am 17. März 2008
    Geliefert am 25. März 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 25. März 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Accession agreement to the debenture
    Erstellt am 27. Juni 2005
    Geliefert am 07. Juli 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the principals (or any of them) to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Gresham LLP (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 07. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Accession agreement relating to composite guarantee and debenture dated 11 march 2005
    Erstellt am 27. Juni 2005
    Geliefert am 02. Juli 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due by the principals or any of them to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 02. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 10. Juni 2005
    Geliefert am 16. Juni 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due by the principals (or any of them) to the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee (For the Secured Parties)
    Transaktionen
    • 16. Juni 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Terms of business agreement
    Erstellt am 11. Nov. 1998
    Geliefert am 17. Nov. 1998
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All obligations of the company or any associate under the agreement and under any transaction or other obligation of the company to the chargee or any associate of the chargee
    Kurze Angaben
    With full title guarantee,by way of first,fixed charge and pledge over all deposits and margin and all securities,documents of or entering title to property,cash or other assets of any nature held by or subject to the control of ics (or any nominee or custodian of ics) for the account of the company.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Meespierson Ics Limited
    Transaktionen
    • 17. Nov. 1998Registrierung einer Belastung (395)

    Hat MBG EUROPE LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    20. März 2015Beginn der Liquidation
    07. Dez. 2015Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Anne Clare O'Keefe
    The Zenith Building 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Praktiker
    The Zenith Building 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Deborah Janet King
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praktiker
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0