MBG EUROPE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | MBG EUROPE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02832871 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MBG EUROPE LIMITED?
- Finanzintermediation sonst. n.n.a. (64999) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Wo befindet sich MBG EUROPE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | ALIXPARTNERS The Zenith Building 26 Spring Gardens M2 1AB Manchester |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von MBG EUROPE LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| TRIO EQUITY DERIVATIVES LTD. | 29. Dez. 1995 | 29. Dez. 1995 |
| MARTIN BIERBAUM EQUITY DERIVATIVES LIMITED | 15. Sept. 1993 | 15. Sept. 1993 |
| MARTIN BIERBAUM SECURITY DERIVATIVES LIMITED | 03. Aug. 1993 | 03. Aug. 1993 |
| LAWGRA (NO. 210) LIMITED | 05. Juli 1993 | 05. Juli 1993 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MBG EUROPE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2013 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für MBG EUROPE LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für MBG EUROPE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation | 17 Seiten | 4.72 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Cannon Bridge 25 Dowgate Hill London EC4R 2BB zum The Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester M2 1AB am 13. Apr. 2015 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular 4.19 | 6 Seiten | 4.20 | ||||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Eamonn William Bradley als Geschäftsführer am 03. Dez. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Eamonn William Bradley als Sekretär am 03. Dez. 2014 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2013 | 14 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 22. Mai 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Eintragung der Belastung 028328710006 | 20 Seiten | MR01 | ||||||||||||||
Eintragung der Belastung 028328710007 | 29 Seiten | MR01 | ||||||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed trio equity derivatives LTD.\certificate issued on 20/11/13 | 3 Seiten | CERTNM | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Alan Farnan als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Caplin als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Stephen Welch als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 22. Mai 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2012 | 12 Seiten | AA | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Eamonn William Bradley als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Eamonn William Bradley als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jeremy Kraft als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jeremy Kraft als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 22. Mai 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2011 | 12 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 22. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von MBG EUROPE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WELCH, Stephen | Geschäftsführer | 26 Spring Gardens M2 1AB Manchester The Zenith Building | England | Australian | 179384770001 | |||||
| BRADLEY, Eamonn William | Sekretär | Cannon Bridge 25 Dowgate Hill EC4R 2BB London | 177013200001 | |||||||
| CLARKE, Matthew James Stanhope | Sekretär | 22 Hazlitt Road W14 0JY London | British | 52586600001 | ||||||
| HERRTAGE, Andrew Mark | Sekretär | 20 Hamboro Gardens SS9 2NR Leigh On Sea Essex | British | 70496290001 | ||||||
| KRAFT, Jeremy David | Sekretär | 27 Avenue Gardens TW11 0BH Teddington Middlesex | British | 71360190003 | ||||||
| THOMSON, John Stewart | Sekretär | 9 Upper Lattimore Road AL1 3UD St Albans Hertfordshire | British | 1644180002 | ||||||
| THOMSON, John Stewart | Sekretär | 37 Lemsford Road AL1 3PP St Albans Hertfordshire | British | 1644180001 | ||||||
| LAWGRAM SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | More London Riverside SE1 2AU London 4 | 900004760001 | |||||||
| BRADLEY, Eamonn William | Geschäftsführer | Cannon Bridge 25 Dowgate Hill EC4R 2BB London | United Kingdom | British | 177008470001 | |||||
| CAPLIN, David Simon Montfort | Geschäftsführer | 519 Ben Johnson House Barbican EC2Q 8DL London | England | British | 104626850001 | |||||
| CLARKE, Matthew James Stanhope | Geschäftsführer | 22 Hazlitt Road W14 0JY London | England | British | 52586600001 | |||||
| FARNAN, Alan Martin | Geschäftsführer | 14 Roganstown Golf And Country Club Roganstown IRISH Swords County Dublin | Ireland | Irish | 88410720002 | |||||
| HAGAN, David Lloyd | Geschäftsführer | Eastwoods Pitmore Lane SO41 6BW Sway Hampshire | United Kingdom | British | 50541510001 | |||||
| HERRTAGE, Andrew Mark | Geschäftsführer | 20 Hamboro Gardens SS9 2NR Leigh On Sea Essex | United Kingdom | British | 70496290001 | |||||
| KRAFT, Jeremy David | Geschäftsführer | 27 Avenue Gardens TW11 0BH Teddington Middlesex | United Kingdom | British | 71360190003 | |||||
| LEVENE, Nicholas David Andrew | Geschäftsführer | The Briars Barnet Road EN5 3JZ Arkley Hertfordshire | British | 58316700003 | ||||||
| LEVENE, Nicholas David Andrew | Geschäftsführer | 37 Alendale Avenue Finchley N3 8PY London | British | 58316700002 | ||||||
| REMME, Klaus | Geschäftsführer | Flat 105 20 Abbey Road NW8 9BW London | Norwegian | 75540660001 | ||||||
| STEINBERG, Jonathan Charles | Geschäftsführer | 25 Westholm NW11 6LH London | British | 75540710001 | ||||||
| THOMSON, John Stewart | Geschäftsführer | 37 Lemsford Road AL1 3PP St Albans Hertfordshire | British | 1644180001 | ||||||
| WHITTLE, David | Geschäftsführer | 18 Osten Mews SW7 4HW South Kensington London | British | 84673020001 | ||||||
| WRIGHT, Simon Andrew | Geschäftsführer | 23 Chancellor House Hyde Park Gate SW7 5DQ London | British | 18573620001 |
Hat MBG EUROPE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 29. Apr. 2014 Geliefert am 06. Mai 2014 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung 1. all registered or unregistered estates and interests in freehold and leasehold properties now or in the future owned by the obligors (as defined in the charge document) or in which the obligors have an interest from time to time; and. 2. any present or future interests (whether legal or equitable, and including the benefit of all licences) relating to any registered or unregistered trade marks, patents, copyrights, design rights, domain names, business names, confidential information, know-how and other intellectual property rights together with the rights to use any of the foregoing. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A registered charge | Erstellt am 29. Apr. 2014 Geliefert am 06. Mai 2014 | Ausstehend | ||
Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debentures | Erstellt am 17. März 2008 Geliefert am 25. März 2008 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Accession agreement to the debenture | Erstellt am 27. Juni 2005 Geliefert am 07. Juli 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the principals (or any of them) to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Accession agreement relating to composite guarantee and debenture dated 11 march 2005 | Erstellt am 27. Juni 2005 Geliefert am 02. Juli 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due by the principals or any of them to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 10. Juni 2005 Geliefert am 16. Juni 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due by the principals (or any of them) to the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Terms of business agreement | Erstellt am 11. Nov. 1998 Geliefert am 17. Nov. 1998 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All obligations of the company or any associate under the agreement and under any transaction or other obligation of the company to the chargee or any associate of the chargee | |
Kurze Angaben With full title guarantee,by way of first,fixed charge and pledge over all deposits and margin and all securities,documents of or entering title to property,cash or other assets of any nature held by or subject to the control of ics (or any nominee or custodian of ics) for the account of the company.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat MBG EUROPE LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0