VIRGIN NET LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameVIRGIN NET LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02833330
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von VIRGIN NET LIMITED?

    • Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen

    Wo befindet sich VIRGIN NET LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von VIRGIN NET LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    VIRGIN.NET LIMITED23. Apr. 199623. Apr. 1996
    V-NET LIMITED12. Aug. 199412. Aug. 1994
    SPEED 3664 LIMITED30. Juli 199330. Juli 1993
    VIRGIN INTERACTIVE ENTERTAINMENT (EUROPE) LIMITED20. Juli 199320. Juli 1993
    SPEED 3664 LIMITED06. Juli 199306. Juli 1993

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von VIRGIN NET LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2016

    Welche sind die letzten Einreichungen für VIRGIN NET LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    9 SeitenLIQ13

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse Media House Bartley Wood Business Park Hook Hampshire RG27 9UP verlegt

    2 SeitenAD03

    Die Adresse der Registerinspektion wurde auf Media House Bartley Wood Business Park Hook Hampshire RG27 9UP geändert

    2 SeitenAD02

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Media House Bartley Wood Business Park Hook Hampshire RG27 9UP zum 1 More London Place London SE1 2AF am 30. Mai 2018

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    5 SeitenLIQ01

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 02. Mai 2018

    LRESSP

    Erfüllung der Belastung 6 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 7 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 9 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 8 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 028333300010 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 028333300012 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 028333300014 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 028333300011 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 028333300013 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 028333300015 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 028333300016 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 028333300017 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 028333300018 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 1 vollständig

    1 SeitenMR04

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    17 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 01. Aug. 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Notification of Virgin Media Limited as a person with significant control on 04. Juli 2017

    2 SeitenPSC02

    Wer sind die Geschäftsführer von VIRGIN NET LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    JAMES, Gillian Elizabeth
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Sekretär
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    British72139660003
    DUNN, Robert Dominic
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Geschäftsführer
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    EnglandBritish179134020002
    HIFZI, Mine Ozkan
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Geschäftsführer
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    EnglandBritish182167230001
    MOCKRIDGE, Thomas
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Geschäftsführer
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    United KingdomNew Zealander179145760002
    FLYNN, Roger Patrick
    43 Winslow Road
    Hammersmith
    W6 9SF London
    Sekretär
    43 Winslow Road
    Hammersmith
    W6 9SF London
    British66703670002
    GRAM, Peter Gerardus
    9 Lambyn Croft
    Langshott
    RH6 9XU Horley
    Surrey
    Sekretär
    9 Lambyn Croft
    Langshott
    RH6 9XU Horley
    Surrey
    British67245530001
    LEGGE, Diana Patricia
    24a Enderby Street
    SE10 9PF London
    Sekretär
    24a Enderby Street
    SE10 9PF London
    British66675910001
    MACKENZIE, Robert Mario
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    Sekretär
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    British101672720002
    ZAMET, Naomi Rae
    Flat 1 Merlin House Oak Hill Park
    Frognal Hampstead
    NW3 7LJ London
    Sekretär
    Flat 1 Merlin House Oak Hill Park
    Frognal Hampstead
    NW3 7LJ London
    British42158970002
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Bevollmächtigter Sekretär
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    BENNIE, Thomas Meikle
    Udimore Cottage 21 Chapel Lane
    Otterborne
    SO21 2HX Winchester
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Udimore Cottage 21 Chapel Lane
    Otterborne
    SO21 2HX Winchester
    Hampshire
    EnglandBritish113251400001
    BRANSON, Richard Charles Nicholas, Sir
    9 Holland Park
    W11 3TH London
    Geschäftsführer
    9 Holland Park
    W11 3TH London
    British39498750002
    BRANSON, Richard Charles Nicholas, Sir
    9 Holland Park
    W11 3TH London
    Geschäftsführer
    9 Holland Park
    W11 3TH London
    British39498750002
    BRENNAN, Sean Michael
    23 Savernake Road
    Hampstead
    NW3 2JT London
    Geschäftsführer
    23 Savernake Road
    Hampstead
    NW3 2JT London
    United KingdomBritish73918530001
    BURKE, Simon Paul
    35 Chepstow Place
    W2 4TT London
    Geschäftsführer
    35 Chepstow Place
    W2 4TT London
    United KingdomIrish30017870003
    BUTTERY, Paul Andrew
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United KingdomBritish185853570001
    CAMPBELL, David Lachlan
    Snapelands
    Lodsworth
    GU28 9DR Petworth
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Snapelands
    Lodsworth
    GU28 9DR Petworth
    West Sussex
    EnglandBritish58507320001
    CHANEY, Timothy Michael
    Wychwood Acres
    Bicester Road
    OX7 4NH Enstone Chipping Norton
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Wychwood Acres
    Bicester Road
    OX7 4NH Enstone Chipping Norton
    Oxfordshire
    British38000240001
    DALE, Alexander
    45 Portland Road
    W11 4LJ London
    Geschäftsführer
    45 Portland Road
    W11 4LJ London
    British68896950001
    DEVEREUX, Robert Harold Ferrers
    5 Ladbroke Terrace
    W11 3PG London
    Geschäftsführer
    5 Ladbroke Terrace
    W11 3PG London
    EnglandBritish68747470001
    GALE, Robert Charles
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    EnglandBritish96956740001
    GREGG, John Francis
    411 Silvermoss Drive
    Vero Beach
    Florida 32963
    America
    Geschäftsführer
    411 Silvermoss Drive
    Vero Beach
    Florida 32963
    America
    American75381740001
    IBBETT, Kenneth Richard Andre
    31 Aldridge Road Villas
    W11 1BN London
    Geschäftsführer
    31 Aldridge Road Villas
    W11 1BN London
    United KingdomBritish34929900001
    JOHNSON, David Graham Charles
    2 High Bridge Wharf
    High Bridge
    SE10 9PS London
    Geschäftsführer
    2 High Bridge Wharf
    High Bridge
    SE10 9PS London
    British79214400001
    KALIKA, Howard Seth
    5 Redburn Street
    SW3 4DA London
    Geschäftsführer
    5 Redburn Street
    SW3 4DA London
    American89166200002
    KNAPP, Barclay
    59 Battle Road
    Princeton
    08540 New Jersey
    08540
    Usa
    Geschäftsführer
    59 Battle Road
    Princeton
    08540 New Jersey
    08540
    Usa
    American41358150002
    MACKENZIE, Robert Mario
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    United KingdomBritish47785600002
    MCCALLUM, Gordon Douglas
    15 First Street
    SW3 2LB London
    Geschäftsführer
    15 First Street
    SW3 2LB London
    United KingdomBritish55294030006
    MCCALLUM, Gordon Douglas
    15 First Street
    SW3 2LB London
    Geschäftsführer
    15 First Street
    SW3 2LB London
    United KingdomBritish55294030006
    MCCALLUM, Gordon Douglas
    Flat 4 16 Rutland Gate
    SW7 1BB London
    Geschäftsführer
    Flat 4 16 Rutland Gate
    SW7 1BB London
    British55294030001
    STEELE, Alasdair Montgomerie
    8 Dovey Lodge
    Bewdley Street
    N1 1HG London
    Geschäftsführer
    8 Dovey Lodge
    Bewdley Street
    N1 1HG London
    British75966010001
    STRONG, Dana Mcdonald
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United KingdomAustralian183163490001
    TILLBROOK, Joanne Christine
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United KingdomBritish164134250001
    TILLBROOK, Joanne Christine
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United KingdomBritish164134250001
    TILLBROOK, Joanne Christine
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    United KingdomBritish164134250001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei VIRGIN NET LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    04. Juli 2017
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandEngland And Wales
    RechtsgrundlageUnited Kingdom (England And Wales)
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer2591237
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.
    Bartley Wood Business Park
    Bartley Way
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    England
    06. Apr. 2016
    Bartley Wood Business Park
    Bartley Way
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    England
    Ja
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandUnited Kingdom
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer4038930
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat VIRGIN NET LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 21. März 2017
    Geliefert am 23. März 2017
    Vollständig erfüllt
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch as Security Trustee
    Transaktionen
    • 23. März 2017Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 04. Mai 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 01. Feb. 2017
    Geliefert am 07. Feb. 2017
    Vollständig erfüllt
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch as Security Trustee
    Transaktionen
    • 07. Feb. 2017Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 04. Mai 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 26. Apr. 2016
    Geliefert am 27. Apr. 2016
    Vollständig erfüllt
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch as Security Trustee
    Transaktionen
    • 27. Apr. 2016Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 04. Mai 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 30. Apr. 2015
    Geliefert am 06. Mai 2015
    Vollständig erfüllt
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 06. Mai 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 04. Mai 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 30. März 2015
    Geliefert am 01. Apr. 2015
    Vollständig erfüllt
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 01. Apr. 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 04. Mai 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 28. Jan. 2015
    Geliefert am 06. Feb. 2015
    Vollständig erfüllt
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 06. Feb. 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 04. Mai 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 04. Apr. 2014
    Geliefert am 10. Apr. 2014
    Vollständig erfüllt
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 10. Apr. 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 04. Mai 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 28. März 2014
    Geliefert am 02. Apr. 2014
    Vollständig erfüllt
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 02. Apr. 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 04. Mai 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 07. Juni 2013
    Geliefert am 14. Juni 2013
    Vollständig erfüllt
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag,London Branch
    Transaktionen
    • 14. Juni 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 04. Mai 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Confirmation deed
    Erstellt am 03. März 2011
    Geliefert am 15. März 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the security trustee, all monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and all monies due or to become due from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The chargor acknowledges and agrees to the issuance of the new notes, the new guarantees and the new indenture and the transactions contemplated thereby and hereby confirms all payment and performance obligations contingent or otherwise and undertakings arising under or in connection with its respective agreements, guarantees, pledges and grants of liens under and subject to the terms of the liens, the group intercreditor agreement and each security document to which it is party. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 15. März 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 04. Mai 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Composite debenture
    Erstellt am 29. Juni 2010
    Geliefert am 08. Juli 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee, all monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and all monies due or to become due from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 08. Juli 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 04. Mai 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Confirmation deed
    Erstellt am 15. Apr. 2010
    Geliefert am 29. Apr. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) on any account whatosover under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The chargor acknowledges and agrees to the new sfa and the transactions contemplated thereby and confirm all payment and performance obligations contingent or otherwise and undertakings arising under or in connection with its respective agreements, guarantees, pledges and grants of encumbrances under and subject to the terms of the group intercreditor agreement and each security document to which it is party. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 29. Apr. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 04. Mai 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Composite debenture
    Erstellt am 19. Jan. 2010
    Geliefert am 22. Jan. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag London Branch (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 22. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 04. Mai 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Composite debenture
    Erstellt am 19. Jan. 2010
    Geliefert am 22. Jan. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag London Branch (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 22. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 28. Mai 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    An alternative bridge composite debenture
    Erstellt am 16. Juni 2006
    Geliefert am 29. Juni 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee and all monies due or to become due from the alternative bridge obligors (or any one or more of them) to the alternative bridge finance parties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch (As Alternative Bridge Trustee for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 29. Juni 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Dez. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite debenture
    Erstellt am 03. März 2006
    Geliefert am 10. März 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee, from the obligors (or any one or more of them) to the finance parties (or any one or more of them) on any account whatsoever, from all or any of the obligors to the restructuring swap counterparties and/or the existing hedge counter parties and to the new hedge counterparties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch (As Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 10. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Mai 2010Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 24. Mai 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 08. Nov. 2004
    Geliefert am 10. Nov. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors or any of them to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Credit Suisse First Boston
    Transaktionen
    • 10. Nov. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Apr. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 19. Apr. 1999
    Geliefert am 28. Apr. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee in accordance with the terms of a lease dated 19TH april 1999
    Kurze Angaben
    The balance credited to the interest bearing account opened in the name of the mortgagee with a bank or other institution of the mortgagees choosing wherein £250,000 plus vat is for the time being lodged. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • At&T (UK) LTD
    Transaktionen
    • 28. Apr. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Apr. 2018Erfüllung einer Belastung (MR04)

    Hat VIRGIN NET LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    25. Aug. 2019Aufgelöst am
    02. Mai 2018Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praktiker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Derek Hyslop
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praktiker
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0