ROYAL BANK PROJECT INVESTMENTS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | ROYAL BANK PROJECT INVESTMENTS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02834015 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ROYAL BANK PROJECT INVESTMENTS LIMITED?
- Finanzintermediation sonst. n.n.a. (64999) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Wo befindet sich ROYAL BANK PROJECT INVESTMENTS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 250 Bishopsgate EC2M 4AA London England |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ROYAL BANK PROJECT INVESTMENTS LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
DAYREPORT LIMITED | 07. Juli 1993 | 07. Juli 1993 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ROYAL BANK PROJECT INVESTMENTS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2015 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ROYAL BANK PROJECT INVESTMENTS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 7 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 30. Juli 2018 | 11 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 6 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 135 Bishopsgate London EC2M 3UR zum 250 Bishopsgate London EC2M 4AA am 17. März 2017 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 4 vollständig | 6 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 2 vollständig | 9 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 3 vollständig | 6 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 6 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 1 vollständig | 6 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 8 Seiten | MR04 | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 06. Sept. 2016 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 7 Seiten | MR04 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 20. Mai 2016
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Sept. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Rbs Secretarial Services Limited als Sekretär am 08. Dez. 2014 | 2 Seiten | AP04 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Elizabeth Lynxwiler als Sekretär am 08. Dez. 2014 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ROYAL BANK PROJECT INVESTMENTS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBS SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Sekretär | St Andrew Square EH2 1AF Edinburgh 24/25 Scotland |
| 169073830001 | ||||||||||
CATO, Guy Howard | Geschäftsführer | 135 Bishopsgate EC2M 3UR London 7th Floor | England | British | Bank Official | 167340790001 | ||||||||
IRISH, Matthew Edward Alphage | Geschäftsführer | EC2M 4AA London 250 Bishopsgate England | England | British | Bank Official | 191076550001 | ||||||||
FLETCHER, Rachel Elizabeth | Sekretär | Steerforth Street Earlsfield SW18 4HF London 31a United Kingdom | British | 106745220004 | ||||||||||
LEA, John Albert | Sekretär | 9 Elderberry Gardens CM8 2PT Witham Essex | British | Secretary | 1369400001 | |||||||||
LEA, John Albert | Sekretär | 2 Heathgate CM8 3NZ Wickham Bishops Essex | British | Bank Official | 1369400003 | |||||||||
LYNXWILER, Elizabeth | Sekretär | Glasgow Road EH12 1HQ Edinburgh Rbs Gogarburn Scotland | 169187130001 | |||||||||||
SUTHERLAND, Ian Maclaren | Sekretär | Littledean 6 Squirrels Chase SK10 4YG Prestbury Cheshire | British | 33119710003 | ||||||||||
THOMAS, Marina Louise | Sekretär | Richmond Lodge Rhinefield Road SO42 7SQ Brockenhurst Hampshire | British | 80901390001 | ||||||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
BOAG, Timothy John Donald | Geschäftsführer | St.Georges Road St Margaret's TW1 1QS East Twickenham 23 Middlesex England | England | British | Banker | 62111350003 | ||||||||
BOAG, Timothy John Donald | Geschäftsführer | 78 Bushwood Road TW9 3BQ Richmond Surrey | British | Banker | 62111350002 | |||||||||
BROWNE, John Richard | Geschäftsführer | Gortenanima Bovally BT49 0GF Limavady 34 County Derry Northern Ireland | Northern Ireland | British | Bank Official | 133984130002 | ||||||||
BURDETT, Wayne Francis | Geschäftsführer | 18th Floor Repulse Bay Gardens, 32 Belleview Drive Hong Kong | Australian | Bank Official | 119566610001 | |||||||||
CARPENTER, Paul | Geschäftsführer | Broadoak 4 Overhill Road CR8 2JD Purley Surrey | United Kingdom | British | Investment Bank Director | 53756030002 | ||||||||
COMMONS, Peter Edmund | Geschäftsführer | The Paddock 14 Bedford Road MK44 3PS Willington Bedfordshire | England | British | Bank Official | 269026820001 | ||||||||
CROME, Trevor Douglas | Geschäftsführer | Bishopsgate EC2M 3UR London 135 | England | British | Bank Official | 186705800001 | ||||||||
DEVINE, Alan Sinclair | Geschäftsführer | Bishopsgate EC2M 3UR London 135 England | United Kingdom | British | Head: Risk & Portfolio Mgmt, Structured Fin | 148842310001 | ||||||||
DEVINE, Alan Sinclair | Geschäftsführer | 42 Mirfield Road B91 1JD Solihull West Midlands | British | Head Of Risk And Portfolio | 96634670001 | |||||||||
GREENSHIELDS, John Fraser | Geschäftsführer | Highfield House The Lane TN3 0RP Fordcombe Kent | British | Banker | 62806730003 | |||||||||
HALL, Phillip James | Geschäftsführer | 45 Crescent West EN4 0EQ Hadley Wood Hertfordshire | Uk | British | Banker | 106668160001 | ||||||||
HAMILTON, Euan Graeme | Geschäftsführer | 1b Saint Ninians Road EH12 8AP Edinburgh | Scotland | Scottish | Bank Official | 96880890001 | ||||||||
HARDY, Thomas William | Geschäftsführer | 28 Piercing Hill CM16 7JW Theydon Bois Essex | England | British | Managing Director | 40359960002 | ||||||||
HOUSTON, Iain Arthur | Geschäftsführer | Maple End 10 Hollydell SG13 8BE Hertford Hertfordshire | British | Bank Official | 8019000001 | |||||||||
JAMESON, Andrew David | Geschäftsführer | 20 Burdenshott Avenue TW10 5ED Richmond Surrey | British | Bank Official | 110180400001 | |||||||||
JONES-MOLYNEUX, Darren Scott | Geschäftsführer | Bishopsgate EC2M 3UR London 135 | England | British | Bank Official | 152191300001 | ||||||||
JORDAN, Nicholas Mark | Geschäftsführer | 43 Priory Road TW9 3DQ Kew Surrey | United Kingdom | British | Bank Official | 114291290001 | ||||||||
LEA, John Albert | Geschäftsführer | 9 Elderberry Gardens CM8 2PT Witham Essex | British | Bank Official | 1369400001 | |||||||||
MADDICK, Kevin John | Geschäftsführer | Ringford Road West Hill SW18 1RS London 16 London England | United Kingdom | British | Bank Official | 94650970001 | ||||||||
MCCARTHY, Fiona Louise | Geschäftsführer | Stock Road CM4 9PQ Stock Kauri Cottage England | British | Head Of Cib Finance | 103928910001 | |||||||||
MCGRANE, Joseph | Geschäftsführer | White Lodge Erskine Road EH31 2DQ Gullane East Lothian | United Kingdom | British | Investment Banker | 125934450001 | ||||||||
MORRIS, Philip Taylor | Geschäftsführer | 4 Oxford Terrace EH4 1PX Edinburgh Scotland | British | Chartered Accountant | 35386590001 | |||||||||
MORSE, Lee Robert | Geschäftsführer | 5a Copers Cope Road BR3 1PB Beckenham Flat 13 Kent | England | British | Bank Official | 141078840001 | ||||||||
MUDAN, Hurbinder Singh | Geschäftsführer | Hyde Vale Greenwich SE10 8QQ London 27 England | England | British | Bank Official | 133983900001 | ||||||||
NAWAS, Michael Eugene, Dr | Geschäftsführer | Maynes Farmhouse Gorhambury AL3 6AF St Albans Hertfordshire | Dutch | Bank Official | 108365160001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ROYAL BANK PROJECT INVESTMENTS LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Royal Bank Of Scotland Plc | 06. Apr. 2016 | EH2 2YB Edinburgh 36 St Andrew Square Scotland | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat ROYAL BANK PROJECT INVESTMENTS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Account charge | Erstellt am 29. Juli 2009 Geliefert am 06. Aug. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge in respect of the charge account number 31296163, see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Account charge | Erstellt am 29. Juli 2009 Geliefert am 06. Aug. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge in respect of the charge account number 31296171, see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of pledge | Erstellt am 22. Dez. 2000 Geliefert am 04. Jan. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies, obligations and liabilities due or to become due from northlink orkney and shetland ferries limited to the chargee under the terms of any secured document | |
Kurze Angaben The pledgor hereby pledges charges assigns in favour of and transfers to the security trustee for the benefit of and on behalf of itself and the secured creditors the exisiting shares (and the proceeds of sale thereof) and any other charged assets,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of pledge | Erstellt am 30. März 1999 Geliefert am 01. Apr. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from kinnoull house limited to the chargee under the deed and/or under the loan agreement | |
Kurze Angaben The existing shares and the proceeds of sale thereof and any other charged assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of pledge | Erstellt am 12. Juni 1998 Geliefert am 26. Juni 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies and liabilities present and future of covesea limited to the chargee under the terms of the loan agreement of even date, or any of the other financing documents other than the subordinated loan agreements and/or any deed or document supplemental thereto | |
Kurze Angaben The existing shares (and the proceeds of sale thereof), of covesea and any other charged assets to which the pledgors are entitled at the date of the deed and any rights or further shares (and proceeds of sale thereof) to which they become entitled after the date of the deed (rights being all rights (including the right to receive all dividends and other distributions and bonus and scrip rights) pertaining to or deriving from the shares.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charges on shares | Erstellt am 25. Nov. 1996 Geliefert am 13. Dez. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities of tcl to the chargee under each of the operative documents to which tcl is a party and all present and future obligations of the company and all or any of the other companies named therein to the chargee under the charge on shares | |
Kurze Angaben 466,593 shares of £1 each in the capital of tcl and 297,454 shares of £1 each in the capital of tcl together with all dividends. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge on shares | Erstellt am 25. Nov. 1996 Geliefert am 12. Dez. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee or to any finance party (as defined) and/or hedging bank (as defined) under each finance document (as defined) and all present and future obligations and liabilities of the company to any finance party and/or hedging bank under this charge on shares | |
Kurze Angaben During the first security period, the 466,598 shares in the capital of the borrower. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat ROYAL BANK PROJECT INVESTMENTS LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0