AVEBURY INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY

AVEBURY INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameAVEBURY INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformAktiengesellschaft
    Unternehmensnummer 02835175
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von AVEBURY INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY?

    • (7415) /

    Wo befindet sich AVEBURY INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o MAZARS LLP
    45 Church Street
    B3 2RT Birmingham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von AVEBURY INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2007

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für AVEBURY INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für AVEBURY INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 05. Feb. 2014

    5 Seiten4.68

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    3 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 09. Nov. 2013

    6 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 09. Mai 2013

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 09. Nov. 2012

    5 Seiten4.68

    Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator

    1 Seiten4.40

    Insolvenzgerichtsbeschluss

    Court order insolvency:replacement of liquidator ;- s d chandler replacing a s wood 01/03/2013
    8 SeitenLIQ MISC OC

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 09. Mai 2012

    7 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 09. Nov. 2011

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 09. Mai 2011

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 09. Nov. 2010

    6 Seiten4.68

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * C/O Mazars Llp Lancaster House 67 Newhall Street Birmingham B3 1NG* am 07. Okt. 2010

    2 SeitenAD01

    Konzernabschluss erstellt bis zum 31. März 2007

    29 SeitenAA

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    14 Seiten2.34B

    legacy

    1 Seiten288b

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 22. Mai 2009

    13 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Mitteilung des Verwalters über eine Änderung der Ausschussmitgliedschaft

    1 Seiten2.27B

    Mitteilung des Verwalters über eine Änderung der Ausschussmitgliedschaft

    1 Seiten2.27B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 22. Nov. 2008

    12 Seiten2.24B

    Ergebnis der Gläubigerversammlung

    34 Seiten2.23B

    Geänderte Bescheinigung über die Zusammensetzung des Gläubigerausschusses

    1 Seiten2.26B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    6 Seiten2.16B

    Wer sind die Geschäftsführer von AVEBURY INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HAYNES, Richard John
    62 St Marys Road
    NN15 7BW Kettering
    Northamptonshire
    Sekretär
    62 St Marys Road
    NN15 7BW Kettering
    Northamptonshire
    British3105900001
    HAYNES, Richard John
    62 St Marys Road
    NN15 7BW Kettering
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    62 St Marys Road
    NN15 7BW Kettering
    Northamptonshire
    United KingdomBritish3105900001
    MACGILLIVRAY, Roderick Roy
    Elders
    The Clump
    WD3 4BD Chorleywood
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Elders
    The Clump
    WD3 4BD Chorleywood
    Hertfordshire
    United KingdomBritish98986380001
    DIAMOND, Henry Alexander
    Broughton Manor
    Broughton
    MK10 9AA Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Sekretär
    Broughton Manor
    Broughton
    MK10 9AA Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British70491590001
    MINTER, Ivan William
    Farmside Leighton Road
    Northall
    LU6 2HA Dunstable
    Bedfordshire
    Sekretär
    Farmside Leighton Road
    Northall
    LU6 2HA Dunstable
    Bedfordshire
    British9384760001
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Bevollmächtigter Sekretär
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    DIAMOND, Henry Alexander
    Broughton Manor
    Broughton
    MK10 9AA Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Broughton Manor
    Broughton
    MK10 9AA Milton Keynes
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish70491590001
    KIRKBY, Duncan Anthony
    Park Lodge
    Hulton Drive
    MK46 5BW Emberton
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Park Lodge
    Hulton Drive
    MK46 5BW Emberton
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish109350030002
    LEWIS, Gareth
    176 White Hill
    HP5 1AZ Chesham
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    176 White Hill
    HP5 1AZ Chesham
    Buckinghamshire
    British76300760005
    MUIR, Peter John Alexander Arthur
    Yaxham Park
    Station Road, Yaxham
    NR19 1RD Dereham
    Norfolk
    Geschäftsführer
    Yaxham Park
    Station Road, Yaxham
    NR19 1RD Dereham
    Norfolk
    British25734580003
    PANCHAL, Dharmesh
    17 Rossini Place
    Old Farm Park
    MK7 8EZ Milton Keynes
    Geschäftsführer
    17 Rossini Place
    Old Farm Park
    MK7 8EZ Milton Keynes
    British78940870002
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    Hat AVEBURY INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    The deed of assignment
    Erstellt am 22. Sept. 2006
    Geliefert am 04. Okt. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All rights title benefit and interest in and to each and every assigned contract meaning the assignors rights and interests under all agreements including without limitation all sums payable thereunder. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 04. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Sept. 2006
    Geliefert am 04. Okt. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H land on the west side of whittlesey road stanground peterborough t/no CB292973. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 04. Okt. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Aug. 2006
    Geliefert am 03. Aug. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Plot 74 westcroft 15 westcroft milton keynes buckinghamshire.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Aug. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Aug. 2006
    Geliefert am 03. Aug. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Plot 73 westcroft 15 westcroft milton keynes buckinghamshire.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Aug. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage
    Erstellt am 12. Juli 2005
    Geliefert am 15. Juli 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £124,000.00 due or to become due from the company to
    Kurze Angaben
    77 south fifth street central milton keynes.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transaktionen
    • 15. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Deed o assignment
    Erstellt am 02. Juni 2005
    Geliefert am 08. Juni 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Ll right,title,benefit and interest in and to each and every assigned contract including all sums payable thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 08. Juni 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Juni 2005
    Geliefert am 08. Juni 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold land known as 51 and 53 bow road,london; 279464. fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 08. Juni 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage deed
    Erstellt am 18. Apr. 2005
    Geliefert am 28. Apr. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £111,300.00 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    447 south row central milton keynes.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage deed
    Erstellt am 18. Apr. 2005
    Geliefert am 28. Apr. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £111,300.00 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    357 south row central milton keynes.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of charge
    Erstellt am 15. Sept. 1995
    Geliefert am 22. Sept. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All right title & interest under the agreements details which are set out in the schedule to the form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Sept. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge and assignment
    Erstellt am 15. Sept. 1995
    Geliefert am 22. Sept. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the agreements as detailed in the schedule to the form 395 and the benefit of the same, all moneys by virtue of the agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Sept. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Sept. 1995
    Geliefert am 22. Sept. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land at richmond road l/b of kingston upon thames being part t/no TGL93924.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Sept. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 24. März 1995
    Geliefert am 29. März 1995
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. März 1995Registrierung einer Belastung (395)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 20. Mai 1994
    Geliefert am 07. Juni 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Juni 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat AVEBURY INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    23. Mai 2008Beginn der Verwaltung
    10. Nov. 2009Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Alistair Steven Wood
    Mazars Llp
    Lancaster House
    B3 1NG 67 Newhall Street
    Birmingham
    Praktiker
    Mazars Llp
    Lancaster House
    B3 1NG 67 Newhall Street
    Birmingham
    Roderick John Weston
    Lancashire House 67 Newhall Street
    B3 1NG Birmingham
    Praktiker
    Lancashire House 67 Newhall Street
    B3 1NG Birmingham
    Martin Dominic Pickard
    Lancaster House 67 Newhall Street
    B3 1NG Birmingham
    Praktiker
    Lancaster House 67 Newhall Street
    B3 1NG Birmingham
    2
    DatumTyp
    10. Nov. 2009Beginn der Liquidation
    12. Mai 2014Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Alistair Steven Wood
    Mazars Llp
    Lancaster House
    B3 1NG 67 Newhall Street
    Birmingham
    Praktiker
    Mazars Llp
    Lancaster House
    B3 1NG 67 Newhall Street
    Birmingham
    Roderick John Weston
    Lancashire House 67 Newhall Street
    B3 1NG Birmingham
    Praktiker
    Lancashire House 67 Newhall Street
    B3 1NG Birmingham
    Martin Dominic Pickard
    Lancaster House 67 Newhall Street
    B3 1NG Birmingham
    Praktiker
    Lancaster House 67 Newhall Street
    B3 1NG Birmingham
    Simon David Chandler
    C/O Mazars Llp 1st Floor
    Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Praktiker
    C/O Mazars Llp 1st Floor
    Two Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0