PILLAR (PRESTON) LIMITED
Überblick
Unternehmensname | PILLAR (PRESTON) LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02836239 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PILLAR (PRESTON) LIMITED?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
Wo befindet sich PILLAR (PRESTON) LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 8 Salisbury Square EC4Y 8BB London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von PILLAR (PRESTON) LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
PARINV (SMALL HEATH) LIMITED | 21. Okt. 1993 | 21. Okt. 1993 |
GOULDITAR NO. 287 LIMITED | 14. Juli 1993 | 14. Juli 1993 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PILLAR (PRESTON) LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2013 |
Welche sind die letzten Einreichungen für PILLAR (PRESTON) LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 4 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2013 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom York House 45 Seymour Street London W1H 7LX am 09. Juli 2013 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Benjamin Toby Grose als Geschäftsführer am 12. Juni 2013 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew David Smith als Geschäftsführer am 12. Juni 2013 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2012 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Philip John Martin am 02. Aug. 2012 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Ernennung von Andrew David Smith als Direktor am 18. Juli 2012 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. Juli 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2011 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. Juli 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2010 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 14. Juli 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Ernennung von Benjamin Toby Grose als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Philip John Martin als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Valentine Beresford als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Jones als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Stirling als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2009 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von PILLAR (PRESTON) LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTIN, Philip John | Sekretär | Runwick Hill Runwick Lane GU10 5EE Farnham Surrey | British | 35118050001 | ||||||
MARTIN, Philip John | Geschäftsführer | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 35118050001 | ||||
MEENAGHAN, Evelyn Maria | Bevollmächtigter Sekretär | 48 Cedars Avenue E17 7QN London | British | 900001370001 | ||||||
BERESFORD, Valentine Tristram | Geschäftsführer | 3 Smith Terrace SW3 4DL London | England | British | Company Director | 40766290003 | ||||
GROSE, Benjamin Toby | Geschäftsführer | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 146546000001 | ||||
JONES, Andrew Marc | Geschäftsführer | Hazlewell Road Putney SW15 6LH London 2 | England | British | Company Director | 82020730004 | ||||
MAXTED, Robert David | Geschäftsführer | Vanhurst Thorncombe Street GU5 0ND Bramley Surrey | British | Company Director | 37177990001 | |||||
MCGANN, Martin Francis | Geschäftsführer | 10 Westcombe Park Road SE3 7RB Blackheath London | British | Chartered Accountant | 109383240001 | |||||
MOULD, Harold Raymond | Geschäftsführer | 40 Hasker Street SW3 2LQ London | England | British | Solicitor | 35576350006 | ||||
PRICE, Humphrey James Montgomery | Geschäftsführer | Deaks Deaks Lane RH17 5JA Cuckfield West Sussex | Uk | British | Chartered Accountant | 14448630001 | ||||
SEATON, Stuart Neil | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 12 Priory Walk SW10 9SP London | United Kingdom | British | 900001360001 | |||||
SMITH, Andrew David | Geschäftsführer | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | Surveyor | 108214880002 | ||||
STIRLING, Mark Andrew | Geschäftsführer | Great Oak House Essendon Place, Essendon AL9 6GZ Hatfield Hertfordshire | United Kingdom | British | Surveyor | 106882210001 | ||||
VAUGHAN, Patrick Lionel | Geschäftsführer | June Farm Trumpet Hill Road RH2 8QY Reigate Surrey | United Kingdom | British | Company Director | 73972350001 | ||||
VAUGHAN, Patrick Lionel | Geschäftsführer | June Farm Trumpet Hill Road RH2 8QY Reigate Surrey | United Kingdom | British | Company Director | 73972350001 |
Hat PILLAR (PRESTON) LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A security agreement between, amongst others, the chargor and the agent (as defined below) | Erstellt am 05. Nov. 2001 Geliefert am 15. Nov. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to each finance party under each finance document (as defined) | |
Kurze Angaben Inclusive of the following property 1). f/h land k/a broughton shopping park chester WA875009 2). f/h land k/a deepdale retail park blackpool road preston lancashire LA624965 3). f/h land k/a land and buildings on the north east side of blackpool road ribbledon preston t/no;-LA481515. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge | Erstellt am 16. März 1998 Geliefert am 01. Apr. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to each finance party under each finance document (as defined) | |
Kurze Angaben Land and buildings on the north east side of blackpool road preston lancashire known as deepdale retail park t/n LA624965. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 11. Sept. 1996 Geliefert am 13. Sept. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities now due or to become due from the company and each obligor to the chargee pursuant to the terms of each finance document (as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 21. Jan. 1994 Geliefert am 03. Feb. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of first fixed charge the l/h property k/a the asda superstore small heath birmingham also by way of first fixed charge any sum paid out on any insurance policy taken out by the company covering the property and any sum paid to the company on any insurance policy taken out by the tenant to the property and covering the property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge over deposit account | Erstellt am 21. Jan. 1994 Geliefert am 03. Feb. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due or to become due from the company to wurttembergische hypothekenbank ag under or pursuant to the terms of the charge, | |
Kurze Angaben All sums from time to time standing to the credit of the company in the curent account number 624114 and the deposit account number 1528424 of the company at the bank of scotland ,38 threadneedle street, london EC2 .,and all interest accrued or to be accrued thereon,. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge over deposit account. | Erstellt am 21. Jan. 1994 Geliefert am 03. Feb. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due or to become due from the company to wurttembergische hypothekenbank ag under or pursuant to the terms of a facility agreement dated 19TH january and/or this charge. | |
Kurze Angaben All the money from time to time standing to the credit of the company in the account numbered 528440 of the company at the bank of scotland ,38 threadneedle street,london E2 together with all interest accrued or to be accrued thereobn. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat PILLAR (PRESTON) LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0