CONCORDE CONTAINER LINE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CONCORDE CONTAINER LINE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02836298 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CONCORDE CONTAINER LINE LIMITED?
- See- und Küstenfrachtverkehr (50200) / Verkehr und Lagerei
Wo befindet sich CONCORDE CONTAINER LINE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Maritime Centre Port Of Liverpool L21 1LA Liverpool Merseyside |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CONCORDE CONTAINER LINE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2015 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CONCORDE CONTAINER LINE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 29. Juni 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 13. Mai 2016
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Whittaker als Geschäftsführer am 29. März 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Thomas Eardley Allison als Geschäftsführer am 29. März 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2015 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 09. Juli 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr John Whittaker am 07. Apr. 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2014 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 09. Juli 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2013 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 09. Juli 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2012 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 09. Juli 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Ernennung von Ian Graeme Lloyd Charnock als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2011 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 09. Juli 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Alan Barr als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CONCORDE CONTAINER LINE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARRISON GILL, Caroline Ruth | Sekretär | 113 Tarvin Road Littleton CH3 7DE Chester Woodleigh Cheshire | Other | 140064590001 | ||||||
| CHARNOCK, Ian Graeme Lloyd | Geschäftsführer | Holly Bank Drive HX3 8PA Halifax Woodcote West Yorkshire United Kingdom | England | British | 165341530001 | |||||
| WHITWORTH, Mark | Geschäftsführer | Culvert Lane Off Back Lane WN8 7XA Newburgh Springside Lancashire | England | British | 120679580002 | |||||
| BOWLEY, William John | Sekretär | 17 St Georges Road Formby L37 3HH Liverpool Merseyside | British | 4171240002 | ||||||
| BREINGAN, Mark | Sekretär | 6 Raith Drive Cumbernauld G68 9PE Glasgow Lanarkshire | British | 65773150001 | ||||||
| LANE, John Anthony | Sekretär | Far Hills Grove Road HP23 5PA Tring Hertfordshire | British | 17079850001 | ||||||
| LEWIN, Roger | Sekretär | The Limes Main Road Claybrook Magna LE17 5AJ Lutterworth Leicestershire | British | 68728770002 | ||||||
| AA COMPANY SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | First Floor Offices 8-10 Stamford Hill N16 6XZ London | 900002630001 | |||||||
| ALLISON, Thomas Eardley | Geschäftsführer | 23 Park Place FK7 9JR Stirling Rockdale Lodge Scotland Scotland | Scotland | British | 1037730004 | |||||
| ALLISON, Thomas Eardley | Geschäftsführer | Rockdale Lodge 23 Park Place FK7 9JR Stirling Scotland | Scotland | British | 1037730004 | |||||
| BARR, Alan Andrew | Geschäftsführer | 7 Wellington Terrace ML11 7QQ Lanark Lanarkshire | Scotland | British | 121452150001 | |||||
| BAXTER, Stephen Roy | Geschäftsführer | Springkell Avenue Pollokshields G41 4EH Glasgow 94 United Kingdom | Scotland | British | 86622660005 | |||||
| BREINGAN, Mark | Geschäftsführer | 6 Raith Drive Cumbernauld G68 9PE Glasgow Lanarkshire | British | 65773150001 | ||||||
| FINDLAY, Alastair Ian | Geschäftsführer | High Billinge House Utkinton CW6 0LA Tarporley Cheshire | United Kingdom | British | 30045540003 | |||||
| GREEN, David Simon | Geschäftsführer | 16a Inverleith Row EH3 5LS Edinburgh | British | 42038120003 | ||||||
| HIE, John Joseph | Geschäftsführer | 3 Willowbrook Derrington ST18 9NN Stafford Staffordshire | British | 21129960001 | ||||||
| LANE, John Anthony | Geschäftsführer | Far Hills Grove Road HP23 5PA Tring Hertfordshire | British | 17079850001 | ||||||
| LEWIN, Roger | Geschäftsführer | The Limes Main Road Claybrook Magna LE17 5AJ Lutterworth Leicestershire | British | 68728770002 | ||||||
| PORTER, Allan | Geschäftsführer | 44 Cawder Road G68 0BF Cumbernauld | British | 49614260002 | ||||||
| SCOTT, Peter Anthony | Geschäftsführer | 6 Bowling Green Way Bamford OL11 5QQ Rochdale Lancashire | British | 1674500002 | ||||||
| WHARTON, Kenneth John | Geschäftsführer | Cornercroft 7 Glendyke Road L18 6JR Liverpool Merseyside | British | 9964160002 | ||||||
| WHITTAKER, John | Geschäftsführer | The Trafford Centre M17 8PL Manchester Peel Dome England England | Isle Of Man | British | 1614010001 | |||||
| BUYVIEW LTD | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 1st Floor Offices 8-10 Stamford Hill N16 6XZ London | 900002620001 |
Hat CONCORDE CONTAINER LINE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Security deed of accession | Erstellt am 28. Feb. 2007 Geliefert am 13. März 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and each other obligor to any secured creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. März 2006 Geliefert am 06. Apr. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the security trustee (whether for its own account or as security trustee for the secured parties) or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 10. Mai 1999 Geliefert am 15. Mai 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 23. Apr. 1999 Geliefert am 30. Apr. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0