GATEFORTH PARK LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameGATEFORTH PARK LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02840715
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von GATEFORTH PARK LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich GATEFORTH PARK LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Stock Lane
    Langford
    BS40 5ES Bristol
    Somerset
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von GATEFORTH PARK LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    TOPCHECK LIMITED29. Juli 199329. Juli 1993

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GATEFORTH PARK LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis29. Dez. 2017

    Welche sind die letzten Einreichungen für GATEFORTH PARK LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 29. Dez. 2017

    14 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 28. Juli 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 28. Juli 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Erfüllung der Belastung 8 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 5 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 3 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 2 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 4 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 6 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 7 vollständig

    2 SeitenMR04

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Dez. 2016

    13 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 28. Juli 2017 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015

    13 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von John Stanley als Geschäftsführer am 19. Sept. 2016

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 29. Juli 2016 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Jahresrückblick erstellt bis 29. Juli 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital08. Sept. 2016

    Kapitalaufstellung am 08. Sept. 2016

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Paul Thomas Wilson am 01. Feb. 2016

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    13 SeitenAA

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    13 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr Philip David Wilson am 16. Nov. 2015

    4 SeitenCH01

    Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss

    3 SeitenAC92

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Wer sind die Geschäftsführer von GATEFORTH PARK LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    WILSON, Philip
    Haddon Road
    Clontarf
    25
    Dublin 3
    Ireland
    Sekretär
    Haddon Road
    Clontarf
    25
    Dublin 3
    Ireland
    Irish107845750001
    WILSON, Paul Thomas
    Langford
    BS40 5ES Bristol
    Stock Lane
    Somerset
    Geschäftsführer
    Langford
    BS40 5ES Bristol
    Stock Lane
    Somerset
    IrelandIrish175102510004
    WILSON, Philip David
    Langford
    BS40 5ES Bristol
    Stock Lane
    Somerset
    Geschäftsführer
    Langford
    BS40 5ES Bristol
    Stock Lane
    Somerset
    IrelandIrish176073380001
    WILSON, Ronald Christopher
    Tyholland House
    IRISH Tyholland
    Monaghan
    Ireland
    Geschäftsführer
    Tyholland House
    IRISH Tyholland
    Monaghan
    Ireland
    IrelandIrish144024000001
    GARRY, Michael
    Landenstown
    Sallins
    IRISH Co. Kildare
    Ireland
    Sekretär
    Landenstown
    Sallins
    IRISH Co. Kildare
    Ireland
    Irish126468430001
    RUTLAND SECRETARIES LIMITED
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    Bevollmächtigter Sekretär
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    900005290001
    CLAY, John Andrew
    35 Woodlands View
    Barlby
    YO8 7XL Selby
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    35 Woodlands View
    Barlby
    YO8 7XL Selby
    North Yorkshire
    British75734550001
    FINNAMORE, Des
    Clonkeen
    IRISH Carbury
    County Kildaire
    South Ireland
    Geschäftsführer
    Clonkeen
    IRISH Carbury
    County Kildaire
    South Ireland
    British40604280001
    GARRY, Michael
    Landenstown
    Sallins
    IRISH Co. Kildare
    Ireland
    Geschäftsführer
    Landenstown
    Sallins
    IRISH Co. Kildare
    Ireland
    Irish126468430001
    MACCANNA, Cahal
    29 Castleknock Lodge
    Castleknock
    Dublin
    Dublin 15
    Ireland
    Geschäftsführer
    29 Castleknock Lodge
    Castleknock
    Dublin
    Dublin 15
    Ireland
    Irish66911960001
    MIDDLEBROOK, Simon
    Burton Hall Farm
    Mill Lane Brayton
    YO8 9LD Selby
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Burton Hall Farm
    Mill Lane Brayton
    YO8 9LD Selby
    North Yorkshire
    EnglandBritish48882160001
    SPENCER, Charles Christopher Alwyn
    The Mews
    29 York Place
    HG1 5RH Harrogate
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    The Mews
    29 York Place
    HG1 5RH Harrogate
    North Yorkshire
    British76665020001
    STANLEY, John
    Riverside
    Athlumwey
    Navan
    County Meath
    Republic Of Ireland
    Geschäftsführer
    Riverside
    Athlumwey
    Navan
    County Meath
    Republic Of Ireland
    IrelandIrish9508050001
    WALKER, David Arthur
    Bank Villa
    Newland Drax
    YO8 8PS Selby
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Bank Villa
    Newland Drax
    YO8 8PS Selby
    North Yorkshire
    British36079820002
    WALSH, Patrick Anthony
    Barnadown
    IRISH Gorey
    Co Wexford
    Ireland
    Geschäftsführer
    Barnadown
    IRISH Gorey
    Co Wexford
    Ireland
    IrelandIrish63377340001
    RUTLAND DIRECTORS LIMITED
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    900005280001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei GATEFORTH PARK LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Decisiondrive Limited
    Stock Lane
    Langford
    BS40 5ES Bristol
    C/O Monaghan Mushrooms Limited
    England
    06. Apr. 2016
    Stock Lane
    Langford
    BS40 5ES Bristol
    C/O Monaghan Mushrooms Limited
    England
    Nein
    RechtsformPrivate Limited Company
    RegistrierungslandUnited Kingdom
    RechtsgrundlageCompanies Act 1985
    RegistrierungsortRegistrar Of Companies For England And Wales
    Registrierungsnummer03742194
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat GATEFORTH PARK LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 04. Nov. 2011
    Geliefert am 17. Nov. 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 17. Nov. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 08. Dez. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 05. Okt. 2010
    Geliefert am 26. Okt. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    First fixed charge the mortgage property,by way of mortgage any deed of easements or rights of way used in connection with the security assets and to the licences and all rights of recovery and compensation,the leases .leasing agreements,agreements for lease or hire purchase agreements see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 26. Okt. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 08. Dez. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 05. Okt. 2010
    Geliefert am 26. Okt. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    First fixed charge the mortgage property,by way of mortgage any deed of easements or rights of way used in connection with the security assets and to the licences and all rights of recovery and compensation,the leases .leasing agreements,agreements for lease or hire purchase agreements see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 26. Okt. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 08. Dez. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Composite debenture
    Erstellt am 02. Juni 2004
    Geliefert am 22. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 22. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Dez. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Composite debenture
    Erstellt am 02. Juni 2004
    Geliefert am 22. Juni 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 22. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Dez. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Composite debenture (as defined)
    Erstellt am 26. Okt. 2001
    Geliefert am 13. Nov. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 13. Nov. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Dez. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 30. März 1998
    Geliefert am 08. Apr. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 08. Apr. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Dez. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 31. Aug. 1993
    Geliefert am 06. Sept. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 06. Sept. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Feb. 2013Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0