IRTH (9) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | IRTH (9) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02845899 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von IRTH (9) LIMITED?
- Nicht spezialisierter Großhandel (46900) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
Wo befindet sich IRTH (9) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Equity House Irthlingborough Road NN8 1LT Wellingborough Northamptonshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von IRTH (9) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| FOOD INGREDIENTS FOR INDUSTRY LIMITED | 09. Jan. 1995 | 09. Jan. 1995 |
| REDLYNE LIMITED | 19. Aug. 1993 | 19. Aug. 1993 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von IRTH (9) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Jan. 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für IRTH (9) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 11. Juli 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Hinweis auf Namensänderung | 2 Seiten | CONNOT | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Jan. 2011 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 11. Juli 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Charles Wilson als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Laura Taylor als Sekretär | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jonathan Prentis als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Laura Taylor als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Chilton als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Jan. 2012 bis 31. März 2012 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Ernennung von Charles Wilson als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||
Ernennung von Mr Jonathan Paul Prentis als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mark Chilton als Sekret är | 3 Seiten | AP03 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Unit 4 Westlinks Alperton Lane Middlesex HA0 1ER am 18. Okt. 2010 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Angela Le Vesconte als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Toby King als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ian Le Vesconte als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Sale als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von IRTH (9) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAYLOR, Laura | Sekretär | Irthlingborough Road NN8 1LT Wellingborough Equity House Northants United Kingdom | 158797680001 | |||||||
| TAYLOR, Laura | Geschäftsführer | Irthlingborough Road NN8 1LT Wellingborough Equity House Northants United Kingdom | United Kingdom | British | 155913200001 | |||||
| CHILTON, Mark | Sekretär | Irthlingborough Road NN8 1LT Wellingborough Equity House Northamptonshire | British | 154975320001 | ||||||
| TISSIER, Anna Katarina | Sekretär | St Cyrus Trout Rise Loudwater WD3 4JS Rickmansworth Hertfordshire | Swedish | 63554830001 | ||||||
| WEBB, Bonnie Mae | Sekretär | 38 Longstone Avenue NW10 3TU London | Irish | 65783770001 | ||||||
| WEBB, Bonnie Mae | Sekretär | 38 Longstone Avenue NW10 3TU London | Irish | 65783770001 | ||||||
| LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 84 Temple Chambers Temple Avenue EC4Y 0HP London | 900001510001 | |||||||
| BEAUMONT, Graham | Geschäftsführer | 134 Bushey Mill Lane WD24 7PB Watford Hertfordshire | British | 74831420001 | ||||||
| HOFFELNER, Guy Konrad | Geschäftsführer | 66 Clare Road SL6 4DQ Maidenhead Berkshire | British | 97505830002 | ||||||
| KING, Toby | Geschäftsführer | 61 Mulgrave Road W5 1LF London | British | 25979120002 | ||||||
| LE VESCONTE, Angela Marie | Geschäftsführer | 73 Copthorne Road Croxley Green WD3 4AH Rickmansworth Hertfordshire | British | 12785650001 | ||||||
| LE VESCONTE, Ian John | Geschäftsführer | 73 Copthorne Road Croxley Green WD3 4AH Rickmansworth Hertfordshire | British | 6354610001 | ||||||
| PRATT, Godfrey John | Geschäftsführer | 43 Barnwell Oundle PE8 5PS Peterborough Cambridgeshire | British | 51766110002 | ||||||
| PRENTIS, Jonathan Paul | Geschäftsführer | Irthlingborough Road NN8 1LT Wellingborough Equity House Northamptonshire | United Kingdom | British | 48949090001 | |||||
| SALE, Richard Stephen George | Geschäftsführer | 41 Chatsworth Road TQ1 3BJ Torquay Devon | United Kingdom | British | 90491420002 | |||||
| SIMON, Eva Gabriella | Geschäftsführer | 40 Kenilworth Road HA8 8YG Edgware Middlesex | British | 36267840002 | ||||||
| TISSIER, Anna Katarina | Geschäftsführer | St Cyrus Trout Rise Loudwater WD3 4JS Rickmansworth Hertfordshire | Swedish | 63554830001 | ||||||
| WILSON, Charles | Geschäftsführer | Irthlingborough Road NN8 1LT Wellingborough Equity House Northamptonshire England | United Kingdom | British | 123998480001 | |||||
| LONDON LAW SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 84 Temple Chambers Temple Avenue EC4Y 0HP London | 900001500001 |
Hat IRTH (9) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 28. Sept. 2006 Geliefert am 04. Okt. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed charge supplemental to a debenture dated 29 august 2000 issued by the company | Erstellt am 01. Nov. 2000 Geliefert am 07. Nov. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies now due or hereafter to become due or from time to time accruing due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the aforesaid debenture | |
Kurze Angaben By way of fixed charge all right title and interest of the company in or arising out of a factoring, invoice discounting or sales ledger financing agreement dated 13 august 1996 between confidential invoice discounting limited and TH0 company and any deed amending or replacing the same (all such deeds being hereinafter called the "charged deeds") and all book debts and other debts. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 29. Aug. 2000 Geliefert am 05. Sept. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 06. Juli 1998 Geliefert am 17. Juli 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed charge supplemental to a guarantee and debenture dated 20TH june 1995 issued by the company and others | Erstellt am 07. Aug. 1997 Geliefert am 14. Aug. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforesaid guarantee and debenture | |
Kurze Angaben Fixed charge all right title and interest of the company in or arising out of the "charged deeds" (as defined) and all book and other debts amending or replacing the same. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 12. Aug. 1996 Geliefert am 16. Aug. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All debts the subject of an invoice discounting agreement and by way of a floating charge. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 20. Juni 1995 Geliefert am 11. Juli 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or leovic limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0