CONTINENTAL CONTRACTING LIMITED
Überblick
Unternehmensname | CONTINENTAL CONTRACTING LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Liquidation |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02845908 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CONTINENTAL CONTRACTING LIMITED?
- Andere Aktivitäten von Arbeitsvermittlungsagenturen (78109) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
Wo befindet sich CONTINENTAL CONTRACTING LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Bulman House Regent Centre Gosforth NE3 3LS Newcastle Upon Tyne |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CONTINENTAL CONTRACTING LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
CONTINENTAL CONTRACTING PLC | 19. Aug. 1993 | 19. Aug. 1993 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CONTINENTAL CONTRACTING LIMITED?
Überfällig | Ja |
---|---|
Nächster Jahresabschluss | |
Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. Dez. 2014 |
Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Sept. 2015 |
Letzter Jahresabschluss | |
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2013 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für CONTINENTAL CONTRACTING LIMITED?
Überfällig | Ja |
---|---|
Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 19. Juli 2016 |
Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 02. Aug. 2016 |
Überfällig | Ja |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für CONTINENTAL CONTRACTING LIMITED?
Jahresabschluss |
|
---|
Welche sind die letzten Einreichungen für CONTINENTAL CONTRACTING LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Dez. 2024 | 24 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Dez. 2023 | 23 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Dez. 2022 | 22 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Dez. 2020 | 24 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Dez. 2021 | 25 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 1 st. James Gate Newcastle upon Tyne Tyne and Wear NE1 4AD zum Bulman House Regent Centre Gosforth Newcastle upon Tyne NE3 3LS am 15. Juli 2020 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Dez. 2019 | 17 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Dez. 2018 | 18 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Dez. 2017 | 18 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 16. Dez. 2016 | 15 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Suite 7 Cookson House River Drive South Shields Tyne & Wear NE33 1TL zum 1 st. James Gate Newcastle upon Tyne Tyne and Wear NE1 4AD am 31. Dez. 2015 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular 4.19 | 7 Seiten | 4.20 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Clare Campbell als Geschäftsführer am 18. Sept. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Juli 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Juli 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Brian Paul Campbell als Sekretär | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Paul Downey als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Aug. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Aug. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CONTINENTAL CONTRACTING LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMPBELL, Brian Paul | Sekretär | Regent Centre Gosforth NE3 3LS Newcastle Upon Tyne Bulman House | 187314730001 | |||||||
CAMPBELL, Brian Paul | Geschäftsführer | 7 West Meadows Road SR6 7TX Sunderland Tyne & Wear | England | British | Managing Director | 64885620002 | ||||
CAMPBELL, Brian Paul | Sekretär | 7 West Meadows Road SR6 7TX Sunderland Tyne & Wear | British | Procurement Manager | 64885620002 | |||||
DOWNEY, Paul | Sekretär | 15 Midhurst Avenue NE34 6JH South Shields Tyne & Wear | British | 69813240001 | ||||||
KING, Clare | Sekretär | 7 West Meadows Road Cleadon Village SR6 7TX Tyne And Wear | Brutish | 41900160003 | ||||||
STOOF, Marcus Omer Cornelius | Sekretär | Middellaan 152 4811vm Breda Breda FOREIGN Netherlands | Dutch | Sales Manager | 36090280001 | |||||
AA COMPANY SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | First Floor Offices 8-10 Stamford Hill N16 6XZ London | 900002630001 | |||||||
CAMPBELL, Agnes | Geschäftsführer | 60 Constable Gardens NE34 8LR South Shields Tyne & Wear | United Kingdom | British | Director | 69828270001 | ||||
MILLER, Timothy Ian | Geschäftsführer | Grote Houw 333 Breda FOREIGN Netherlands | British | General Manager | 36090270001 | |||||
STOOF, Marcus Omer Cornelius | Geschäftsführer | Middellaan 152 4811vm Breda Breda FOREIGN Netherlands | Dutch | Sales Manager | 36090280001 | |||||
BUYVIEW LTD | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 1st Floor Offices 8-10 Stamford Hill N16 6XZ London | 900002620001 |
Hat CONTINENTAL CONTRACTING LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Fixed charge over factoring agreement | Erstellt am 25. Okt. 2005 Geliefert am 02. Nov. 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of fixed charge all right title and interest of the company in or arising out of a factoring agreement dated 21 october 2005 and all book debts and other debts. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of charge over credit balances | Erstellt am 25. Okt. 2005 Geliefert am 02. Nov. 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Account number 20006270 sort code 20-80-47. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 24. Okt. 2005 Geliefert am 29. Okt. 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & debenture | Erstellt am 21. Okt. 2002 Geliefert am 30. Okt. 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or kestrel manpower limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed and floating charge | Erstellt am 07. Okt. 1998 Geliefert am 09. Okt. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee whether arising under the agreement or otherwise | |
Kurze Angaben By way of fixed charge all specified debts and all amounts of indebtedness due to the company on any account whatsoever. By way of floating charge all undertaking property rights and assets of the company including stock in trade and its uncalled capital. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 10. Juli 1998 Geliefert am 30. Juli 1998 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Contract to sell/contract of services commercial accounts receivable | Erstellt am 14. Aug. 1996 Geliefert am 17. Aug. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All that, on any ground whatever and either conditionally or unconditionally, the company owes or will owe the chargee, be it due for immediate payment or not | |
Kurze Angaben Anything at any time held by the chargee for the company or any thing so held which belongs to the company or is or will be owing to the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed charge on debts | Erstellt am 14. Aug. 1996 Geliefert am 17. Aug. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee whether arising under the factoring agreement or otherwise | |
Kurze Angaben By way of first fixed charge the debts and associated rights and by way of first fixed equitable charge the other debts. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat CONTINENTAL CONTRACTING LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0