REFINED MP LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | REFINED MP LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02847780 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von REFINED MP LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich REFINED MP LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Gladstone Place 36-38 Upper Marlborough Road AL1 3UU St. Albans Hertfordshire England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von REFINED MP LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| MALTHURST PETROLEUM LIMITED | 21. Juni 2000 | 21. Juni 2000 |
| GILLINGHAM SERVICE STATION LIMITED | 22. Okt. 1998 | 22. Okt. 1998 |
| HEARTS SERVICES LIMITED | 25. Aug. 1993 | 25. Aug. 1993 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von REFINED MP LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für REFINED MP LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 8 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 30. Aug. 2019
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 25. Aug. 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Ernennung von Thomas Mckenzie Biggart als Direktor am 11. März 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Ernennung von Pinsent Masons Secretarial Limited als Sekretär am 07. März 2019 | 2 Seiten | AP04 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Hathaway als Sekretär am 07. März 2019 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Graham Paul Timbers als Geschäftsführer am 12. Feb. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Simon Paul Lane als Direktor am 31. Dez. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr William Bahlsen Bannister als Direktor am 31. Dez. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Vincent House 4 Grove Lane Epping Essex CM16 4LH zum Gladstone Place 36-38 Upper Marlborough Road St. Albans Hertfordshire AL1 3UU am 02. Jan. 2019 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Steven John Back als Geschäftsführer am 15. Okt. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Graham Paul Timbers als Direktor am 12. Okt. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Sept. 2018 bis 31. Dez. 2018 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 25. Aug. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Karen Juanita Dickens als Geschäftsführer am 22. Juni 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 01. Okt. 2017 | 7 Seiten | AA | ||||||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. Dez. 2017 bis 30. Sept. 2017 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 25. Aug. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Sept. 2017 bis 31. Dez. 2017 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von REFINED MP LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED | Sekretär | Park Row LS1 5AB Leeds 1 England |
| 76579530001 | ||||||||||
| BANNISTER, William Bahlsen | Geschäftsführer | 36-38 Upper Marlborough Road AL1 3UU St. Albans Gladstone Place Hertfordshire England | United Kingdom | British | 252731900001 | |||||||||
| BIGGART, Thomas Mckenzie | Geschäftsführer | 36-38 Upper Marlborough Road AL1 3UU St. Albans Gladstone Place Hertfordshire England | Scotland | British | 215843640001 | |||||||||
| LANE, Simon Paul | Geschäftsführer | 36-38 Upper Marlborough Road AL1 3UU St. Albans Gladstone Place Hertfordshire England | England | British | 252862090001 | |||||||||
| BIRD, Edwin Arthur | Sekretär | Hulver Dane O'Coys Road CM23 2JP Bishops Stortford Hertfordshire | British | 55967160001 | ||||||||||
| CAMPBELL, James Oliver | Sekretär | 9 Marine Parade Gorleston NR31 6DU Great Yarmouth Norfolk | British | 29587680003 | ||||||||||
| DOWDING, Charles Michael | Sekretär | 1 Oakcroft Drive Framingham Earl NR14 7JQ Norwich Norfolk | British | 13193130001 | ||||||||||
| FRENCH, Walter | Sekretär | High Farm Bungalow High Farm PE9 3BY Southorpe Lincolnshire | British | 88005070001 | ||||||||||
| HATHAWAY, David | Sekretär | 36-38 Upper Marlborough Road AL1 3UU St. Albans Gladstone Place Hertfordshire England | British | 117227730001 | ||||||||||
| KEATING, Roderick Charles | Sekretär | Vincent House 4 Grove Lane CM16 4LH Epping Essex | British | 126363230002 | ||||||||||
| KEIDAN, Michael David Alan | Sekretär | 15 Crooked Usage Finchley N3 3HD London | Other | 1447490001 | ||||||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
| BACK, Steven John | Geschäftsführer | Vincent House 4 Grove Lane CM16 4LH Epping Essex | United Kingdom | British | 205661380001 | |||||||||
| CAMPBELL, James Oliver | Geschäftsführer | 9 Marine Parade Gorleston NR31 6DU Great Yarmouth Norfolk | United Kingdom | British | 29587680003 | |||||||||
| DICKENS, Karen Juanita, Dr | Geschäftsführer | Vincent House 4 Grove Lane CM16 4LH Epping Essex | United Kingdom | British | 124061360001 | |||||||||
| FRENCH, Walter | Geschäftsführer | High Farm Bungalow High Farm PE9 3BY Southorpe Lincolnshire | England | British | 88005070001 | |||||||||
| KING, Joseph | Geschäftsführer | Stratford House Stratford Crescent NR4 7SF Cringleford Norfolk | British | 3635770001 | ||||||||||
| PEACOCK, Graham Frederick | Geschäftsführer | Vincent House 4 Grove Lane CM16 4LH Epping Essex | United Kingdom | British | 5133310002 | |||||||||
| PEACOCK, Graham Frederick | Geschäftsführer | 5 Brook Street Little Dunmow CM6 3HU Dunmow Essex | British | 5133310001 | ||||||||||
| PEARS, David Alan | Geschäftsführer | 2 Old Brewery Mews Hampstead NW3 1PZ London | United Kingdom | British | 65200910001 | |||||||||
| PEARS, Mark Andrew | Geschäftsführer | 2 Old Brewery Mews Hampstead NW3 1PZ London | United Kingdom | British | 1447500008 | |||||||||
| PEARS, Trevor Steven, Sir | Geschäftsführer | 2 Old Brewery Mews Hampstead NW3 1PZ London | United Kingdom | British | 40036010005 | |||||||||
| ROBINSON, Melvin Frank | Geschäftsführer | 19 Aylmer Drive HA7 3EJ Stanmore Middlesex | England | British | 146452070001 | |||||||||
| SCOTT, Richard Antony Cargill | Geschäftsführer | Vincent House 4 Grove Lane CM16 4LH Epping Essex | England | British | 107002130001 | |||||||||
| SHARPE, Steven | Geschäftsführer | Kenwood House Kenwood Close NW3 7JL London | England | British | 146452160001 | |||||||||
| THOMPSON, Brian Lane | Geschäftsführer | Rock Hill House Rock Hill OX7 5BA Chipping Norton Oxfordshire | British | 56518620001 | ||||||||||
| TIMBERS, Graham Paul | Geschäftsführer | 36-38 Upper Marlborough Road AL1 3UU St. Albans Gladstone Place Hertfordshire England | England | British | 127888240001 | |||||||||
| TOBBELL, Susan Margaret | Geschäftsführer | Vincent House 4 Grove Lane CM16 4LH Epping Essex | United Kingdom | British | 17957620003 | |||||||||
| TOBBELL, Susan Margaret | Geschäftsführer | The Finch Inn Church Hill Finchingfield CM7 4NN Essex | United Kingdom | British | 17957620003 | |||||||||
| WPG REGISTRARS LIMITED | Geschäftsführer | Ground Floor 30 City Road EC1Y 2AB London | 106986280001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei REFINED MP LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Refined Estates Limited | 06. Apr. 2016 | 4 Grove Lane CM16 4LH Epping Vincent House Essex England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat REFINED MP LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Rental assignation | Erstellt am 11. Jan. 2005 Geliefert am 21. Jan. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and refined estates limited to the chargee | |
Kurze Angaben The benefit of all rents payable under the lease entered into between malthurst petroleum limited, malthurst fuels limited and malthurst UK limited dated 17 november 2003, together with such arrears (if any), including (without limitation) all vat (if any) payable on or in respect of the same. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 22. Dez. 2004 Geliefert am 23. Dez. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A standard security which was presented for registration in scotland on 19 january 2005 and | Erstellt am 15. Dez. 2004 Geliefert am 25. Jan. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All and whole subjects k/a milngavie service station, glasgow road, milngavie t/n DMB4074. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 15. Feb. 2002 Geliefert am 26. Feb. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The property known as 457 alfreton road nottingham. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 18. Juli 2001 Geliefert am 30. Juli 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Freehold property k/a little london service station london road spalding lincolnshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 22. Mai 2001 Geliefert am 31. Mai 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Leasehold property being land and buildings on the south side of norwich road gillingham. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 22. Mai 2001 Geliefert am 24. Mai 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee including all such monies as may fall due for payment under any agreements present and future all costs and expenses all sums due for any goods or services supplied by the chargee to the company, any interest payable to the chargee by the company, or sums which become due to the chargee in connection with any loan, and all sums which become due to the chargee in connection with an externally funded loan | |
Kurze Angaben Premises k/a widows cruse filling station gillinham nr beccles norfolk all fixtures and fittings not being personal chattels within the bill of sales act on the premises, all rental income present or future and whether payable now or in the future and the proceeds of sale. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. Mai 2001 Geliefert am 30. Mai 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A standard security which was presented for registration in scotland on the 21 june 2001 and | Erstellt am 18. Mai 2001 Geliefert am 26. Juni 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Milngavie service station, 42 glasgow road, milngavie. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 09. Feb. 1996 Geliefert am 28. Feb. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a petrol filling station at junction of A143/A146 roads gillingham near beccles norfolk together with all fixtures and fittings at any tim at the property the benefits of all rights licences and the goodwill of the company at the premises. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 09. Feb. 1996 Geliefert am 28. Feb. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben L/H property k/a petrol filling station junction A143/A146 roads gillingham nr. Beccles norfolk together with all fixtures fittings at the premises all rental income at any time all rights and claims against any third parties all goodwill full benefit of all contracts of the company. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge and assignment | Erstellt am 19. Jan. 1995 Geliefert am 23. Jan. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Petrol filling station development site situate at the junction of A143 and A146 gillingham norfolk all and singular the mortgagor's respective rights title and interest in and to each of the development documents and the development. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 03. Juni 1994 Geliefert am 10. Juni 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0