REFINED MP LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameREFINED MP LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02847780
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von REFINED MP LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich REFINED MP LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Gladstone Place
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Hertfordshire
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von REFINED MP LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    MALTHURST PETROLEUM LIMITED21. Juni 200021. Juni 2000
    GILLINGHAM SERVICE STATION LIMITED22. Okt. 199822. Okt. 1998
    HEARTS SERVICES LIMITED25. Aug. 199325. Aug. 1993

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von REFINED MP LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2018

    Welche sind die letzten Einreichungen für REFINED MP LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2018

    8 SeitenAA

    legacy

    2 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 30. Aug. 2019

    • Kapital: GBP 1
    4 SeitenSH19

    legacy

    2 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Reduction of capital redemption reserve 28/08/2019
    RES13
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Bestätigungserklärung erstellt am 25. Aug. 2019 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Ernennung von Thomas Mckenzie Biggart als Direktor am 11. März 2019

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Pinsent Masons Secretarial Limited als Sekretär am 07. März 2019

    2 SeitenAP04

    Beendigung der Bestellung von David Hathaway als Sekretär am 07. März 2019

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Graham Paul Timbers als Geschäftsführer am 12. Feb. 2019

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Simon Paul Lane als Direktor am 31. Dez. 2018

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr William Bahlsen Bannister als Direktor am 31. Dez. 2018

    2 SeitenAP01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Vincent House 4 Grove Lane Epping Essex CM16 4LH zum Gladstone Place 36-38 Upper Marlborough Road St. Albans Hertfordshire AL1 3UU am 02. Jan. 2019

    1 SeitenAD01

    Beendigung der Bestellung von Steven John Back als Geschäftsführer am 15. Okt. 2018

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Graham Paul Timbers als Direktor am 12. Okt. 2018

    2 SeitenAP01

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Sept. 2018 bis 31. Dez. 2018

    1 SeitenAA01

    Bestätigungserklärung erstellt am 25. Aug. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Karen Juanita Dickens als Geschäftsführer am 22. Juni 2018

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 01. Okt. 2017

    7 SeitenAA

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. Dez. 2017 bis 30. Sept. 2017

    1 SeitenAA01

    Bestätigungserklärung erstellt am 25. Aug. 2017 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Sept. 2017 bis 31. Dez. 2017

    1 SeitenAA01

    Wer sind die Geschäftsführer von REFINED MP LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    England
    Sekretär
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    England
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer02318923
    76579530001
    BANNISTER, William Bahlsen
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    Geschäftsführer
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    United KingdomBritish252731900001
    BIGGART, Thomas Mckenzie
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    Geschäftsführer
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    ScotlandBritish215843640001
    LANE, Simon Paul
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    Geschäftsführer
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish252862090001
    BIRD, Edwin Arthur
    Hulver
    Dane O'Coys Road
    CM23 2JP Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Sekretär
    Hulver
    Dane O'Coys Road
    CM23 2JP Bishops Stortford
    Hertfordshire
    British55967160001
    CAMPBELL, James Oliver
    9 Marine Parade
    Gorleston
    NR31 6DU Great Yarmouth
    Norfolk
    Sekretär
    9 Marine Parade
    Gorleston
    NR31 6DU Great Yarmouth
    Norfolk
    British29587680003
    DOWDING, Charles Michael
    1 Oakcroft Drive
    Framingham Earl
    NR14 7JQ Norwich
    Norfolk
    Sekretär
    1 Oakcroft Drive
    Framingham Earl
    NR14 7JQ Norwich
    Norfolk
    British13193130001
    FRENCH, Walter
    High Farm Bungalow
    High Farm
    PE9 3BY Southorpe
    Lincolnshire
    Sekretär
    High Farm Bungalow
    High Farm
    PE9 3BY Southorpe
    Lincolnshire
    British88005070001
    HATHAWAY, David
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    Sekretär
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    British117227730001
    KEATING, Roderick Charles
    Vincent House
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Essex
    Sekretär
    Vincent House
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Essex
    British126363230002
    KEIDAN, Michael David Alan
    15 Crooked Usage
    Finchley
    N3 3HD London
    Sekretär
    15 Crooked Usage
    Finchley
    N3 3HD London
    Other1447490001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BACK, Steven John
    Vincent House
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Essex
    Geschäftsführer
    Vincent House
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Essex
    United KingdomBritish205661380001
    CAMPBELL, James Oliver
    9 Marine Parade
    Gorleston
    NR31 6DU Great Yarmouth
    Norfolk
    Geschäftsführer
    9 Marine Parade
    Gorleston
    NR31 6DU Great Yarmouth
    Norfolk
    United KingdomBritish29587680003
    DICKENS, Karen Juanita, Dr
    Vincent House
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Essex
    Geschäftsführer
    Vincent House
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Essex
    United KingdomBritish124061360001
    FRENCH, Walter
    High Farm Bungalow
    High Farm
    PE9 3BY Southorpe
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    High Farm Bungalow
    High Farm
    PE9 3BY Southorpe
    Lincolnshire
    EnglandBritish88005070001
    KING, Joseph
    Stratford House
    Stratford Crescent
    NR4 7SF Cringleford
    Norfolk
    Geschäftsführer
    Stratford House
    Stratford Crescent
    NR4 7SF Cringleford
    Norfolk
    British3635770001
    PEACOCK, Graham Frederick
    Vincent House
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Essex
    Geschäftsführer
    Vincent House
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Essex
    United KingdomBritish5133310002
    PEACOCK, Graham Frederick
    5 Brook Street
    Little Dunmow
    CM6 3HU Dunmow
    Essex
    Geschäftsführer
    5 Brook Street
    Little Dunmow
    CM6 3HU Dunmow
    Essex
    British5133310001
    PEARS, David Alan
    2 Old Brewery Mews
    Hampstead
    NW3 1PZ London
    Geschäftsführer
    2 Old Brewery Mews
    Hampstead
    NW3 1PZ London
    United KingdomBritish65200910001
    PEARS, Mark Andrew
    2 Old Brewery Mews
    Hampstead
    NW3 1PZ London
    Geschäftsführer
    2 Old Brewery Mews
    Hampstead
    NW3 1PZ London
    United KingdomBritish1447500008
    PEARS, Trevor Steven, Sir
    2 Old Brewery Mews
    Hampstead
    NW3 1PZ London
    Geschäftsführer
    2 Old Brewery Mews
    Hampstead
    NW3 1PZ London
    United KingdomBritish40036010005
    ROBINSON, Melvin Frank
    19 Aylmer Drive
    HA7 3EJ Stanmore
    Middlesex
    Geschäftsführer
    19 Aylmer Drive
    HA7 3EJ Stanmore
    Middlesex
    EnglandBritish146452070001
    SCOTT, Richard Antony Cargill
    Vincent House
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Essex
    Geschäftsführer
    Vincent House
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Essex
    EnglandBritish107002130001
    SHARPE, Steven
    Kenwood House
    Kenwood Close
    NW3 7JL London
    Geschäftsführer
    Kenwood House
    Kenwood Close
    NW3 7JL London
    EnglandBritish146452160001
    THOMPSON, Brian Lane
    Rock Hill House Rock Hill
    OX7 5BA Chipping Norton
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Rock Hill House Rock Hill
    OX7 5BA Chipping Norton
    Oxfordshire
    British56518620001
    TIMBERS, Graham Paul
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    Geschäftsführer
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish127888240001
    TOBBELL, Susan Margaret
    Vincent House
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Essex
    Geschäftsführer
    Vincent House
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Essex
    United KingdomBritish17957620003
    TOBBELL, Susan Margaret
    The Finch Inn Church Hill
    Finchingfield
    CM7 4NN Essex
    Geschäftsführer
    The Finch Inn Church Hill
    Finchingfield
    CM7 4NN Essex
    United KingdomBritish17957620003
    WPG REGISTRARS LIMITED
    Ground Floor
    30 City Road
    EC1Y 2AB London
    Geschäftsführer
    Ground Floor
    30 City Road
    EC1Y 2AB London
    106986280001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei REFINED MP LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Refined Estates Limited
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    England
    06. Apr. 2016
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    England
    Nein
    RechtsformPrivate Limited Company
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortEngland And Wales
    Registrierungsnummer04193995
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.

    Hat REFINED MP LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Rental assignation
    Erstellt am 11. Jan. 2005
    Geliefert am 21. Jan. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and refined estates limited to the chargee
    Kurze Angaben
    The benefit of all rents payable under the lease entered into between malthurst petroleum limited, malthurst fuels limited and malthurst UK limited dated 17 november 2003, together with such arrears (if any), including (without limitation) all vat (if any) payable on or in respect of the same. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 21. Jan. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Nov. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 22. Dez. 2004
    Geliefert am 23. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Banking Corporation PLC
    Transaktionen
    • 23. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Nov. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 19 january 2005 and
    Erstellt am 15. Dez. 2004
    Geliefert am 25. Jan. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All and whole subjects k/a milngavie service station, glasgow road, milngavie t/n DMB4074.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 25. Jan. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Nov. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 15. Feb. 2002
    Geliefert am 26. Feb. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property known as 457 alfreton road nottingham.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Feb. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Nov. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 18. Juli 2001
    Geliefert am 30. Juli 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Freehold property k/a little london service station london road spalding lincolnshire.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Juli 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Mai 2001
    Geliefert am 31. Mai 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Leasehold property being land and buildings on the south side of norwich road gillingham.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 31. Mai 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Nov. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Mai 2001
    Geliefert am 24. Mai 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee including all such monies as may fall due for payment under any agreements present and future all costs and expenses all sums due for any goods or services supplied by the chargee to the company, any interest payable to the chargee by the company, or sums which become due to the chargee in connection with any loan, and all sums which become due to the chargee in connection with an externally funded loan
    Kurze Angaben
    Premises k/a widows cruse filling station gillinham nr beccles norfolk all fixtures and fittings not being personal chattels within the bill of sales act on the premises, all rental income present or future and whether payable now or in the future and the proceeds of sale. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bp Oil UK Limited
    Transaktionen
    • 24. Mai 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Nov. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 21. Mai 2001
    Geliefert am 30. Mai 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Mai 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 21 june 2001 and
    Erstellt am 18. Mai 2001
    Geliefert am 26. Juni 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Milngavie service station, 42 glasgow road, milngavie.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Juni 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Feb. 1996
    Geliefert am 28. Feb. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a petrol filling station at junction of A143/A146 roads gillingham near beccles norfolk together with all fixtures and fittings at any tim at the property the benefits of all rights licences and the goodwill of the company at the premises.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Feb. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Juni 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Feb. 1996
    Geliefert am 28. Feb. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    L/H property k/a petrol filling station junction A143/A146 roads gillingham nr. Beccles norfolk together with all fixtures fittings at the premises all rental income at any time all rights and claims against any third parties all goodwill full benefit of all contracts of the company. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Mobil Oil Company Limited
    Transaktionen
    • 28. Feb. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Juni 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge and assignment
    Erstellt am 19. Jan. 1995
    Geliefert am 23. Jan. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Petrol filling station development site situate at the junction of A143 and A146 gillingham norfolk all and singular the mortgagor's respective rights title and interest in and to each of the development documents and the development. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Mobil Oil Company Limited
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Jan. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. März 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 03. Juni 1994
    Geliefert am 10. Juni 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Juni 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Juni 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0